Actos BORME de Remagro Sa
24 de Julio de 2019Reelecciones. Adm. Unico: FERNANDEZ BECARES JUSTO. Datos registrales. T 1221, L 1221, F 58, S 8, H PO 7155, I/A 34(16.07.19).
26 de Septiembre de 2018Nombramientos. Apoderado: ESTRADA BRIZUELA ARLETYS. Datos registrales. T 1221, L 1221, F 58, S 8, H PO 7155, I/A 33(20.09.18).
19 de Septiembre de 2012Reelecciones. Auditor: PLADE CONSULTORES SL. Datos registrales. T 1221, L 1221, F 57, S 8, H PO 7155, I/A 32 ( 6.09.12).
03 de Septiembre de 2012Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: FERNANDEZ BECARES JUSTO;MEIS CACABELOS MANUEL;BARRIENTOS FERNANDEZBENITO. Nombramientos. Adm. Unico: FERNANDEZ BECARES JUSTO. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo deAdministraci贸n: Administradores solidarios a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 1221, L 1221, F 57, S 8, H PO 7155, I/A 31(23.08.12).
27 de Julio de 2012Nombramientos. Apoderado: DIESTE MOS MANUEL. Datos registrales. T 1221, L 1221, F 57, S 8, H PO 7155, I/A 30 (16.07.12).
15 de Febrero de 2012Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ MEIS MIGUEL. Datos registrales. T 1221, L 1221, F 56, S 8, H PO 7155, I/A 29 (3.02.12).
27 de Enero de 2012Reelecciones. Auditor: PLADE CONSULTORES SL. Datos registrales. T 1221, L 1221, F 56, S 8, H PO 7155, I/A 28 (16.01.12).
08 de Septiembre de 2011Nombramientos. Auditor: PLADE CONSULTORES SL. Datos registrales. T 1221, L 1221, F 56, S 8, H PO 7155, I/A 26 (29.08.11).
Nombramientos. Auditor: PLADE CONSULTORES SL. Datos registrales. T 1221, L 1221, F 56, S 8, H PO 7155, I/A 27 (29.08.11).
31 de Enero de 2011Reelecciones. Adm. Solid.: FERNANDEZ BECARES JUSTO;MEIS CACABELOS MANUEL;BARRIENTOS FERNANDEZ BENITO.Datos registrales. T 1221, L 1221, F 55, S 8, H PO 7155, I/A 25 (20.01.11).
26 de Enero de 2011Reelecciones. Aud.C.Con.: PLADE CONSULTORES SL. Datos registrales. T 1221, L 1221, F 55, S 8, H PO 7155, I/A 24(17.01.11).
25 de Enero de 2011Fe de erratas: El nombramiento de auditor para los ejercicios 2006 a 2008 es para las cuentas anuales consolidadas y no el que porerror se hizo constar. Datos registrales. T 1221, L 1221, F 54, S 8, H PO 7155, I/A 20 (13.05.09).
11 de Noviembre de 2009Revocaciones. Apo.Sol.: CASTRO ABILLEIRA SANTIAGO;CHAVES PRIETO JOSE CARLOS. Datos registrales. T 1221, L 1221, F55, S 8, H PO 7155, I/A 23 (26.10.09).
27 de Mayo de 2009Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 1.924.384,00 Euros. Desembolsado: 1.924.384,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.906.384,00 Euros.Resultante Desembolsado: 4.906.384,00 Euros. Datos registrales. T 1221, L 1221, F 55, S 8, H PO 7155, I/A 22 (15.05.09).
26 de Mayo de 2009Nombramientos. Auditor: I.C.M. IBERICA SL. Datos registrales. T 1221, L 1221, F 54, S 8, H PO 7155, I/A 14 (13.05.09).
Nombramientos. Auditor: PLADE CONSULTORES SL. Datos registrales. T 1221, L 1221, F 54, S 8, H PO 7155, I/A 15 (13.05.09).
Nombramientos. Auditor: PLADE CONSULTORES SL. Datos registrales. T 1221, L 1221, F 54, S 8, H PO 7155, I/A 16 (13.05.09).
Nombramientos. Auditor: PLADE CONSULTORES SL. Datos registrales. T 1221, L 1221, F 54, S 8, H PO 7155, I/A 17 (13.05.09).
Nombramientos. Auditor: PLADE CONSULTORES SL. Datos registrales. T 1221, L 1221, F 54, S 8, H PO 7155, I/A 18 (13.05.09).
Nombramientos. Auditor: PLADE CONSULTORES SL. Datos registrales. T 1221, L 1221, F 54, S 8, H PO 7155, I/A 19 (13.05.09).
Nombramientos. Auditor: PLADE CONSULTORES SL. Datos registrales. T 1221, L 1221, F 54, S 8, H PO 7155, I/A 20 (13.05.09).
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 1.228.500,00 Euros. Desembolsado: 1.228.500,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.982.000,00 Euros.Resultante Desembolsado: 2.982.000,00 Euros. Datos registrales. T 1221, L 1221, F 55, S 8, H PO 7155, I/A 21 (14.05.09).