Actos BORME de Remolcadores De Aviles Sa
28 de Agosto de 2023Reelecciones. Adm. Unico: REMOLQUES Y SERVICIOS MARITIMOS SL. Datos registrales. T 1648 , F 142, S 8, H AS 9903, I/A 27(18.08.23).
17 de Abril de 2018Revocaciones. Apo.Manc.: ALONSO GARCIA ROMAN. Apo.Sol.: ALONSO GARCIA ROMAN. Apo.Manc.: GOMEZ BOLLOEDUARDO. Apo.Sol.: GOMEZ BOLLO EDUARDO. Nombramientos. Apo.Sol.: RIBED SANCHEZ LUIS;GARCIA GORBEÑAGABRIEL;GOMEZ BOLLO EDUARDO. Apo.Manc.: RIBED SANCHEZ LUIS;GARCIA GORBEÑA GABRIEL;GOMEZ BOLLOEDUARDO. Apo.Sol.: ALTADILL LLORT FRANCES XAVIER;CASTILLA FREIXA MONTSERRAT;HERNANDEZ ANDRESESTHER;CAVERO CABALLERO YOLANDA. Datos registrales. T 1648 , F 139, S 8, H AS 9903, I/A 26 ( 9.04.18).
03 de Abril de 2018Reelecciones. Adm. Unico: REMOLQUES Y SERVICIOS MARITIMOS SL. Datos registrales. T 1648 , F 139, S 8, H AS 9903, I/A 25(22.03.18).
12 de Diciembre de 2017Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ SANCHEZ GEMMA MATILDE. Apo.Manc.: CHAO LOPEZ MARIA DEL MAR. Apo.Sol.: CHAOLOPEZ MARIA DEL MAR. Datos registrales. T 1648 , F 139, S 8, H AS 9903, I/A 24 ( 1.12.17).
17 de Noviembre de 2017Nombramientos. Apo.Sol.: DELGADO GIL ROBERTO;FARIZA REQUEJO JESUS;CAÑO CADAHIA MARIA;GALAN GARCIAPALOMA MARIA;AUSIN AJURIA JAVIER. Datos registrales. T 1648 , F 139, S 8, H AS 9903, I/A 23 ( 9.11.17).
18 de Julio de 2017Declaración de unipersonalidad. Socio único: REMOLQUES Y SERVICIOS MARITIMOS SL. Datos registrales. T 1648 , F 113, S8, H AS 9903, I/A 21 (11.07.17).
03 de Mayo de 2016Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 2. Domicilio.-. Cambio de domicilio social. PLAZA DE PEDRO MENENDEZ6 3º A (AVILES). Datos registrales. T 1648 , F 113, S 8, H AS 9903, I/A 20 (22.04.16).
26 de Junio de 2015Revocaciones. Apoderado: BRUGUE MEDARDO JUAN JOSE. Datos registrales. T 1648 , F 109, S 8, H AS 9903, I/A 17(16.06.15).
Nombramientos. Apo.Manc.: CHAO LOPEZ MARIA DEL MAR. Apo.Sol.: CHAO LOPEZ MARIA DEL MAR. Apo.Manc.: ALONSOGARCIA ROMAN. Apo.Sol.: ALONSO GARCIA ROMAN. Apo.Manc.: GOMEZ BOLLO EDUARDO. Apo.Sol.: GOMEZ BOLLOEDUARDO. Datos registrales. T 1648 , F 109, S 8, H AS 9903, I/A 18 (16.06.15).
Nombramientos. Apoderado: COTERA NAVA JUAN PABLO. Datos registrales. T 1648 , F 112, S 8, H AS 9903, I/A 19 (16.06.15).
06 de Febrero de 2015Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ SANCHEZ GEMMA MATILDE. Datos registrales. T 1648 , F 109, S 8, H AS 9903, I/A 16(28.01.15).
20 de Mayo de 2013Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: TRUEBA HERRANZ GUILLERMO. Nombramientos. Adm. Unico: REMOLQUES Y SERVICIOSMARITIMOS S.L. Datos registrales. T 1648 , F 74, S 8, H AS 9903, I/A 15 (10.05.13).
31 de Agosto de 2010Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 2. Domicilio.-. Cambio de domicilio social. C/ DEL MUELLE 10 2º A(AVILES). Datos registrales. T 1648 , F 74, S 8, H AS 9903, I/A 14 (17.08.10).
19 de Julio de 2010Reelecciones. Adm. Unico: TRUEBA HERRANZ GUILLERMO. Datos registrales. T 1648 , F 74, S 8, H AS 9903, I/A 13 ( 7.07.10).
27 de Mayo de 2010Revocaciones. Apoderado: DEL BARRIO ALVAREZ ANGEL CARLOS. Datos registrales. T 1648 , F 74, S 8, H AS 9903, I/A 12(17.05.10).
18 de Noviembre de 2009Revocaciones. Apoderado: FERNANDEZ IGLESIAS MARIA DOLORES. Datos registrales. T 1648 , F 74, S 8, H AS 9903, I/A 11 (4.11.09).