Buscador CIF Logo

Actos BORME Remolcadores Ferrolanos Sa

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Remolcadores Ferrolanos Sa

Actos BORME Remolcadores Ferrolanos Sa - A80352636

Tenemos registrados 22 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Remolcadores Ferrolanos Sa con CIF A80352636

🔙 Perfil de Remolcadores Ferrolanos Sa
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Remolcadores Ferrolanos Sa

31 de Octubre de 2023
Reelecciones. Representan: GARCIA GORBEÑA IÑIGO. Adm. Unico: REMOLQUES Y SERVICIOS MARITIMOS SL REYSER.Datos registrales. T 32814 , F 205, S 8, H M 62482, I/A 33 (24.10.23).

05 de Marzo de 2020
Nombramientos. Apoderado: VIVERO GARCIA-TUÑON MARIA ISABEL. Datos registrales. T 32814 , F 203, S 8, H M 62482, I/A 32(27.02.20).

04 de Marzo de 2020
Revocaciones. Apoderado: ZALVIDE TORRENTE MANUEL. Datos registrales. T 32814 , F 202, S 8, H M 62482, I/A 31 (26.02.20).

20 de Abril de 2018
Revocaciones. Apo.Man.Soli: ALONSO GARCIA ROMAN;GOMEZ BOLLO EDUARDO. Nombramientos. Apoderado: RIBEDSANCHEZ LUIS;GARCIA GORBEÑA GABRIEL;GOMEZ BOLLO EDUARDO;ALTADILL LLORT FRANCESC XAVIER;CASTILLAFREIXA MONTSERRAT;HERNANDEZ ANDRES ESTHER;CAVERO CABALLERO YOLANDA. Datos registrales. T 32814 , F 199, S8, H M 62482, I/A 30 (11.04.18).

10 de Abril de 2018
Reelecciones. Adm. Unico: REMOLQUES Y SERVICIOS MARITIMOS SL REYSER. Representan: GARCIA GORBEÑA IÑIGO.Datos registrales. T 32814 , F 199, S 8, H M 62482, I/A 29 ( 3.04.18).

20 de Diciembre de 2017
Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ SANCHEZ GEMMA MATILDE. Apo.Man.Soli: CHAO LOPEZ MARIA DEL MAR. Datosregistrales. T 32814 , F 198, S 8, H M 62482, I/A 28 (13.12.17).

08 de Noviembre de 2017
Cambio de domicilio social. C/ DOCTOR FLEMING 24, 3º B (MADRID). Datos registrales. T 32814 , F 198, S 8, H M 62482, I/A 26(30.10.17).

Nombramientos. Apoderado: DELGADO GIL ROBERTO;FARIZA REQUEJO JESUS;CAÑO CADAHIA MARIA;GALAN GARCIAPALOMA MARIA;AUSIN AJURIA JAVIER. Datos registrales. T 32814 , F 198, S 8, H M 62482, I/A 27 (30.10.17).

27 de Octubre de 2017
Ceses/Dimisiones. Representan: ESCUDERO ZAVALA PEDRO. Nombramientos. Representan: GARCIA GORBEÑA IÑIGO.Datos registrales. T 32814 , F 198, S 8, H M 62482, I/A 25 (19.10.17).

25 de Julio de 2017
Declaración de unipersonalidad. Socio único: REMOLQUES Y SERVICIOS MARITIMOS SL REYSER. Datos registrales. T 32814, F 197, S 8, H M 62482, I/A 24 (19.07.17).

30 de Abril de 2015
Otros conceptos: SUBSANADO EL PRIMER APELLIDO Y EL NUMERO DEL DNI DEL APODERADO DON MANUEL ZALDIVETORRENTE SIENDO EL CORRECTO DON MANUEL ZALVIDE TORRENTE Y EL DNI: 36.081.295-E. Datos registrales. T 3749 , F136, S 8, H M 62482, I/A 22-M (22.04.15).

14 de Abril de 2015
Revocaciones. Apoderado: FERNANDEZ PEINADO CARLOS;BRUGUE MEDARDO JUAN JOSE. Datos registrales. T 3749 , F135, S 8, H M 62482, I/A 21 ( 1.04.15).

Nombramientos. Apoderado: ZALDIVE TORRENTE MANUEL. Datos registrales. T 3749 , F 136, S 8, H M 62482, I/A 22 ( 1.04.15).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: CHAO LOPEZ MARIA DEL MAR;ALONSO GARCIA ROMAN;GOMEZ BOLLO EDUARDO. Datosregistrales. T 32814 , F 194, S 8, H M 62482, I/A 23 ( 1.04.15).

06 de Febrero de 2015
Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ SANCHEZ GEMMA MATILDE. Datos registrales. T 3749 , F 135, S 8, H M 62482, I/A 20(27.01.15).

12 de Julio de 2013
Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 2. Domicilio.-. Cambio de domicilio social. C/ ALCALA 65 (MADRID).Datos registrales. T 3749 , F 135, S 8, H M 62482, I/A 19 ( 4.07.13).

17 de Mayo de 2013
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: TRUEBA HERRANZ GUILLERMO. Nombramientos. Representan: ESCUDERO ZAVALA PEDRO.Adm. Unico: REMOLQUES Y SERVICIOS MARITIMOS SL REYSER. Datos registrales. T 3749 , F 134, S 8, H M 62482, I/A 18 (8.05.13).

16 de Noviembre de 2012
Otros conceptos: HA QUEDADO MODIFICADO EL ARTICULO 20 DE LOS ESTATUTOS E INTRODUCIDO UN NUEVO ARTICULO20 BIS EN LOS ESTATUTOS SOCIALES.- Datos registrales. T 3749 , F 134, S 8, H M 62482, I/A 17 ( 5.11.12).

19 de Julio de 2010
Reelecciones. Adm. Unico: TRUEBA HERRANZ GUILLERMO. Datos registrales. T 3749 , F 134, S 8, H M 62482, I/A 16 ( 7.07.10).

01 de Junio de 2010
Revocaciones. Apoderado: DEL BARRIO ALVAREZ ANGEL CARLOS. Datos registrales. T 3749 , F 134, S 8, H M 62482, I/A 15(20.05.10).

27 de Enero de 2010
Modificaciones estatutarias. AÑADIDO EL ARTICULO 4 BIS A LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 3749 , F 133, S8, H M 62482, I/A 14 (18.01.10).

19 de Noviembre de 2009
Revocaciones. Apoderado: FERNANDEZ IGLESIAS MARIA DOLORES. Datos registrales. T 3749 , F 133, S 8, H M 62482, I/A 13 (6.11.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información