Actos BORME de Remolques Y Servicios Maritimos Santander Sl
07 de Febrero de 2023Revocaciones. Apoderado: ALONSO GONZALEZ PABLO. Datos registrales. T 13478 , F 220, S 8, H M 218882, I/A 26 (31.01.23).
Nombramientos. Apoderado: MEDIAVILLA ARRIBAS ENRIQUE. Datos registrales. T 13478 , F 220, S 8, H M 218882, I/A 27(31.01.23).
30 de Marzo de 2020Revocaciones. Apoderado: ESCANDON DEL RIO JOSE MANUEL. Datos registrales. T 13478 , F 220, S 8, H M 218882, I/A 25(23.03.20).
25 de Abril de 2018Revocaciones. Apoderado: ALONSO GARCIA ROMAN;GOMEZ BOLLO EDUARDO. Nombramientos. Apo.Sol.: RIBED SANCHEZLUIS;GARCIA GORBEÑA GABRIEL;GOMEZ BOLLO EDUARDO;ALTADILL LLORT FRANCESC XAVIER;CASTILLA FREIXAMONTSERRAT;CAVERO CABALLERO YOLANDA;HERNANDEZ ANDRES ESTHER. Datos registrales. T 13478 , F 216, S 8, H M218882, I/A 24 (16.04.18).
20 de Diciembre de 2017Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ SANCHEZ GEMMA MATILDE;CHAO LOPEZ MARIA DEL MAR. Datos registrales. T 13478, F 216, S 8, H M 218882, I/A 23 (13.12.17).
27 de Noviembre de 2017Cambio de domicilio social. C/ DOCTOR FLEMING NUMERO 24, 3º B (MADRID). Datos registrales. T 13478 , F 216, S 8, H M218882, I/A 21 (16.11.17).
Nombramientos. Apo.Sol.: DELGADO GIL ROBERTO;FARIZA REQUEJO JESUS;CAÑO CADAHIA MARIA;GALAN GARCIAPALOMA MARIA;AUSIN AJURIA JAVIER. Datos registrales. T 13478 , F 216, S 8, H M 218882, I/A 22 (16.11.17).
27 de Octubre de 2017Ceses/Dimisiones. Representan: ESCUDERO ZAVALA PEDRO. Nombramientos. Representan: GARCIA GORBEÑA IÑIGO.Datos registrales. T 13478 , F 215, S 8, H M 218882, I/A 20 (19.10.17).
26 de Junio de 2015Revocaciones. Apoderado: BRUGUE MEDARDO JUAN JOSE. Datos registrales. T 13478 , F 194, S 8, H M 218882, I/A 16(19.06.15).
Nombramientos. Apoderado: CHAO LOPEZ MARIA DEL MAR;ALONSO GARCIA ROMAN;GOMEZ BOLLO EDUARDO. Datosregistrales. T 13478 , F 194, S 8, H M 218882, I/A 17 (19.06.15).
Nombramientos. Apoderado: ESCANDON DEL RIO JOSE MANUEL. Datos registrales. T 13478 , F 197, S 8, H M 218882, I/A 18(19.06.15).
Nombramientos. Apoderado: ALONSO GONZALEZ PABLO. Datos registrales. T 13478 , F 199, S 8, H M 218882, I/A 19(19.06.15).
10 de Febrero de 2015Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ SANCHEZ GEMMA MATILDE. Datos registrales. T 13478 , F 193, S 8, H M 218882, I/A15 ( 2.02.15).
11 de Diciembre de 2013Revocaciones. Apoderado: TRUEBA HERRANZ GUILLERMO. Datos registrales. T 13478 , F 193, S 8, H M 218882, I/A 14 (2.12.13).
15 de Julio de 2013Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 4º. Domicilio.-. Cambio de domicilio social. C/ DE ALCALA 65 (MADRID).Datos registrales. T 13478 , F 193, S 8, H M 218882, I/A 13 ( 5.07.13).
17 de Mayo de 2013Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: TRUEBA HERRANZ GUILLERMO. Nombramientos. Representan: ESCUDERO ZAVALA PEDRO.Adm. Unico: REMOLQUES Y SERVICIOS MARITIMOS SL REYSER. Datos registrales. T 13478 , F 193, S 8, H M 218882, I/A 12 (8.05.13).
31 de Mayo de 2010Revocaciones. Apoderado: DEL BARRIO ALVAREZ ANGEL CARLOS. Datos registrales. T 13478 , F 193, S 8, H M 218882, I/A 11(19.05.10).
19 de Noviembre de 2009Revocaciones. Apoderado: FERNANDEZ IGLESIAS MARIA DOLORES. Datos registrales. T 13478 , F 40, S 8, H M 218882, I/A 10( 6.11.09).