Actos BORME de Renault Retail Group Levante Sa
22 de Diciembre de 2023Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 7398, L 4699, F 93, S 8, H V 12045, I/A 242 (15.12.23).
25 de Septiembre de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: RAMOS LOPEZ DANIEL. Datos registrales. T 7398, L 4699, F 93, S 8, H V 12045, I/A 241 (18.09.23).
20 de Julio de 2023Nombramientos. Apo.Man.Soli: IBAÑEZ ALBAJAR ENRIQUE. Datos registrales. T 7398, L 4699, F 92, S 8, H V 12045, I/A 240(13.07.23).
18 de Mayo de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: RAMOS LOPEZ CESAR JAVIER. Datos registrales. T 7398, L 4699, F 91, S 8, H V 12045, I/A 237(10.05.23).
12 de Mayo de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: HERRERA MARQUEZ MARIA TERESA. Datos registrales. T 7398, L 4699, F 91, S 8, H V 12045, I/A236 ( 4.05.23).
16 de Febrero de 2023Revocaciones. Apoderado: FELIX BRAZ JOANA ISABEL. Datos registrales. T 7398, L 4699, F 91, S 8, H V 12045, I/A 235 (9.02.23).
07 de Febrero de 2023Revocaciones. Apoderado: LEROYER PAULINE RACHEL ALICE. Datos registrales. T 7398, L 4699, F 90, S 8, H V 12045, I/A 234(31.01.23).
03 de Enero de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: INGAUD-JAUBERT CLAUDE JEAN. Presidente: INGAUD-JAUBERT CLAUDE JEAN.Nombramientos. Consejero: ORTIGOSA JIMENEZ CESAR. Presidente: ORTIGOSA JIMENEZ CESAR. Con.Delegado: ORTIGOSAJIMENEZ CESAR. Datos registrales. T 7398, L 4699, F 90, S 8, H V 12045, I/A 233 (27.12.22).
14 de Diciembre de 2022Nombramientos. Apoderado: FONTANA JORDAN DE URRIES JORGE. Datos registrales. T 7398, L 4699, F 90, S 8, H V 12045,I/A 232 ( 5.12.22).
01 de Diciembre de 2022Revocaciones. Apo.Sol.: NUÑEZ PORTELA JOSE LUIS. Datos registrales. T 7398, L 4699, F 89, S 8, H V 12045, I/A 231(24.11.22).
18 de Octubre de 2022Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: INGAUD-JAUBERT CLAUDE JEAN. Reelecciones. Consejero: INGAUD-JAUBERT CLAUDEJEAN. Presidente: INGAUD-JAUBERT CLAUDE JEAN. Datos registrales. T 7398, L 4699, F 89, S 8, H V 12045, I/A 230 (10.10.22).
23 de Septiembre de 2022Revocaciones. Apo.Sol.: CLAVERO FERNANDEZ DE CORDOVA ISABEL. Apoderado: MARTINEZ MOLINERO JESUS;ALVAREZGARCIA ALEJANDRO JAVIER;GARCIA CARDONA JULIO MIGUEL;GASCO VILLANUEVA JORGE DAVID. Datos registrales. T7398, L 4699, F 88, S 8, H V 12045, I/A 228 (16.09.22).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: MONTEJO CORDON FRANCISCO. Datos registrales. T 7398, L 4699, F 88, S 8, H V 12045, I/A229 (16.09.22).
19 de Julio de 2022Nombramientos. Apoderado: ROVIRA VILCHES GUILLERMO. Datos registrales. T 7398, L 4699, F 88, S 8, H V 12045, I/A 227(12.07.22).
09 de Junio de 2022Nombramientos. Apoderado: FELIX BRAZ JOANA ISABEL. Datos registrales. T 7398, L 4699, F 88, S 8, H V 12045, I/A 226 (2.06.22).
21 de Octubre de 2021Revocaciones. Apoderado: ALAVA GOMEZ CARLOS JAVIER. Datos registrales. T 7398, L 4699, F 87, S 8, H V 12045, I/A 225(14.10.21).
10 de Mayo de 2021Cancelaciones de oficio de nombramientos. Consejero: RODRIGUEZ GALAN DE CONTES D'ESGRANGES MARIA LUISA. Datosregistrales. T 7398, L 4699, F 66, S 8, H V 12045, I/A 159 A (28.04.21).
Ceses/Dimisiones. Consejero: MESIC JEAN PIERRE. Revocaciones. Apoderado: REQUENA CAMPILLO JUAN ANTONIO.Nombramientos. Consejero: GUIGUES SEBASTIEN MARIE PASCAL. Datos registrales. T 7398, L 4699, F 87, S 8, H V 12045, I/A224 (30.04.21).
25 de Febrero de 2021Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 7398, L 4699, F 87, S 8, H V 12045, I/A 223 (18.02.21).
12 de Febrero de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: CURRAN LEONARD STEPHEN. Presidente: CURRAN LEONARD STEPHEN. Vicesecret.: BLASCOLOBO MARTA. Nombramientos. Consejero: LEROYER PAULINE RACHEL ALICE. Presidente: INGAUD-JAUBERT CLAUDE JEAN.Vicesecret.: LEROYER PAULINE RACHEL ALICE. Datos registrales. T 7398, L 4699, F 84, S 8, H V 12045, I/A 218 ( 5.02.21).
Ceses/Dimisiones. Vicesecret.: LEROYER PAULINE RACHEL ALICE. Nombramientos. Vicesecret.: BLASCO LOBO MARTA.Datos registrales. T 7398, L 4699, F 84, S 8, H V 12045, I/A 219 ( 5.02.21).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GONZALEZ LOPEZ LAURA. Datos registrales. T 7398, L 4699, F 85, S 8, H V 12045, I/A 220 (5.02.21).
Ceses/Dimisiones. Secretario: REQUENA CAMPILLO JUAN ANTONIO. Nombramientos. Secretario: MENOR GOMEZ CARLOS.Apoderado: MENOR GOMEZ CARLOS. Datos registrales. T 7398, L 4699, F 85, S 8, H V 12045, I/A 221 ( 5.02.21).
Ceses/Dimisiones. Consejero: LEROYER PAULINE RACHEL ALICE. Nombramientos. Consejero: MENOR GOMEZ CARLOS.Datos registrales. T 7398, L 4699, F 86, S 8, H V 12045, I/A 222 ( 5.02.21).
25 de Agosto de 2020Revocaciones. Apoderado: HERNANDEZ RUBIO ANTONIO. Datos registrales. T 7398, L 4699, F 83, S 8, H V 12045, I/A 216(18.08.20).
Revocaciones. Apoderado: RODRIGUEZ GALAN DE CONTES D'ESGRANGES MARIA LUISA;RODRIGUEZ GALAN DE CONTESD'ESGRANGES MARIA LUISA;RODRIGUEZ GALAN DE CONTES D'ESGRANGES MARIA LUISA. Datos registrales. T 7398, L4699, F 84, S 8, H V 12045, I/A 217 (18.08.20).
11 de Febrero de 2020Revocaciones. Apo.Man.Soli: MARTIN PRADOS MANUEL. Datos registrales. T 7398, L 4699, F 83, S 8, H V 12045, I/A 215 (4.02.20).
18 de Diciembre de 2019Revocaciones. Apoderado: MARTIN PRADOS MANUEL. Datos registrales. T 7398, L 4699, F 83, S 8, H V 12045, I/A 214(11.12.19).
06 de Noviembre de 2019Nombramientos. Apo.Man.Soli: QUEIPO VAQUERO SECUNDINO. Otros conceptos: El ejercicio de las facultades mancomunadaslo hará DON SECUNDINO QUEIPO VAQUERO con cualquier otro apoderado de la sociedad en los mismos términos. Datosregistrales. T 7398, L 4699, F 82, S 8, H V 12045, I/A 212 (29.10.19).
Nombramientos. Apo.Sol.: NUÑEZ PORTELA JOSE LUIS. Datos registrales. T 7398, L 4699, F 82, S 8, H V 12045, I/A 213(29.10.19).
08 de Octubre de 2019Revocaciones. Apoderado: SANDIN BARCO JUAN CARLOS. Datos registrales. T 7398, L 4699, F 82, S 8, H V 12045, I/A 211 (1.10.19).
14 de Agosto de 2019Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 7398, L 4699, F 82, S 8, H V 12045, I/A 210 ( 7.08.19).
13 de Agosto de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: SEGAL IVAN ANTOINE ALEXANDRE. Nombramientos. Consejero: MESIC JEAN PIERRE. Datosregistrales. T 7398, L 4699, F 81, S 8, H V 12045, I/A 209 ( 6.08.19).
05 de Agosto de 2019Revocaciones. Apo.Man.Soli: VALVERDE CASERO FRANCISCO. Apo.Sol.: SANCHEZ MARINA LAMBERTO. Apo.Man.Soli:SANCHEZ MARINA LAMBERTO. Apoderado: MARTINEZ MOLINERO JESUS;GASCO VILLANUEVA JORGE DAVID. Apo.Manc.:GASCO VILLANUEVA JORGE DAVID. Datos registrales. T 7398, L 4699, F 81, S 8, H V 12045, I/A 207 (29.07.19).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARTIN PRADOS MANUEL. Datos registrales. T 7398, L 4699, F 81, S 8, H V 12045, I/A 208(29.07.19).
04 de Junio de 2019Nombramientos. Apoderado: ALVAREZ GARCIA ALEJANDRO JAVIER. Datos registrales. T 7398, L 4699, F 79, S 8, H V 12045,I/A 202 (28.05.19).
Revocaciones. Apoderado: RODRIGUEZ MODENES LUIS;GONZALEZ TOLEDO CRISTOBAL. Apo.Sol.: MATEOS URRACAVICENTE BERNARDO;HERRERA MARQUEZ MARIA TERESA;MORENO GARCIA MARIA HENAR. Apo.Man.Soli: TOLOSA MORTEJOSE GREGORIO. Apoderado: PERTIERRA ASENSIO MARIA. Datos registrales. T 7398, L 4699, F 79, S 8, H V 12045, I/A 203(28.05.19).
Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ MOLINERO JESUS. Datos registrales. T 7398, L 4699, F 80, S 8, H V 12045, I/A 204(28.05.19).
Nombramientos. Apoderado: GASCO VILLANUEVA JORGE DAVID. Datos registrales. T 7398, L 4699, F 80, S 8, H V 12045, I/A205 (28.05.19).
Nombramientos. Apoderado: GARCIA CARDONA JULIO MIGUEL. Datos registrales. T 7398, L 4699, F 80, S 8, H V 12045, I/A 206(28.05.19).
02 de Noviembre de 2018Nombramientos. Apo.Man.Soli: SANCHEZ MARINA LAMBERTO. Datos registrales. T 7398, L 4699, F 78, S 8, H V 12045, I/A 199
Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ LOPEZ RICARDO. Datos registrales. T 7398, L 4699, F 78, S 8, H V 12045, I/A 200(25.10.18).
Nombramientos. Apoderado: TOLOSA MORTE JOSE GREGORIO. Datos registrales. T 7398, L 4699, F 78, S 8, H V 12045, I/A201 (25.10.18).
21 de Agosto de 2018Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 7398, L 4699, F 77, S 8, H V 12045, I/A 198 (13.08.18).
16 de Agosto de 2018Modificaciones estatutarias. ARTICULO 21º.- La sociedad será regida y administrada por un órgano de administración que podráser confiado a un Administrador Unico, o a dos Administradores que actuarán de forma solidaria o mancomunada según la JuntaGeneral determine, o a un Consejo de Administración integrado por un mínimo de Se adiciona el articulo 25º bis en relacion al que elcargo de administrador es remunerado en la forma que por extenso consta en dicho articulo. . Datos registrales. T 7398, L 4699, F77, S 8, H V 12045, I/A 197 ( 8.08.18).
07 de Mayo de 2018Revocaciones. Apoderado: GUIJARRO GUIJARRO SEVERIANO. Apo.Manc.: GUIJARRO GUIJARRO SEVERIANO. Apoderado:MUÑOZ GUILLEN VANESA RAQUEL. Datos registrales. T 7398, L 4699, F 771, S 8, H V 12045, I/A 194 (26.04.18).
Nombramientos. Apo.Manc.: GARCIA TIZON MARTA CUENCA. Datos registrales. T 7398, L 4699, F 77, S 8, H V 12045, I/A 196(26.04.18).
18 de Abril de 2018Ceses/Dimisiones. Secretario: RODRIGUEZ GALAN DE CONTES D'ESGRANGES MARIA LUISA. Nombramientos. Secretario:REQUENA CAMPILLO JUAN ANTONIO. Apoderado: REQUENA CAMPILLO JUAN ANTONIO. Datos registrales. T 7398, L 4699, F75, S 8, H V 12045, I/A 194 (11.04.18).
20 de Marzo de 2018Nombramientos. Vicesecret.: BLASCO LOBO MARTA. Modificaciones estatutarias. El Consejo de Administración elegirá de entresus miembros un Presidente. Igualmente designará un Secretario y un Vicesecretario que podrán ser o no Consejeros. En los casos deausencia o enfermedad del Presidente y/o del Secretario estos serán, en cada caso, sustituidos por el Consejero de más. Datosregistrales. T 7398, L 4699, F 74, S 8, H V 12045, I/A 193 (13.03.18).
06 de Marzo de 2018Nombramientos. Apoderado: LEROYER PAULINE RACHEL ALICE. Datos registrales. T 7398, L 4699, F 73, S 8, H V 12045, I/A190 (27.02.18).
Nombramientos. Apoderado: ANTONA RODRIGUEZ ANA. Datos registrales. T 7398, L 4699, F 74, S 8, H V 12045, I/A 191(27.02.18).
Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ ESQUIROZ BEATRIZ. Datos registrales. T 7398, L 4699, F 74, S 8, H V 12045, I/A 192(27.02.18).
08 de Febrero de 2018Revocaciones. Apo.Sol.: RODRIGUEZ MARTIN FLORISELA MARIA. Datos registrales. T 7398, L 4699, F 73, S 8, H V 12045, I/A187 ( 1.02.18).
Nombramientos. Apoderado: ALAVA GOMEZ CARLOS JAVIER. Datos registrales. T 7398, L 4699, F 73, S 8, H V 12045, I/A 188 (1.02.18).
Nombramientos. Apoderado: SANDIN BARCO JUAN CARLOS. Datos registrales. T 7398, L 4699, F 73, S 8, H V 12045, I/A 189 (1.02.18).
23 de Noviembre de 2017Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 7398, L 4699, F 72, S 8, H V 12045, I/A 186 (16.11.17).
27 de Septiembre de 2017Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ GALAN DE CONTES D'ESGRANGES MARIA LUISA. Datos registrales. T 7398, L4699, F 72, S 8, H V 12045, I/A 184 (20.09.17).
Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ GALAN DE CONTES D'ESGRANGES MARIA LUISA. Datos registrales. T 7398, L4699, F 72, S 8, H V 12045, I/A 185 (20.09.17).
16 de Mayo de 2017Nombramientos. Apoderado: PERTIERRA ASENSIO MARIA. Datos registrales. T 7398, L 4699, F 71, S 8, H V 12045, I/A 183 (8.05.17).
19 de Diciembre de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: BASSET ERIC. Con.Delegado: BASSET ERIC. Nombramientos. Consejero: INGAUD-JAUBERTCLAUDE JEAN. Con.Delegado: INGAUD-JAUBERT CLAUDE JEAN. Datos registrales. T 7398, L 4699, F 71, S 8, H V 12045, I/A182 (12.12.16).
03 de Agosto de 2016Nombramientos. Apo.Man.Soli: KAPUSTA MALWINA MONIKA. Datos registrales. T 7398, L 4699, F 71, S 8, H V 12045, I/A 181(27.07.16).
27 de Mayo de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: YUJI GONDO RICARDO. Nombramientos. Consejero: SEGAL IVAN ANTOINE ALEXANDRE.Datos registrales. T 7398, L 4699, F 70, S 8, H V 12045, I/A 178 (20.05.16).
Revocaciones. Apoderado: JOVER MOLERO JOAQUIN FERNANDO. Datos registrales. T 7398, L 4699, F 70, S 8, H V 12045, I/A179 (20.05.16).
Nombramientos. Apoderado: MARTIN PRADOS MANUEL. Datos registrales. T 7398, L 4699, F 70, S 8, H V 12045, I/A 180(20.05.16).
13 de Mayo de 2016Nombramientos. Apoderado: LOSA RANZ FELIX. Datos registrales. T 7398, L 4699, F 70, S 8, H V 12045, I/A 176 ( 6.05.16).
Nombramientos. Apoderado: HERNANDEZ RUBIO ANTONIO. Datos registrales. T 7398, L 4699, F 70, S 8, H V 12045, I/A 177 (6.05.16).
03 de Mayo de 2016Nombramientos. Apo.Sol.: HERRERA MARQUEZ MARIA TERESA;RODRIGUEZ MARTIN FLORISELA MARIA;MORENO GARCIAMARIA HENAR. Datos registrales. T 7398, L 4699, F 69, S 8, H V 12045, I/A 173 (25.04.16).
Revocaciones. Apoderado: CIVERA QUILES MARIA DESAMPARADOS. Datos registrales. T 7398, L 4699, F 69, S 8, H V 12045,I/A 174 (25.04.16).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: TOLOSA MORTE JOSE GREGORIO. Datos registrales. T 7398, L 4699, F 69, S 8, H V 12045, I/A175 (25.04.16).
18 de Agosto de 2015Revocaciones. Apoderado: RICO DE LAMO FERNANDO JAVIER. Datos registrales. T 7398, L 4699, F 69, S 8, H V 12045, I/A 172(11.08.15).
11 de Mayo de 2015Nombramientos. Apo.Sol.: MATEOS URRACA VICENTE BERNARDO. Datos registrales. T 7398, L 4699, F 68, S 8, H V 12045, I/A170 ( 4.05.15).
Nombramientos. Apoderado: HUESO NUÑEZ MARIA ROSA. Datos registrales. T 7398, L 4699, F 69, S 8, H V 12045, I/A 171 (4.05.15).
03 de Octubre de 2014Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 7398, L 4699, F 68, S 8, H V 12045, I/A 169 (26.09.14).
06 de Agosto de 2014Revocaciones. Apoderado: LOPEZ POZO JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 7398, L 4699, F 67, S 8, H V 12045, I/A 167(30.07.14).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: HUESO NUÑEZ MARIA ROSA. Datos registrales. T 7398, L 4699, F 68, S 8, H V 12045, I/A 168(30.07.14).
01 de Julio de 2014Revocaciones. Apoderado: FLORES IZQUIERDO DAVID. Datos registrales. T 7398, L 4699, F 67, S 8, H V 12045, I/A 164(24.06.14).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: VALVERDE CASERO FRANCISCO. Datos registrales. T 7398, L 4699, F 67, S 8, H V 12045, I/A165 (24.06.14).
Nombramientos. Apo.Manc.: GASCO VILLANUEVA JORGE DAVID;GUIJARRO GUIJARRO SEVERIANO. Datos registrales. T7398, L 4699, F 67, S 8, H V 12045, I/A 166 (24.06.14).
31 de Octubre de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: DE LA TORRE GIL CARLOS TOMAS;GENEREUX OLIVIER. Con.Delegado: DE LA TORRE GILCARLOS TOMAS. Presidente: GENEREUX OLIVIER. Nombramientos. Consejero: BASSET ERIC. Con.Delegado: BASSET ERIC.Consejero: CURRAN LEONARD STEPHEN. Presidente: CURRAN LEONARD STEPHEN. Datos registrales. T 7398, L 4699, F 67, S8, H V 12045, I/A 163 (24.10.13).
30 de Octubre de 2013Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 7398, L 4699, F 66, S 8, H V 12045, I/A 161 (23.10.13).
Revocaciones. Apoderado: BARRACHINA MONFERRER ANTONIO. Datos registrales. T 7398, L 4699, F 66, S 8, H V 12045, I/A162 (23.10.13).
24 de Octubre de 2013Nombramientos. Apoderado: GASCO VILLANUEVA JORGE DAVID;GUIJARRO GUIJARRO SEVERIANO. Datos registrales. T7398, L 4699, F 66, S 8, H V 12045, I/A 160 (17.10.13).
04 de Junio de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: GARCIA OTERO JOSE LUIS ARMANDO. Nombramientos. Consejero: YUJI GONDO RICARDO.Reelecciones. Consejero: RODRIGUEZ GALAN DE CONTES D'ESGRANGES MARIA LUISA. Secretario: RODRIGUEZ GALAN DECONTES D'ESGRANGES MARIA LUISA. Datos registrales. T 7398, L 4699, F 66, S 8, H V 12045, I/A 159 (28.05.13).
05 de Marzo de 2013Nombramientos. Apoderado: CIVERA QUILES MARIA DESAMPARADOS. Datos registrales. T 7398, L 4699, F 65, S 8, H V 12045,I/A 158 (26.02.13).
01 de Marzo de 2013Revocaciones. Apoderado: REQUENA CAMPILLO JUAN ANTONIO. Datos registrales. T 7398, L 4699, F 65, S 8, H V 12045, I/A157 (22.02.13).
07 de Diciembre de 2012Pérdida del caracter de unipersonalidad. Datos registrales. T 7398, L 4699, F 65, S 8, H V 12045, I/A 156 (28.11.12).