Actos BORME de Renovalia Bejis Sociedad Limitada
19 de Diciembre de 2022Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ LOZANO MANUEL. Datos registrales. T 1051, L 815, F 182, S 8, H AB 27635, I/A 11(10.12.22).
06 de Octubre de 2022Modificaci贸n de poderes. Apo.Sol.: DIAZ SILVESTRE SILVIA;NU脩EZ PASTRANA MARIA ISABEL;CAMPOY BLANESANGELES;SANCHEZ JIMENEZ SUSANA. Datos registrales. T 1036, L 800, F 81, S 8, H AB 27635, I/A 9 (29.09.22).
Nombramientos. Apo.Sol.: ROJAS HERREROS PEDRO MANUEL. Datos registrales. T 1051, L 815, F 182, S 8, H AB 27635, I/A10 (29.09.22).
19 de Julio de 2022Nombramientos. Apo.Sol.: ROJAS HERREROS PEDRO MANUEL. Datos registrales. T 1036, L 800, F 81, S 8, H AB 27635, I/A 8(11.07.22).
27 de Junio de 2022Nombramientos. Apo.Sol.: ARBIZU LASHERAS LAURA;GIL ACACIO MARIA DEL PILAR;ALVAREZ SANCHEZ ANA;IGLESIASSANTOS MARIA FELICIDAD. Datos registrales. T 1036, L 800, F 80, S 8, H AB 27635, I/A 7 (20.06.22).
12 de Noviembre de 2021Revocaciones. Apo.Sol.: CAMPOY BLANES ANGELES;DIAZ SILVESTRE SILVIA;NU脩EZ PASTRANA MARIA ISABEL;SANCHEZJIMENEZ SUSANA;CAMPOY BLANES ANGELES;DIAZ SILVESTRE SILVIA;NU脩EZ PASTRANA MARIA ISABEL;SANCHEZJIMENEZ SUSANA. Nombramientos. Apo.Sol.: DIAZ SILVESTRE SILVIA;NU脩EZ PASTRANA MARIA ISABEL;CAMPOY BLANESANGELES;SANCHEZ JIMENEZ SUSANA. Otros conceptos: REVOCADOS los poderes otorgados por escritura autorizada el d铆a 15de Abril de 2.021, ante el Notario de Madrid, Do帽a Rodriguez Mart铆n, Rocio, n煤mero 756 de protocolo. Datos registrales. T 1036, L800, F 80, S 8, H AB 27635, I/A 6 ( 3.11.21).
09 de Septiembre de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: DIAZ SILVESTRE SILVIA;NU脩EZ PASTRANA MARIA ISABEL;CAMPOY BLANES ANGELES;SANCHEZJIMENEZ SUSANA. Datos registrales. T 1032, L 796, F 11, S 8, H AB 27635, I/A 5 ( 2.09.21).
24 de Junio de 2021Nombramientos. Apo.Man.Soli: ESPINOSA PRADOS ROCIO;GIL ACACIO MARIA DEL PILAR. Apo.Sol.: REVILLO ALEGRE JOSELUIS. Apo.Man.Soli: MARTIN-PE脩ATO ECHEVARRIA TOMAS;ORTIZ HURTADO ITZIAR;OLEA AVILES JOSE MANUEL. Apo.Sol.:ALVAREZ SANCHEZ ANA. Datos registrales. T 1032, L 796, F 10, S 8, H AB 27635, I/A 4 (15.06.21).
31 de Mayo de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: DIAZ SILVESTRE SILVIA;NU脩EZ PASTRANA MARIA ISABEL;CAMPOY BLANES ANGELES;SANCHEZJIMENEZ SUSANA. Datos registrales. T 1009, L 773, F 116, S 8, H AB 27635, I/A 3 (24.05.21).
16 de Marzo de 2021Nombramientos. Apoderado: REVILLO ALEGRE JOSE LUIS. Datos registrales. T 1009, L 773, F 116, S 8, H AB 27635, I/A 2 (9.03.21).
09 de Agosto de 2019Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 29.07.19. Objeto social: La administraci贸n, gesti贸n, explotaci贸n y producci贸n de plantas degeneraci贸n de energ铆a el茅ctrica, de cualquier clase, ya sea de fuentes convencionales o renovables -solar, hidr谩ulica, e贸lica, biomasa ygeot茅rmica-, sistemas de transmisi贸n el茅ctrica e infraestructuras industriales. CNAE 3519. La ad. Domicilio: AVDA PICASENT, 10-EDIFICIO A (VILLARROBLEDO). Capital: 3.000,00 Euros. Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: RENOVALIA VALENCIASOCIEDAD LIMITADA. Nombramientos. Adm. Mancom.: OLEA AVILES JOSE MANUEL;GIL ACACIO MARIA DEL PILAR. Datosregistrales. T 1009, L 773, F 115, S 8, H AB 27635, I/A 1 ( 1.08.19).