Actos BORME de Renovalia Cheste Sociedad Limitada
19 de Diciembre de 2022Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ LOZANO MANUEL. Datos registrales. T 1051, L 815, F 191, S 8, H AB 27642, I/A 11(10.12.22).
06 de Octubre de 2022Modificaci贸n de poderes. Apo.Sol.: DIAZ SILVESTRE SILVIA;NU脩EZ PASTRANA MARIA ISABEL;CAMPOY BLANESANGELES;SANCHEZ JIMENEZ SUSANA. Datos registrales. T 1036, L 800, F 87, S 8, H AB 27642, I/A 9 (29.09.22).
Nombramientos. Apo.Sol.: ROJAS HERREROS PEDRO MANUEL. Datos registrales. T 1051, L 815, F 191, S 8, H AB 27642, I/A10 (29.09.22).
19 de Julio de 2022Nombramientos. Apo.Sol.: ROJAS HERREROS PEDRO MANUEL. Datos registrales. T 1036, L 800, F 87, S 8, H AB 27642, I/A 8(11.07.22).
27 de Junio de 2022Nombramientos. Apo.Sol.: ARBIZU LASHERAS LAURA;GIL ACACIO MARIA DEL PILAR;ALVAREZ SANCHEZ ANA;IGLESIASSANTOS MARIA FELICIDAD. Datos registrales. T 1036, L 800, F 86, S 8, H AB 27642, I/A 7 (20.06.22).
12 de Noviembre de 2021Revocaciones. Apo.Sol.: CAMPOY BLANES ANGELES;DIAZ SILVESTRE SILVIA;NU脩EZ PASTRANA MARIA ISABEL;SANCHEZJIMENEZ SUSANA;CAMPOY BLANES ANGELES;DIAZ SILVESTRE SILVIA;NU脩EZ PASTRANA MARIA ISABEL;SANCHEZJIMENEZ SUSANA. Nombramientos. Apo.Sol.: DIAZ SILVESTRE SILVIA;NU脩EZ PASTRANA MARIA ISABEL;CAMPOY BLANESANGELES;SANCHEZ JIMENEZ SUSANA. Otros conceptos: REVOCADOS los poderes otorgados en Escritura de otorgamiento depoder otorgada ante el Notario de Madrid, Do帽a Rodr铆guez Mart铆n, Rocio, el d铆a quince de Abril de dos mil veintiuno, n煤mero 756 deprotocolo. Datos registrales. T 1036, L 800, F 86, S 8, H AB 27642, I/A 6 ( 3.11.21).
09 de Septiembre de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: DIAZ SILVESTRE SILVIA;NU脩EZ PASTRANA MARIA ISABEL;CAMPOY BLANES ANGELES;SANCHEZJIMENEZ SUSANA. Datos registrales. T 1032, L 796, F 17, S 8, H AB 27642, I/A 5 ( 2.09.21).
24 de Junio de 2021Nombramientos. Apo.Man.Soli: ESPINOSA PRADOS ROCIO;GIL ACACIO MARIA DEL PILAR. Apo.Sol.: REVILLO ALEGRE JOSELUIS. Apo.Man.Soli: MARTIN-PE脩ATO ECHEVARRIA TOMAS;ORTIZ HURTADO ITZIAR;OLEA AVILES JOSE MANUEL. Apo.Sol.:ALVAREZ SANCHEZ ANA. Datos registrales. T 1032, L 796, F 16, S 8, H AB 27642, I/A 4 (15.06.21).
31 de Mayo de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: DIAZ SILVESTRE SILVIA;NU脩EZ PASTRANA MARIA ISABEL;CAMPOY BLANES ANGELES;SANCHEZJIMENEZ SUSANA. Datos registrales. T 1009, L 773, F 130, S 8, H AB 27642, I/A 3 (24.05.21).
16 de Marzo de 2021Nombramientos. Apoderado: REVILLO ALEGRE JOSE LUIS. Datos registrales. T 1009, L 773, F 130, S 8, H AB 27642, I/A 2 (9.03.21).
09 de Agosto de 2019Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 29.07.19. Objeto social: La administraci贸n, gesti贸n, explotaci贸n y producci贸n de plantas degeneraci贸n de energ铆a el茅ctrica, de cualquier clase, ya sea de fuentes convencionales o renovables -solar, hidr谩ulica, e贸lica, biomasa ygeot茅rmica-, sistemas de transmisi贸n el茅ctrica e infraestructuras industriales. CNAE 3519. La ad. Domicilio: AVDA PICASSENT, 10-EDIFICIO A 02600 (VILLARROBLEDO). Capital: 3.000,00 Euros. Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: RENOVALIAVALENCIA SOCIEDAD LIMITADA. Nombramientos. Adm. Mancom.: OLEA AVILES JOSE MANUEL;GIL ACACIO MARIA DELPILAR. Datos registrales. T 1009, L 773, F 129, S 8, H AB 27642, I/A 1 ( 1.08.19).