Actos BORME de Renovalia Ingenieria-epc Sociedad Anonima
27 de Octubre de 2021Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: GIL ACACIO MARIA DEL PILAR;OLEA AVILES JOSE MANUEL. Revocaciones. Apoderado:REVILLO ALEGRE JOSE LUIS. Apo.Man.Soli: GIL ACACIO MARIA DEL PILAR;OLEA AVILES JOSE MANUEL. Apo.Sol.: ALVAREZSANCHEZ ANA;REVILLO ALEGRE JOSE LUIS. Apo.Man.Soli: MARTIN-PEÑATO ECHEVARRIA TOMAS;ORTIZ HURTADOITZIAR;ESPINOSA PRADOS ROCIO. Disolución. Fusion. Extinción. Datos registrales. T 1033, L 797, F 136, S 8, H AB 3684, I/A50 (19.10.21).
06 de Julio de 2021Nombramientos. Apoderado: REVILLO ALEGRE JOSE LUIS. Otros conceptos: REVOCADO el poder otorgado a Don Juan CarlosSanmartin de Castro, en escritura otorgada el día 14 de Enero de 2.016, ante el Notario de madrid, Don Paz-Ares Rodríguez, Ignacio,número 95 de protocolo. Datos registrales. T 1033, L 797, F 136, S 8, H AB 3684, I/A 49 (29.06.21).
25 de Junio de 2021Revocaciones. Apo.Manc.: OLEA AVILES JOSE MANUEL. Apo.Sol.: GIL ACACIO MARIA DEL PILAR;SANMARTIN DE CASTROJUAN CARLOS;SANMARTIN DE CASTRO JUAN CARLOS. Apo.Manc.: SANMARTIN DE CASTRO JUAN CARLOS. Apo.Sol.: OLEAAVILES JOSE MANUEL. Nombramientos. Apo.Man.Soli: ESPINOSA PRADOS ROCIO;GIL ACACIO MARIA DEL PILAR. Apo.Sol.:REVILLO ALEGRE JOSE LUIS. Apo.Man.Soli: MARTIN-PEÑATO ECHEVARRIA TOMAS;ORTIZ HURTADO ITZIAR;OLEA AVILESJOSE MANUEL. Apo.Sol.: ALVAREZ SANCHEZ ANA. Datos registrales. T 979, L 743, F 42, S 8, H AB 3684, I/A 48 (15.06.21).
19 de Marzo de 2018Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: GALOBART SANCHEZ MARCO JAIME;OLEA AVILES JOSE MANUEL. Nombramientos. Adm.Mancom.: GIL ACACIO MARIA DEL PILAR;OLEA AVILES JOSE MANUEL. Otros conceptos: Artículo de los estatutos: ARTICULO17. La Sociedad estará regida y administrada por Dos Administradores Mancomunados. Para ser nombrado administrador no serequiere la calidad de accionista, pudiendo serlo tanto personas físicas como jurídicas. No podrán ser administradores las personas.Datos registrales. T 979, L 743, F 42, S 8, H AB 3684, I/A 47 (12.03.18).
27 de Febrero de 2018Revocaciones. Apo.Sol.: GALOBART SANCHEZ MARCO JAIME;GALOBART SANCHEZ MARCO JAIME. Apo.Manc.: GALOBARTSANCHEZ MARCO JAIME. Apoderado: GALOBART SANCHEZ MARCO JAIME. Nombramientos. Apo.Sol.: OLEA AVILES JOSEMANUEL. Datos registrales. T 979, L 743, F 42, S 8, H AB 3684, I/A 46 (20.02.18).
23 de Enero de 2017Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: SPV SPAIN 5 SOCIEDAD LIMITADA. Nombramientos. Adm. Solid.: GALOBART SANCHEZMARCO JAIME;OLEA AVILES JOSE MANUEL. Otros conceptos: Artículo de los estatutos: ARTICULO 17. La Sociedad estaráregida y administrada por Dos Administradores Solidarios. Para ser nombrado administrador no se requiere la calidad de accionista,pudiendo serlo tanto personas físicas como jurídicas. No podrán ser administradores las personas declaradas. Datos registrales. T968, L 732, F 27, S 8, H AB 3684, I/A 45 (13.01.17).
11 de Febrero de 2016Nombramientos. Apo.Sol.: SANMARTIN DE CASTRO JUAN CARLOS;GALOBART SANCHEZ MARCO JAIME;GIL ACACIO MARIADEL PILAR;SANMARTIN DE CASTRO JUAN CARLOS;GALOBART SANCHEZ MARCO JAIME. Apo.Manc.: SANMARTIN DECASTRO JUAN CARLOS;GALOBART SANCHEZ MARCO JAIME;OLEA AVILES JOSE MANUEL. Apoderado: GALOBART SANCHEZMARCO JAIME. Datos registrales. T 954, L 718, F 63, S 8, H AB 3684, I/A 44 ( 4.02.16).
01 de Febrero de 2016Revocaciones. Apo.Man.Soli: SANMARTIN DE CASTRO JUAN CARLOS;GALOBART SANCHEZ MARCO JAIME. Apo.Sol.: GILACACIO MARIA DEL PILAR. Apo.Man.Soli: OLEA AVILES JOSE MANUEL. Apoderado: MARTINEZ LOZANO MANUEL. Datosregistrales. T 954, L 718, F 63, S 8, H AB 3684, I/A 43 (25.01.16).
27 de Enero de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: ORTEGA MARTINEZ MARIA TERESA;GALOBART SANCHEZ MARCO JAIME;DIAZ ORTEGACARLOS. Cons.Del.Sol: ORTEGA MARTINEZ MARIA TERESA;GALOBART SANCHEZ MARCO JAIME. Presidente: ORTEGAMARTINEZ MARIA TERESA. Vicepresid.: GALOBART SANCHEZ MARCO JAIME. SecreNoConsj: GIL ACACIO MARIA DEL PILAR.VsecrNoConsj: SANMARTIN DE CASTRO JUAN CARLOS. Nombramientos. Adm. Unico: SPV SPAIN 5 SOCIEDAD LIMITADA.Modificaciones estatutarias. ARTICULO 15. Las Juntas Generales se celebrarán en la localidad donde la sociedad tenga sudomicilio. En todo lo demás, verificación de asistentes, votación y derecho de información del accionista, y cualquier otro aspectorelativo a la Junta que no venga regulado en los presentes estatutos, se ARTICULO 16. De las reuniones de la Junta General seextenderá acta en el libro llevado al efecto. El acta será aprobada en los términos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital..ARTICULO 17. La Sociedad estará regida y administrada por un Administrador Unico. Para ser nombrado administrador no se requierela calidad de accionista, pudiendo serlo tanto personas físicas como jurídicas. No podrán ser administradores las personas declaradasincompatibles por el artículo 213 de. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración aAdministrador único. ARTICULO 18º.- El Administrador Unico ejercerá su cargo durante el plazo de SEIS AÑOS. Los Administradorespodrán ser reelegidos para el cargo, una o varias veces, p or periodos de igual duración máxima. Datos registrales. T 954, L 718, F63, S 8, H AB 3684, I/A 42 (20.01.16).
23 de Diciembre de 2015Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 954, L 718, F 63, S 8, H AB 3684, I/A 41(16.12.15).
05 de Octubre de 2015Revocaciones. Apoderado: ORTEGA PARRA JUAN ANTONIO. Datos registrales. T 954, L 718, F 58, S 8, H AB 3684, I/A 40(28.09.15).
20 de Mayo de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: ROJAS GOMEZ MANUEL CELEDONIO. Revocaciones. Apo.Man.Soli: ROJAS GOMEZ MANUELCELEDONIO. Datos registrales. T 954, L 718, F 58, S 8, H AB 3684, I/A 39 (12.05.15).
01 de Abril de 2015Segregación. Beneficiarios de la segregación: ENERGIAS RENOVABLES Y MECANIZACIONES MANCHEGAS SOC. Datosregistrales. T 948, L 712, F 71, S 8, H AB 3684, I/A 38 (25.03.15).
30 de Diciembre de 2014Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 948, L 712, F 71, S 8, H AB 3684, I/A 37(22.12.14).
20 de Octubre de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: ORTEGA MARTINEZ JUAN DOMINGO. Presidente: ORTEGA MARTINEZ JUAN DOMINGO.Cons.Del.Sol: ORTEGA MARTINEZ JUAN DOMINGO. Secretario: GALOBART SANCHEZ MARCO JAIME. Vicepresid.: ORTEGAMARTINEZ MARIA TERESA. Nombramientos. Presidente: ORTEGA MARTINEZ MARIA TERESA. Vicepresid.: GALOBARTSANCHEZ MARCO JAIME. SecreNoConsj: GIL ACACIO MARIA DEL PILAR. VsecrNoConsj: SAN MARTIN DE CASTRO JUANCARLOS. Datos registrales. T 936, L 700, F 166, S 8, H AB 3684, I/A 36 (13.10.14).
27 de Mayo de 2014Ceses/Dimisiones. Vicepresid.: ROJAS GOMEZ MANUEL CELEDONIO. Secretario: ORTEGA MARTINEZ MARIA TERESA.Nombramientos. Secretario: GALOBART SANCHEZ MARCO JAIME. Vicepresid.: ORTEGA MARTINEZ MARIA TERESA.Cons.Del.Sol: GALOBART SANCHEZ MARCO JAIME. Datos registrales. T 936, L 700, F 166, S 8, H AB 3684, I/A 35 (20.05.14).
15 de Enero de 2014Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 936, L 700, F 166, S 8, H AB 3684, I/A 34 (8.01.14).
21 de Octubre de 2013Cambio de objeto social. la creación de programas de trabajo SOFTWARE para las aplicaciones industriales actuales en el campode la automatización y desarrollo de sistemas de control y comunicación a través de PLC - Controles Logísticos Programables - y PC -Ordenador Personal -, así como la venta de productos que intervi. Datos registrales. T 924, L 688, F 150, S 8, H AB 3684, I/A 30(14.10.13).
Cambio de domicilio social. AVDA PICASSENT 10 (VILLARROBLEDO). Datos registrales. T 924, L 688, F 150, S 8, H AB 3684,I/A 31 (14.10.13).
Reelecciones. Cons.Del.Sol: ORTEGA MARTINEZ JUAN DOMINGO;ORTEGA MARTINEZ MARIA TERESA. Datos registrales. T936, L 700, F 164, S 8, H AB 3684, I/A 32 (14.10.13).
30 de Abril de 2013Reelecciones. Consejero: ORTEGA MARTINEZ JUAN DOMINGO;ORTEGA MARTINEZ MARIA TERESA;ROJAS GOMEZ MANUELCELEDONIO;GALOBART SANCHEZ MARCO JAIME;DIAZ ORTEGA CARLOS. Presidente: ORTEGA MARTINEZ JUAN DOMINGO.Vicepresid.: ROJAS GOMEZ MANUEL CELEDONIO. Secretario: ORTEGA MARTINEZ MARIA TERESA. Datos registrales. T 924, L688, F 150, S 8, H AB 3684, I/A 29 (23.04.13).
31 de Diciembre de 2012Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 896, L 660, F 160, S 8, H AB 3684, I/A 27(24.12.12).
Revocaciones. Apo.Manc.: BERZOSA CUESTA JUAN TOMAS. Datos registrales. T 924, L 688, F 150, S 8, H AB 3684, I/A 28(24.12.12).
19 de Noviembre de 2012Revocaciones. Apoderado: HARO SANTOS MIGUEL. Nombramientos. Apoderado: ORTEGA PARRA JUAN ANTONIO. Datosregistrales. T 896, L 660, F 160, S 8, H AB 3684, I/A 26 ( 7.11.12).
25 de Octubre de 2012Nombramientos. Apoderado: HARO SANTOS MIGUEL. Datos registrales. T 896, L 660, F 160, S 8, H AB 3684, I/A 25 (15.10.12).
26 de Octubre de 2011Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 896, L 660, F 160, S 8, H AB 3684, I/A 24(14.10.11).
24 de Junio de 2011Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ LOZANO MANUEL. Datos registrales. T 896, L 660, F 159, S 8, H AB 3684, I/A 23(14.06.11).
14 de Junio de 2010Revocaciones. Apo.Manc.: ROJAS GOMEZ MANUEL CELEDONIO;CALERO BRAZALEZ JUAN JOSE;PERUYERO TOYOS JUANLUIS. Nombramientos. Apo.Man.Soli: SAN MARTIN DE CASTRO JUAN CARLOS;GALOBART SANCHEZ MARCO JAIME. Apo.Sol.:GIL ACACIO MARIA DEL PILAR. Apo.Man.Soli: OLEA AVILES JOSE MANUEL;ROJAS GOMEZ MANUEL CELEDONIO. Datosregistrales. T 893, L 657, F 70, S 8, H AB 3684, I/A 22 ( 2.06.10).