Actos BORME de Renovalia Invest Sociedad Limitada
19 de Diciembre de 2022Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ LOZANO MANUEL. Datos registrales. T 1033, L 797, F 134, S 8, H AB 17972, I/A 22(10.12.22).
25 de Junio de 2021Revocaciones. Apo.Sol.: SANMARTIN DE CASTRO JUAN CARLOS;GIL ACACIO MARIA DEL PILAR. Apo.Manc.: OLEA AVILESJOSE MANUEL;SANMARTIN DE CASTRO JUAN CARLOS. Apo.Sol.: SANMARTIN DE CASTRO JUAN CARLOS;GIL ACACIOMARIA DEL PILAR;OLEA AVILES JOSE MANUEL. Nombramientos. Apo.Man.Soli: ESPINOSA PRADOS ROCIO;GIL ACACIOMARIA DEL PILAR. Apo.Sol.: REVILLO ALEGRE JOSE LUIS. Apo.Man.Soli: MARTIN-PE脩ATO ECHEVARRIA TOMAS;ORTIZHURTADO ITZIAR;OLEA AVILES JOSE MANUEL. Apo.Sol.: ALVAREZ SANCHEZ ANA. Datos registrales. T 991, L 755, F 57, S 8,H AB 17972, I/A 21 (15.06.21).
16 de Marzo de 2021Nombramientos. Apoderado: REVILLO ALEGRE JOSE LUIS. Datos registrales. T 991, L 755, F 57, S 8, H AB 17972, I/A 20 (9.03.21).
19 de Marzo de 2018Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: GALOBART SANCHEZ MARCO JAIME;OLEA AVILES JOSE MANUEL. Nombramientos. Adm.Mancom.: GIL ACACIO MARIA DEL PILAR;OLEA AVILES JOSE MANUEL. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n:Administradores solidarios a Administradores mancomunados. Datos registrales. T 991, L 755, F 57, S 8, H AB 17972, I/A 19(12.03.18).
27 de Febrero de 2018Revocaciones. Apoderado: GALOBART SANCHEZ MARCO JAIME. Apo.Sol.: GALOBART SANCHEZ MARCO JAIME;GALOBARTSANCHEZ MARCO JAIME. Apo.Manc.: GALOBART SANCHEZ MARCO JAIME. Nombramientos. Apo.Sol.: OLEA AVILES JOSEMANUEL. Datos registrales. T 964, L 728, F 107, S 8, H AB 17972, I/A 18 (20.02.18).
07 de Diciembre de 2016Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: SPV SPAIN 5 SOCIEDAD LIMITADA. Nombramientos. Adm. Solid.: GALOBART SANCHEZMARCO JAIME;OLEA AVILES JOSE MANUEL. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico aAdministradores solidarios. Datos registrales. T 964, L 728, F 107, S 8, H AB 17972, I/A 16 (29.11.16).
Nombramientos. Apo.Sol.: GIL ACACIO MARIA DEL PILAR. Datos registrales. T 964, L 728, F 107, S 8, H AB 17972, I/A 17(29.11.16).
25 de Febrero de 2016Cambio de domicilio social. AVDA PICASSENT 10 - EDIFICIO A, 02600 (VILLARROBLEDO). Datos registrales. T 964, L 728, F107, S 8, H AB 17972, I/A 15 (18.02.16).
01 de Febrero de 2016Revocaciones. Apoderado: ORTEGA MARTINEZ MARIA TERESA. Apo.Man.Soli: SANMARTIN DE CASTRO JUANCARLOS;GALOBART SANCHEZ MARCO JAIME;OLEA AVILES JOSE MANUEL. Apo.Sol.: GIL ACACIO MARIA DEL PILAR.Apoderado: ORTEGA MARTINEZ MARIA TERESA. Datos registrales. T 964, L 728, F 107, S 8, H AB 17972, I/A 14 (25.01.16).
29 de Enero de 2016Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: GALOBART SANCHEZ MARCO JAIME;ORTEGA MARTINEZ MARIA TERESA. Nombramientos.Adm. Unico: SPV SPAIN 5 SOCIEDAD LIMITADA. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradoressolidarios a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 940, L 704, F 66, S 8, H AB 17972, I/A 12 (22.01.16).
Nombramientos. Apoderado: GALOBART SANCHEZ MARCO JAIME. Apo.Sol.: SANMARTIN DE CASTRO JUANCARLOS;GALOBART SANCHEZ MARCO JAIME;GIL ACACIO MARIA DEL PILAR;SANMARTIN DE CASTRO JUANCARLOS;GALOBART SANCHEZ MARCO JAIME. Apo.Manc.: SANMARTIN DE CASTRO JUAN CARLOS;GALOBART SANCHEZMARCO JAIME;OLEA AVILES JOSE MANUEL. Datos registrales. T 940, L 704, F 66, S 8, H AB 17972, I/A 13 (22.01.16).
21 de Octubre de 2014Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: ORTEGA MARTINEZ JUAN DOMINGO. Datos registrales. T 940, L 704, F 66, S 8, H AB 17972, I/A11 (13.10.14).
13 de Mayo de 2014Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: ORTEGA MARTINEZ JUAN DOMINGO. Nombramientos. Adm. Solid.: GALOBART SANCHEZMARCO JAIME;ORTEGA MARTINEZ JUAN DOMINGO;ORTEGA MARTINEZ MARIA TERESA. Modificaciones estatutarias.Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Administradores solidarios. Datos registrales. T 940, L 704, F 66, S 8, HAB 17972, I/A 10 ( 6.05.14).
03 de Febrero de 2014Cambio de domicilio social. AVDA DE LOS REYES CATOLICOS 151 (VILLARROBLEDO). Datos registrales. T 940, L 704, F 66,S 8, H AB 17972, I/A 9 (24.01.14).
30 de Enero de 2014Nombramientos. Apoderado: ORTEGA MARTINEZ MARIA TERESA. Datos registrales. T 925, L 689, F 3, S 8, H AB 17972, I/A 7(22.01.14).
03 de Enero de 2013Revocaciones. Apoderado: CALERO BRAZALEZ JUAN JOSE. Datos registrales. T 900, L 664, F 172, S 8, H AB 17972, I/A 6(15.12.12).
19 de Diciembre de 2012Ampliaci贸n de capital. Capital: 5.300.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 5.303.006,00 Euros. Datos registrales. T 900, L 664, F172, S 8, H AB 17972, I/A 7 (12.12.12).
10 de Noviembre de 2010Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: PAGO DE JUAN AGUSTIN SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 896, L 660,F 144, S 8, H AB 17972, I/A 5 (29.10.10).
14 de Junio de 2010Nombramientos. Apo.Man.Soli: SAN MARTIN DE CASTRO JUAN CARLOS;GALOBART SANCHEZ MARCO JAIME;OLEA AVILESJOSE MANUEL. Apo.Sol.: GIL ACACIO MARIA DEL PILAR. Datos registrales. T 867, L 631, F 46, S 8, H AB 17972, I/A 4 ( 2.06.10).