Buscador CIF Logo

Actos BORME Renovalia Invest Sociedad Limitada

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Renovalia Invest Sociedad Limitada

Actos BORME Renovalia Invest Sociedad Limitada - B02445815

Tenemos registrados 19 Actos BORME del Registro Mercantil de Albacete para Renovalia Invest Sociedad Limitada con CIF B02445815

馃敊 Perfil de Renovalia Invest Sociedad Limitada
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Albacete

Actos BORME de Renovalia Invest Sociedad Limitada

19 de Diciembre de 2022
Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ LOZANO MANUEL. Datos registrales. T 1033, L 797, F 134, S 8, H AB 17972, I/A 22(10.12.22).

25 de Junio de 2021
Revocaciones. Apo.Sol.: SANMARTIN DE CASTRO JUAN CARLOS;GIL ACACIO MARIA DEL PILAR. Apo.Manc.: OLEA AVILESJOSE MANUEL;SANMARTIN DE CASTRO JUAN CARLOS. Apo.Sol.: SANMARTIN DE CASTRO JUAN CARLOS;GIL ACACIOMARIA DEL PILAR;OLEA AVILES JOSE MANUEL. Nombramientos. Apo.Man.Soli: ESPINOSA PRADOS ROCIO;GIL ACACIOMARIA DEL PILAR. Apo.Sol.: REVILLO ALEGRE JOSE LUIS. Apo.Man.Soli: MARTIN-PE脩ATO ECHEVARRIA TOMAS;ORTIZHURTADO ITZIAR;OLEA AVILES JOSE MANUEL. Apo.Sol.: ALVAREZ SANCHEZ ANA. Datos registrales. T 991, L 755, F 57, S 8,H AB 17972, I/A 21 (15.06.21).

16 de Marzo de 2021
Nombramientos. Apoderado: REVILLO ALEGRE JOSE LUIS. Datos registrales. T 991, L 755, F 57, S 8, H AB 17972, I/A 20 (9.03.21).

19 de Marzo de 2018
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: GALOBART SANCHEZ MARCO JAIME;OLEA AVILES JOSE MANUEL. Nombramientos. Adm.Mancom.: GIL ACACIO MARIA DEL PILAR;OLEA AVILES JOSE MANUEL. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n:Administradores solidarios a Administradores mancomunados. Datos registrales. T 991, L 755, F 57, S 8, H AB 17972, I/A 19(12.03.18).

27 de Febrero de 2018
Revocaciones. Apoderado: GALOBART SANCHEZ MARCO JAIME. Apo.Sol.: GALOBART SANCHEZ MARCO JAIME;GALOBARTSANCHEZ MARCO JAIME. Apo.Manc.: GALOBART SANCHEZ MARCO JAIME. Nombramientos. Apo.Sol.: OLEA AVILES JOSEMANUEL. Datos registrales. T 964, L 728, F 107, S 8, H AB 17972, I/A 18 (20.02.18).

07 de Diciembre de 2016
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: SPV SPAIN 5 SOCIEDAD LIMITADA. Nombramientos. Adm. Solid.: GALOBART SANCHEZMARCO JAIME;OLEA AVILES JOSE MANUEL. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico aAdministradores solidarios. Datos registrales. T 964, L 728, F 107, S 8, H AB 17972, I/A 16 (29.11.16).

Nombramientos. Apo.Sol.: GIL ACACIO MARIA DEL PILAR. Datos registrales. T 964, L 728, F 107, S 8, H AB 17972, I/A 17(29.11.16).

25 de Febrero de 2016
Cambio de domicilio social. AVDA PICASSENT 10 - EDIFICIO A, 02600 (VILLARROBLEDO). Datos registrales. T 964, L 728, F107, S 8, H AB 17972, I/A 15 (18.02.16).

01 de Febrero de 2016
Revocaciones. Apoderado: ORTEGA MARTINEZ MARIA TERESA. Apo.Man.Soli: SANMARTIN DE CASTRO JUANCARLOS;GALOBART SANCHEZ MARCO JAIME;OLEA AVILES JOSE MANUEL. Apo.Sol.: GIL ACACIO MARIA DEL PILAR.Apoderado: ORTEGA MARTINEZ MARIA TERESA. Datos registrales. T 964, L 728, F 107, S 8, H AB 17972, I/A 14 (25.01.16).

29 de Enero de 2016
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: GALOBART SANCHEZ MARCO JAIME;ORTEGA MARTINEZ MARIA TERESA. Nombramientos.Adm. Unico: SPV SPAIN 5 SOCIEDAD LIMITADA. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradoressolidarios a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 940, L 704, F 66, S 8, H AB 17972, I/A 12 (22.01.16).

Nombramientos. Apoderado: GALOBART SANCHEZ MARCO JAIME. Apo.Sol.: SANMARTIN DE CASTRO JUANCARLOS;GALOBART SANCHEZ MARCO JAIME;GIL ACACIO MARIA DEL PILAR;SANMARTIN DE CASTRO JUANCARLOS;GALOBART SANCHEZ MARCO JAIME. Apo.Manc.: SANMARTIN DE CASTRO JUAN CARLOS;GALOBART SANCHEZMARCO JAIME;OLEA AVILES JOSE MANUEL. Datos registrales. T 940, L 704, F 66, S 8, H AB 17972, I/A 13 (22.01.16).

21 de Octubre de 2014
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: ORTEGA MARTINEZ JUAN DOMINGO. Datos registrales. T 940, L 704, F 66, S 8, H AB 17972, I/A11 (13.10.14).

13 de Mayo de 2014
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: ORTEGA MARTINEZ JUAN DOMINGO. Nombramientos. Adm. Solid.: GALOBART SANCHEZMARCO JAIME;ORTEGA MARTINEZ JUAN DOMINGO;ORTEGA MARTINEZ MARIA TERESA. Modificaciones estatutarias.Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Administradores solidarios. Datos registrales. T 940, L 704, F 66, S 8, HAB 17972, I/A 10 ( 6.05.14).

03 de Febrero de 2014
Cambio de domicilio social. AVDA DE LOS REYES CATOLICOS 151 (VILLARROBLEDO). Datos registrales. T 940, L 704, F 66,S 8, H AB 17972, I/A 9 (24.01.14).

30 de Enero de 2014
Nombramientos. Apoderado: ORTEGA MARTINEZ MARIA TERESA. Datos registrales. T 925, L 689, F 3, S 8, H AB 17972, I/A 7(22.01.14).

03 de Enero de 2013
Revocaciones. Apoderado: CALERO BRAZALEZ JUAN JOSE. Datos registrales. T 900, L 664, F 172, S 8, H AB 17972, I/A 6(15.12.12).

19 de Diciembre de 2012
Ampliaci贸n de capital. Capital: 5.300.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 5.303.006,00 Euros. Datos registrales. T 900, L 664, F172, S 8, H AB 17972, I/A 7 (12.12.12).

10 de Noviembre de 2010
Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: PAGO DE JUAN AGUSTIN SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 896, L 660,F 144, S 8, H AB 17972, I/A 5 (29.10.10).

14 de Junio de 2010
Nombramientos. Apo.Man.Soli: SAN MARTIN DE CASTRO JUAN CARLOS;GALOBART SANCHEZ MARCO JAIME;OLEA AVILESJOSE MANUEL. Apo.Sol.: GIL ACACIO MARIA DEL PILAR. Datos registrales. T 867, L 631, F 46, S 8, H AB 17972, I/A 4 ( 2.06.10).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n