Actos BORME de Renovalia Wind 2 Sociedad Limitada
07 de Enero de 2020Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: GIL ACACIO MARIA DEL PILAR;OLEA AVILES JOSE MANUEL. Revocaciones. Apo.Sol.:SANMARTIN DE CASTRO JUAN CARLOS. Apo.Manc.: OLEA AVILES JOSE MANUEL;SANMARTIN DE CASTRO JUAN CARLOS.Apo.Sol.: SANMARTIN DE CASTRO JUAN CARLOS;GIL ACACIO MARIA DEL PILAR;GIL ACACIO MARIA DEL PILAR;OLEA AVILESJOSE MANUEL. Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 991, L 755, F 55, S 8, H AB 21032, I/A 17 (27.12.19).
15 de Marzo de 2018Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: GALOBART SANCHEZ MARCO JAIME;OLEA AVILES JOSE MANUEL. Nombramientos. Adm.Mancom.: GIL ACACIO MARIA DEL PILAR;OLEA AVILES JOSE MANUEL. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n:Administradores solidarios a Administradores mancomunados. Datos registrales. T 991, L 755, F 55, S 8, H AB 21032, I/A 16 (8.03.18).
27 de Febrero de 2018Revocaciones. Apoderado: GALOBART SANCHEZ MARCO JAIME. Apo.Sol.: GALOBART SANCHEZ MARCO JAIME;GALOBARTSANCHEZ MARCO JAIME. Apo.Manc.: GALOBART SANCHEZ MARCO JAIME. Nombramientos. Apo.Sol.: OLEA AVILES JOSEMANUEL. Datos registrales. T 964, L 728, F 134, S 8, H AB 21032, I/A 15 (20.02.18).
07 de Diciembre de 2016Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: SPV SPAIN 5 SOCIEDAD LIMITADA. Nombramientos. Adm. Solid.: GALOBART SANCHEZMARCO JAIME;OLEA AVILES JOSE MANUEL. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico aAdministradores solidarios. Datos registrales. T 964, L 728, F 134, S 8, H AB 21032, I/A 13 (29.11.16).
Nombramientos. Apo.Sol.: GIL ACACIO MARIA DEL PILAR. Datos registrales. T 964, L 728, F 134, S 8, H AB 21032, I/A 14(29.11.16).
25 de Febrero de 2016Cambio de domicilio social. AVDA PICASSENT 10 - EDIFICIO A, 02600 (VILLARROBLEDO). Datos registrales. T 964, L 728, F134, S 8, H AB 21032, I/A 12 (18.02.16).
01 de Febrero de 2016Revocaciones. Apo.Man.Soli: SANMARTIN DE CASTRO JUAN CARLOS;GALOBART SANCHEZ MARCO JAIME;OLEA AVILESJOSE MANUEL. Apo.Sol.: GIL ACACIO MARIA DEL PILAR. Apoderado: ORTEGA MARTINEZ MARIA TERESA. Datos registrales. T964, L 728, F 112, S 8, H AB 21032, I/A 11 (25.01.16).
29 de Enero de 2016Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: GALOBART SANCHEZ MARCO JAIME;ORTEGA MARTINEZ MARIA TERESA. Nombramientos.Adm. Unico: SPV SPAIN 5 SOCIEDAD LIMITADA. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradoressolidarios a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 943, L 707, F 194, S 8, H AB 21032, I/A 9 (22.01.16).
Nombramientos. Apoderado: GALOBART SANCHEZ MARCO JAIME. Apo.Sol.: SANMARTIN DE CASTRO JUANCARLOS;GALOBART SANCHEZ MARCO JAIME;GIL ACACIO MARIA DEL PILAR;SANMARTIN DE CASTRO JUANCARLOS;GALOBART SANCHEZ MARCO JAIME. Apo.Manc.: SANMARTIN DE CASTRO JUAN CARLOS;GALOBART SANCHEZMARCO JAIME;OLEA AVILES JOSE MANUEL. Datos registrales. T 943, L 707, F 194, S 8, H AB 21032, I/A 10 (22.01.16).
23 de Diciembre de 2015Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 943, L 707, F 194, S 8, H AB 21032, I/A 8(16.12.15).
21 de Octubre de 2014Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: ORTEGA MARTINEZ JUAN DOMINGO. Datos registrales. T 943, L 707, F 194, S 8, H AB 21032,I/A 7 (14.10.14).
13 de Mayo de 2014Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: ORTEGA MARTINEZ JUAN DOMINGO. Nombramientos. Adm. Solid.: GALOBART SANCHEZMARCO JAIME;ORTEGA MARTINEZ JUAN DOMINGO;ORTEGA MARTINEZ MARIA TERESA. Modificaciones estatutarias.Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Administradores solidarios. Datos registrales. T 896, L 660, F 146, S 8,H AB 21032, I/A 6 ( 6.05.14).
03 de Febrero de 2014Cambio de domicilio social. AVDA AVENIDA DE LOS REYES CATOLICOS 151 (VILLARROBLEDO). Datos registrales. T 896, L660, F 146, S 8, H AB 21032, I/A 5 (24.01.14).
30 de Enero de 2014Nombramientos. Apoderado: ORTEGA MARTINEZ MARIA TERESA. Datos registrales. T 890, L 654, F 94, S 8, H AB 21032, I/A 4(22.01.14).
31 de Diciembre de 2012Nombramientos. Auditor: BDO AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 890, L 654, F 94, S 8, H AB 21032, I/A 3(24.12.12).
14 de Junio de 2010Nombramientos. Apo.Man.Soli: SAN MARTIN DE CASTRO JUAN CARLOS;GALOBART SANCHEZ MARCO JAIME;OLEA AVILESJOSE MANUEL. Apo.Sol.: GIL ACACIO MARIA DEL PILAR. Datos registrales. T 890, L 654, F 94, S 8, H AB 21032, I/A 2 ( 2.06.10).
03 de Diciembre de 2009Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 18.11.09. Objeto social: La adquisici贸n, tenencia disfrute y enajenaci贸n de toda clase devalores yactivos mobiliarios por cuenta propia, la participaci贸n en sociedades o entidades mercantiles, espa帽olas o extranjeras,cualquiera que sea su fin u objero, mediante la suscripci贸n de capital o adquisici贸n por cualquier t铆tulo. Domicilio: AVDA DE LOSREYES CATOLICOS 135 (VILLARROBLEDO). Capital: 37.047.420,00 Euros. Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico:RENOVALIA WIND SOCIEDAD LIMITADA. Nombramientos. Adm. Unico: ORTEGA MARTINEZ JUAN DOMINGO. Datosregistrales. T 890, L 654, F 91, S 8, H AB 21032, I/A 1 (24.11.09).