Buscador CIF Logo

Actos BORME Renta Antigua Lopez Brea Sociedad Limitada

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Renta Antigua Lopez Brea Sociedad Limitada

Actos BORME Renta Antigua Lopez Brea Sociedad Limitada - B28250090

Tenemos registrados 19 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Renta Antigua Lopez Brea Sociedad Limitada con CIF B28250090

馃敊 Perfil de Renta Antigua Lopez Brea Sociedad Limitada
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Renta Antigua Lopez Brea Sociedad Limitada

13 de Julio de 2021
Revocaciones. Apoderado: LOPEZ BREA REDONDO FRANCISCO. Apo.Manc.: GUIJARRO JIMENEZ MARIA MILAGROS;LOPEZ-BREA ESPESO MARTA MARIA DEL MAR;LOPEZ-BREA ESPESO MARIA FRANCISCA;LOPEZ BREA ESPESO JOSEIGNACIO;LOPEZ-BREA ESPESO JUAN JAVIER. Apoderado: LOPEZ-BREA ESPESO MARTA MARIA DEL MAR;LOPEZ-BREAESPESO JUAN JAVIER;LOPEZ BREA ESPESO JOSE IGNACIO. Nombramientos. Apoderado: LOPEZ-BREA ESPESO MARTAMARIA DEL MAR. Datos registrales. T 39532 , F 167, S 8, H M 99727, I/A 75 ( 6.07.21).

17 de Junio de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: LOPEZ-BREA ESPESO MARIA FRANCISCA. Secretario: LOPEZ-BREA ESPESO MARIAFRANCISCA. Vicesecret.: LOPEZ-BREA ESPESO MARTA MARIA DEL MAR. Revocaciones. Apoderado: LOPEZ-BREA ESPESOMARIA FRANCISCA. Nombramientos. Vicepresid.: LOPEZ-BREA ESPESO JUAN JAVIER. Secretario: LOPEZ-BREA ESPESOMARTA MARIA DEL MAR. Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 1.242.966,50 Euros. Resultante Suscrito: 3.728.899,50 Euros.Datos registrales. T 39532 , F 153, S 8, H M 99727, I/A 74 (10.06.20).

19 de Marzo de 2020
Ampliaci贸n de capital. Capital: 3.617.688,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.971.866,00 Euros. Datos registrales. T 39277 , F 121, S8, H M 99727, I/A 73 (12.03.20).

16 de Diciembre de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: LOPEZ BREA REDONDO FRANCISCO. Presidente: LOPEZ BREA REDONDO FRANCISCO.Con.Delegado: LOPEZ BREA REDONDO FRANCISCO. Nombramientos. Presidente: LOPEZ BREA ESPESO JOSE IGNACIO.Otros conceptos: Ampliar las facultades conferidos a los apoderados en virtud de escitura con n煤mero de protoloco 2043, que caus贸la inscripci贸n 69陋 de la hoja social. Datos registrales. T 39019 , F 2, S 8, H M 99727, I/A 72 ( 5.12.19).

04 de Diciembre de 2019
Nombramientos. Apoderado: MARTIN LOPEZ JOSE LUIS. Datos registrales. T 39019 , F 1, S 8, H M 99727, I/A 71 (27.11.19).

11 de Abril de 2019
Nombramientos. Apoderado: MARTIN LOPEZ JOSE LUIS. Datos registrales. T 21897 , F 159, S 8, H M 99727, I/A 70 ( 4.04.19).

16 de Agosto de 2018
Nombramientos. Apoderado: LOPEZ-BREA ESPESO MARIA FRANCISCA;LOPEZ-BREA ESPESO MARTA MARIA DELMAR;LOPEZ-BREA ESPESO JUAN JAVIER;LOPEZ BREA ESPESO JOSE IGNACIO. Datos registrales. T 21897 , F 158, S 8, H M99727, I/A 69 ( 8.08.18).

16 de Julio de 2018
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: LOPEZ BREA REDONDO FRANCISCO. Nombramientos. Consejero: LOPEZ BREA REDONDOFRANCISCO. Presidente: LOPEZ BREA REDONDO FRANCISCO. Con.Delegado: LOPEZ BREA REDONDO FRANCISCO.Consejero: LOPEZ-BREA ESPESO MARIA FRANCISCA. Secretario: LOPEZ-BREA ESPESO MARIA FRANCISCA. Consejero:LOPEZ-BREA ESPESO MARTA MARIA DEL MAR. Vicesecret.: LOPEZ-BREA ESPESO MARTA MARIA DEL MAR. Consejero:LOPEZ-BREA ESPESO JUAN JAVIER;LOPEZ BREA ESPESO JOSE IGNACIO. Otros conceptos: Cambio del Organo deAdministraci贸n: Administrador 煤nico a Consejo de administraci贸n. Datos registrales. T 21897 , F 157, S 8, H M 99727, I/A 68 (9.07.18).

19 de Marzo de 2018
Revocaciones. Apoderado: GUIJARRO JIMENEZ MILAGROS. Apo.Sol.: GUIJARRO JIMENEZ MARIA MILAGROS;GUIJARROJIMENEZ MARIA MILAGROS. Apoderado: MARTIN LOPEZ JOSE LUIS;GUIJARRO JIMENEZ MARIA MILAGROS. Datosregistrales. T 21897 , F 156, S 8, H M 99727, I/A 66 ( 8.03.18).

Nombramientos. Apo.Manc.: GUIJARRO JIMENEZ MARIA MILAGROS;LOPEZ-BREA ESPESO MARTA MARIA DEL MAR;LOPEZ-BREA ESPESO MARIA FRANCISCA;LOPEZ BREA ESPESO JOSE IGNACIO;LOPEZ-BREA ESPESO JUAN JAVIER. Datosregistrales. T 21897 , F 156, S 8, H M 99727, I/A 67 ( 8.03.18).

02 de Agosto de 2017
Ampliaci贸n de capital. Capital: 853.849,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.354.178,00 Euros. Fusi贸n por absorci贸n. Sociedadesabsorbidas: RS2012 INVESTMENTS SPAIN SL. RS 2012 INVESTMENT HOLDING SL. Datos registrales. T 21897 , F 152, S 8, H M99727, I/A 65 (26.07.17).

11 de Mayo de 2017
Nombramientos. Apoderado: GUIJARRO JIMENEZ MARIA MILAGROS. Datos registrales. T 21897 , F 152, S 8, H M 99727, I/A 64( 4.05.17).

13 de Enero de 2016
Nombramientos. Auditor: AFP AUDIT & CONSULTING SL. Datos registrales. T 21897 , F 152, S 8, H M 99727, I/A 63 ( 5.01.16).

03 de Julio de 2014
Revocaciones. Apoderado: GUTIERREZ MU脩OZ SANTIAGO JOSE. Datos registrales. T 21897 , F 151, S 8, H M 99727, I/A 61(26.06.14).

Nombramientos. Apoderado: MARTIN LOPEZ JOSE LUIS. Datos registrales. T 21897 , F 151, S 8, H M 99727, I/A 62 (26.06.14).

18 de Diciembre de 2013
Revocaciones. Apoderado: GONZALEZ GATA ANTONIO. Apo.Sol.: GONZALEZ GATA ANTONIO;GONZALEZ GATA ANTONIO.Datos registrales. T 21897 , F 151, S 8, H M 99727, I/A 60 (11.12.13).

05 de Marzo de 2013
Modificaciones estatutarias. 26. Retribuci贸n 贸rgano administraci贸n.-. Datos registrales. T 21897 , F 151, S 8, H M 99727, I/A 59(25.02.13).

03 de Enero de 2013
Nombramientos. Auditor: LAES NEXIA AC SL. Datos registrales. T 21897 , F 150, S 8, H M 99727, I/A 58 (26.12.12).

16 de Mayo de 2012
Nombramientos. Apo.Sol.: GUIJARRO JIMENEZ MARIA MILAGROS;GONZALEZ GATA ANTONIO. Datos registrales. T 21897 , F150, S 8, H M 99727, I/A 57 ( 4.05.12).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n