Actos BORME de Repsol Servicios Renovables Sa
26 de Octubre de 2023Nombramientos. Apoderado: MERINO GARCIA PEDRO ANTONIO. Datos registrales. T 23888 , F 225, S 8, H M 11072, I/A 100(19.10.23).
10 de Mayo de 2023Nombramientos. Apoderado: DIAZ ALDAO MARIA LUCIA. Datos registrales. T 23888 , F 225, S 8, H M 11072, I/A 99 ( 3.05.23).
18 de Abril de 2023Nombramientos. Apoderado: BRETON LESMES JOSE IGNACIO. Datos registrales. T 23888 , F 224, S 8, H M 11072, I/A 97(11.04.23).
Revocaciones. Apoderado: GRANDE DIAZ ALEJANDRO;ZAPATA RAMON TOMAS;HERNANDEZ PEREZ ENRIQUE. Apo.Sol.:URIBE GALINDO GLADYS;MARAVALL CIFUENTES PABLO. Apoderado: MERINO GARCIA PEDRO ANTONIO. Datos registrales.T 23888 , F 225, S 8, H M 11072, I/A 98 (11.04.23).
22 de Febrero de 2023Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 23888 , F 223, S 8, H M 11072,I/A 95 (15.02.23).
Nombramientos. Apoderado: VILLORIA MARTINEZ MIGUEL. Datos registrales. T 23888 , F 223, S 8, H M 11072, I/A 96(15.02.23).
24 de Octubre de 2022Revocaciones. Apoderado: MI脩ANO FERNANDEZ GERMAN. Datos registrales. T 23888 , F 223, S 8, H M 11072, I/A 94(17.10.22).
20 de Octubre de 2022Fe de erratas: Se public贸 por error en la Inscripci贸n 78陋 el nmobramiento como Apoderado de TOMAS RODRIGUEZ RAMIRO, siendolo correcto MI脩ANO FERNANDEZ GERMAN. Datos registrales. T 23888 , F 212, S 8, H M 11072, I/A 78 (11.06.18).
19 de Agosto de 2022Nombramientos. Apo.Sol.: PORRAS PERALES EVA. Datos registrales. T 23888 , F 221, S 8, H M 11072, I/A 92 (11.08.22).
Nombramientos. Apo.Sol.: PEDROSA GOMEZ ENRIQUE;GOMEZ REDONDO SERGIO ALFONSO;GARCIA ALAJARIN PAZ. Datosregistrales. T 23888 , F 222, S 8, H M 11072, I/A 93 (11.08.22).
24 de Marzo de 2022Nombramientos. Apoderado: MERINO GARCIA PEDRO ANTONIO. Datos registrales. T 23888 , F 221, S 8, H M 11072, I/A 91(17.03.22).
31 de Enero de 2022Revocaciones. Apoderado: BENITO ZAMARRIEGO MARIANO. Nombramientos. Apoderado: GOMEZ REDONDO SERGIOALFONSO. Datos registrales. T 23888 , F 219, S 8, H M 11072, I/A 90 (24.01.22).
07 de Enero de 2022Cambio de domicilio social. C/ MENDEZ ALVARO 44 (MADRID). Datos registrales. T 23888 , F 219, S 8, H M 11072, I/A 89(30.12.21).
23 de Junio de 2021Nombramientos. Apoderado: SANZ MADRO脩O PATRICIA. Datos registrales. T 23888 , F 218, S 8, H M 11072, I/A 88 (16.06.21).
10 de Junio de 2021Nombramientos. Apoderado: BENITO ZAMARRIEGO MARIANO;DE LA LAMA ALCAIDE JOSE MANUEL;SEIJAS UZQUIZAIGNACIO. Datos registrales. T 23888 , F 217, S 8, H M 11072, I/A 87 ( 3.06.21).
13 de Mayo de 2021Nombramientos. Apoderado: GUILLEN RUIZ JULIA. Datos registrales. T 23888 , F 216, S 8, H M 11072, I/A 85 ( 6.05.21).
Nombramientos. Apoderado: ESCOBAR FUERTES CARLOS. Datos registrales. T 23888 , F 216, S 8, H M 11072, I/A 86 (6.05.21).
24 de Marzo de 2021Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: REPSOL RENOVABLES SL. Datos registrales. T 23888 , F 216, S 8, H M 11072,I/A 84 (16.03.21).
15 de Marzo de 2021Nombramientos. Apoderado: ESCOBAR FUERTES CARLOS. Datos registrales. T 23888 , F 215, S 8, H M 11072, I/A 82 (8.03.21).
Nombramientos. Apo.Sol.: DE LUIS GARCIA MARIA ISABEL. Datos registrales. T 23888 , F 215, S 8, H M 11072, I/A 83 ( 8.03.21).