Actos BORME de Residencia Nueva Vida Sa
06 de Noviembre de 2023Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 44167 , F 181, S 8, H M 705926, I/A 16 (27.10.23).
11 de Mayo de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: ABAJO MENGUEZ MARIO;GARCIA ORTIZ ANTONIO. Datos registrales. T 39729 , F 73, S 8, H M705926, I/A 14 ( 4.05.23).
09 de Mayo de 2023Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: GARCIA GARCIA VALENTIN. Nombramientos. Adm. Mancom.: ABAJO MENGUEZ MARIO.Datos registrales. T 39729 , F 73, S 8, H M 705926, I/A 13 (28.04.23).
20 de Abril de 2023Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ ALEGRE MARIA DOLORES. Datos registrales. T 39729 , F 72, S 8, H M 705926, I/A 12(13.04.23).
24 de Marzo de 2022Revocaciones. Apo.Sol.: DIEZ BARCENILLA JOSE MANUEL. Datos registrales. T 39729 , F 72, S 8, H M 705926, I/A 11(17.03.22).
21 de Febrero de 2022Nombramientos. Apoderado: ORTIZ CAS FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 39729 , F 72, S 8, H M 705926, I/A 10(14.02.22).
05 de Octubre de 2021Nombramientos. Apoderado: VELOSO SOTO MARIA. Datos registrales. T 39729 , F 71, S 8, H M 705926, I/A 9 (28.09.21).
06 de Agosto de 2021Nombramientos. Apoderado: RUBIO VALOR PABLO. Datos registrales. T 39729 , F 71, S 8, H M 705926, I/A 8 (30.07.21).
08 de Febrero de 2021Revocaciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 39729 , F
12 de Marzo de 2020Nombramientos. Apoderado: RUBIO VALOR PABLO. Datos registrales. T 39729 , F 69, S 8, H M 705926, I/A 6 ( 5.03.20).
12 de Febrero de 2020Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Otros conceptos: Se revoca el nombramiento de "Galicontrol SL" como auditorpara los ejercicios 2019 y 2020 por justa causa. Datos registrales. T 39729 , F 69, S 8, H M 705926, I/A 5 ( 5.02.20).
07 de Noviembre de 2019Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: CASER RESIDENCIAL INMOBILIARIA SA. Datos registrales. T 39729 , F 69, S 8,H M 705926, I/A 4 (30.10.19).
30 de Octubre de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: IGLESIAS LOUREIRO BEATRIZ. Datos registrales. T 39729 , F 68, S 8, H M 705926, I/A 3 (23.10.19).
23 de Octubre de 2019Cambio de domicilio social. AVDA DE BURGOS 109 (MADRID). Datos registrales. T 39729 , F 68, S 8, H M 705926, I/A 2(16.10.19).
05 de Septiembre de 2019Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: IGLESIAS LOUREIRO BEATRIZ. Nombramientos. Adm. Mancom.: GARCIA GARCIAVALENTIN;GARCIA ORTIZ ANTONIO. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico aAdministradores mancomunados. Modificados los art铆culos 6, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 20 y 21 de los estatutos sociales. Datos registrales.T 2710, L 2710, F 123, S 8, H PO 30184, I/A 21 (28.08.19).
18 de Marzo de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: GARMENDIA FERNANDEZ JESUS;FUENTES DIAZ VIRGINIA;REY GONZALEZ ALEJANDRO;PELAEZRODRIGUEZ JOSE ALBERTO;DIEZ BARCENILLA JOSE MANUEL. Datos registrales. T 2710, L 2710, F 122, S 8, H PO 30184, I/A19 ( 8.03.19).
Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ ALEGRE MARIA DOLORES. Datos registrales. T 2710, L 2710, F 122, S 8, H PO 30184,I/A 20 ( 8.03.19).
13 de Febrero de 2019Revocaciones. Apoderado: IGLESIAS LOUREIRO BEATRIZ;DOCAMPO BUGALLO JOSE LUIS;DOCAMPO BUGALLO JOSE LUIS.Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA ORTIZ ANTONIO;GARCIA GARCIA VALENTIN. Datos registrales. T 2710, L 2710, F 121, S 8,H PO 30184, I/A 18 ( 5.02.19).
04 de Febrero de 2019Reelecciones. Auditor: GALICONTROL SL. Datos registrales. T 2710, L 2710, F 121, S 8, H PO 30184, I/A 17 (24.01.19).
29 de Octubre de 2018Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 16.629,60 Euros. Resultante Suscrito: 1.314.570,40 Euros. Datos registrales. T 2710, L2710, F 120, S 8, H PO 30184, I/A 16 (19.10.18).
12 de Febrero de 2016Reelecciones. Auditor: GALICONTROL SA. Datos registrales. T 2710, L 2710, F 120, S 8, H PO 30184, I/A 15 ( 4.02.16).
11 de Junio de 2015Cancelaciones de oficio de nombramientos. Adm. Unico: IGLESIAS LOUREIRO BEATRIZ. Nombramientos. Adm. Unico:IGLESIAS LOUREIRO BEATRIZ. Datos registrales. T 2710, L 2710, F 120, S 8, H PO 30184, I/A 14 ( 1.06.15).
23 de Mayo de 2013Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 332.800,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.331.200,00 Euros. Datos registrales. T 2710, L2710, F 119, S 8, H PO 30184, I/A 13 (14.05.13).
18 de Febrero de 2013Reelecciones. Auditor: GALICONTROL SA. Datos registrales. T 2710, L 2710, F 119, S 8, H PO 30184, I/A 12 ( 8.02.13).
01 de Septiembre de 2011Nombramientos. Apoderado: DOCAMPO BUGALLO JOSE LUIS. Datos registrales. T 2710, L 2710, F 119, S 8, H PO 30184, I/A 11(22.08.11).
09 de Febrero de 2010Reelecciones. Auditor: GALICONTROL SA. Datos registrales. T 2710, L 2710, F 119, S 8, H PO 30184, I/A 10 (28.01.10).
08 de Septiembre de 2009Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: DOCAMPO BUGALLO JOSE LUIS. Nombramientos. Adm. Unico: IGLESIAS LOUREIROBEATRIZ. Datos registrales. T 2710, L 2710, F 117, S 8, H PO 30184, I/A 8 (27.08.09).
Nombramientos. Apoderado: DOCAMPO BUGALLO JOSE LUIS. Datos registrales. T 2710, L 2710, F 118, S 8, H PO 30184, I/A 9(27.08.09).