Buscador CIF Logo

Actos BORME Residencia Reyes De Aragon Sociedad Limitada

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Residencia Reyes De Aragon Sociedad Limitada

Actos BORME Residencia Reyes De Aragon Sociedad Limitada - B99362311

Tenemos registrados 20 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Residencia Reyes De Aragon Sociedad Limitada con CIF B99362311

馃敊 Perfil de Residencia Reyes De Aragon Sociedad Limitada
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Residencia Reyes De Aragon Sociedad Limitada

05 de Abril de 2023
Nombramientos. Apo.Sol.: BARCELO MAZARRON LUIS;VALCANERAS DE RODA IGNACIO;MORENO AYMI ENRIQUE;SERRANOBARRIO FERNANDO. Apo.Manc.: NAUDE HURTADO SUSANA;SERRANO BARRIO FERNANDO. Apo.Sol.: DUO DELGADO JOSELUIS;DOMINGUEZ SANTA MARIA FABIAN;ORTEGA COBO LUIS ANTONIO;CANTERO FRESNEDA CRISTINA;VICARIO LA CALLEALFONSO MARIA. Datos registrales. T 35352 , F 224, S 8, H M 635512, I/A 14 (29.03.23).

01 de Marzo de 2023
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 35352 , F 224, S 8, H M 635512, I/A 13 (22.02.23).

19 de Enero de 2023
Ceses/Dimisiones. Consejero: MESNARD SEBASTIAN;BATTESTI LOIC DOMINIQUE;CHARRIER PHILIPPE JEAN PIERRE.Presidente: CHARRIER PHILIPPE JEAN PIERRE. VsecrNoConsj: TARDIN SANCHEZ CAROLINA. Revocaciones. Apo.Man.Soli:MESNARD SEBASTIEN. Nombramientos. VsecrNoConsj: VICARIO LA CALLE LA CALLE ALFONSO MARIA. Consejero: GUILLOTLAURENT;GIACCARDO BERENGERE;LEMAIRE LAURENT. Presidente: GUILLOT LAURENT. Apoderado: GUILLOTLAURENT;GIACCARDO BERENGERE;LEMAIRE LAURENT;AZNAR AZNAR MANUEL;ZARAGOZA LLIRINOS ASUNCION. Datosregistrales. T 35352 , F 222, S 8, H M 635512, I/A 12 (12.01.23).

06 de Junio de 2022
Ceses/Dimisiones. Consejero: LE MASNE YVES. Presidente: LE MASNE YVES. Nombramientos. Consejero: CHARRIERPHILIPPE JEAN PIERRE. Presidente: CHARRIER PHILIPPE JEAN PIERRE. Datos registrales. T 35352 , F 221, S 8, H M 635512,I/A 11 (30.05.22).

23 de Junio de 2021
Revocaciones. Apoderado: BRDENK JEAN CLAUDE. Apo.Man.Soli: BRDENK JEAN CLAUDE. Datos registrales. T 35352 , F 221,S 8, H M 635512, I/A 10 (16.06.21).

05 de Marzo de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: ORPEA IBERICA SAU. Vicepresid.: ORPEA IBERICA SAU. Consejero: BRDENK JEAN CLAUDE.Nombramientos. Consejero: MESNARD SEBASTIAN;BATTESTI LOIC DOMINIQUE. Datos registrales. T 35352 , F 221, S 8, H M635512, I/A 9 (26.02.21).

06 de Febrero de 2020
Cambio de domicilio social. PASEO DEL GENERAL MARTINEZ CAMPOS 46 7潞 (MADRID). Datos registrales. T 35352 , F 221, S8, H M 635512, I/A 8 (30.01.20).

20 de Abril de 2017
Cambio de domicilio social. C/ MIGUEL ANGEL 23 6陋 (MADRID). Datos registrales. T 35352 , F 220, S 8, H M 635512, I/A 7(11.04.17).

02 de Marzo de 2017
Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 35352 , F 219, S 8, H M 635512, I/A 5 (22.02.17).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: BRDENK JEAN CLAUDE;MESNARD SEBASTIEN. Datos registrales. T 35352 , F 219, S 8, H M635512, I/A 6 (23.02.17).

17 de Febrero de 2017
Cambio de domicilio social. C/ MONTE ESQUINZA NUMERO 30, 7潞 IZQUIERDA (MADRID). Datos registrales. T 35352 , F 217, S8, H M 635512, I/A 2 ( 9.02.17).

Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: ORPEA IBERICA SA. Datos registrales. T 35352 , F 217, S 8, H M 635512, I/A 3 (9.02.17).

Nombramientos. Apoderado: AZNAR AZNAR MANUEL;BRDENK JEAN CLAUDE;ZARAGOZA LLIRINOS ASUNCION. Datosregistrales. T 35352 , F 217, S 8, H M 635512, I/A 4 ( 9.02.17).

30 de Enero de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: PEREZ PE脩A RAFAEL MARTIN;SOLORZANO GALLO FRANCISCO JOSE;GOROSTIAGABASTERRA ANGEL RAMON;IMAZ BORDE JUAN JOSE;ESPINA GAYUBO FRANCISCO JAVIER;LANDETA LEKONA IRATXE.Presidente: ESPINA GAYUBO FRANCISCO JAVIER. Secretario: IMAZ BORDE JUAN JOSE. Revocaciones. Apoderado: IMAZ

31 de Agosto de 2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: AZAOLA ONAINDIA GABIREL. Cons.Del.Sol: SOLORZANO GALLO FRANCISCOJOSE;GOROSTIAGA BASTERRA ANGEL RAMON. Presidente: PEREZ PE脩A RAFAEL MARTIN. Secretario: AZAOLA ONAINDIAGABIREL. Nombramientos. Consejero: ESPINA GAYUBO FRANCISCO JAVIER;LANDETA LEKONA IRATXE. Presidente: ESPINAGAYUBO FRANCISCO JAVIER. Secretario: IMAZ BORDE JUAN JOSE. Datos registrales. T 3951 , F 148, S 8, H Z 54370, I/A 5(18.08.16).

Nombramientos. Apo.Manc.: IMAZ BORDE JUAN JOSE;SOLORZANO GALLO FRANCISCO JOSE. Datos registrales. T 3951 , F148, S 8, H Z 54370, I/A 6 (18.08.16).

18 de Febrero de 2013
Nombramientos. Apoderado: IMAZ BORDE JUAN JOSE. Datos registrales. T 3951 , F 147, S 8, H Z 54370, I/A 3 ( 8.02.13).

Nombramientos. Apoderado: LOPEZ GONZALEZ MARIA SONIA. Datos registrales. T 3951 , F 148, S 8, H Z 54370, I/A 4 (8.02.13).

01 de Febrero de 2013
Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 14.12.12. Objeto social: El cuidado, asistencia, rehabilitaci贸n, inserci贸n social,acompa帽amiento ytratamiento de todo tipo a personas de tercera edad, o cualquier otra con alguna carencia, enfermedad o minusval铆aen el Centro Residencia Reyes de Arag贸n o bien mediante asistencia a domiciliaria. Domicilio: C/ SAN JUAN DE LA CRUZ 22 - C.P.50.006 (ZARAGOZA). Capital: 3.000,00 Euros. Nombramientos. Consejero: PEREZ PE脩A RAFAEL MARTIN. Presidente: PEREZPE脩A RAFAEL MARTIN. Consejero: AZAOLA ONAINDIA GABIREL. Secretario: AZAOLA ONAINDIA GABIREL. Consejero:SOLORZANO GALLO FRANCISCO JOSE;GOROSTIAGA BASTERRA ANGEL RAMON;IMAZ BORDE JUAN JOSE. Datosregistrales. T 3951 , F 145, S 8, H Z 54370, I/A 1 (25.01.13).

Nombramientos. Cons.Del.Sol: SOLORZANO GALLO FRANCISCO JOSE;GOROSTIAGA BASTERRA ANGEL RAMON. Datosregistrales. T 3951 , F 147, S 8, H Z 54370, I/A 2 (25.01.13).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n