Actos BORME de Residencias De Castilla 2002 Sl
10 de Octubre de 2023Modificaci贸n de poderes. Apo.Sol.: SCHULLER DE SANTOS DAVID CARLOS. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 159, S 8, HPO 58865, I/A 59 ( 2.10.23).
29 de Septiembre de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: RODRIGUEZ VAZQUEZ JUAN CARLOS. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 158, S 8, H PO 58865,I/A 58 (21.09.23).
04 de Agosto de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ LORENZO DIEGO;ROJAS RODRIGUEZ VICTORIA;SARMINI SAINZALBERTO;FERNANDEZ MIGUELEZ PEDRO;VILLAVERDE MARTINEZ ANA ISABEL;VICENTE ARCOS MARIA CARMEN;SOLLATORRES JOSE MANUEL;BRAVO ARAGON PEDRO;RECUENCO COTILLAS PILAR;ALZAMORA CA脩ERO ELENA;SARRATOMARTINEZ FRANCISCO JAVIER;REYES PONCE MONICA;RODRIGUEZ IGLESIAS JOSE LUIS. Datos registrales. T 4204, L 4204,F 158, S 8, H PO 58865, I/A 57 (26.07.23).
28 de Julio de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: MARTIN GARCIA ELENA. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 158, S 8, H PO 58865, I/A 56 (20.07.23).
24 de Julio de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: MONTERO QUINTELA SANDRA;TAUSTE BAUTISTA HUGO;LAGUNA VALENZUELA MARIA CRISTINA.Datos registrales. T 4204, L 4204, F 157, S 8, H PO 58865, I/A 55 (13.07.23).
02 de Junio de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: SCHULLER DE SANTOS DAVID CARLOS. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 155, S 8, H PO 58865,I/A 52 (22.05.23).
30 de Mayo de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: RUBIO PERIA脩EZ MARIA TERESA. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 155, S 8, H PO 58865, I/A 51(19.05.23).
23 de Mayo de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: TARDIN SANCHEZ CAROLINA. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 154, S 8, H PO 58865, I/A 49(15.05.23).
21 de Noviembre de 2022Revocaciones. Apoderado: FERRA GUILLEN MARIO-JOSE;FERRA GUILLEN MARIO-JOSE. Datos registrales. T 4204, L 4204, F154, S 8, H PO 58865, I/A 48 (14.11.22).
07 de Noviembre de 2022Revocaciones. Apoderado: CUETO FAUS JOSE LUIS. Apo.Sol.: CUETO FAUS JOSE LUIS;CUETO FAUS JOSE LUIS. Datosregistrales. T 4204, L 4204, F 154, S 8, H PO 58865, I/A 47 (27.10.22).
03 de Agosto de 2022Revocaciones. Apoderado: SOLER VICENS ANTONI;SOLER VICENS ANTONI. Apo.Sol.: SOLER VICENS ANTONI;SOLER VICENSANTONI. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 154, S 8, H PO 58865, I/A 46 (26.07.22).
19 de Enero de 2022Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: FERNANDEZ MIGUELEZ JOSEFA ISABEL. Nombramientos. Adm. Unico: GERIAVI SA. Datosregistrales. T 4204, L 4204, F 154, S 8, H PO 58865, I/A 45 (10.01.22).
04 de Noviembre de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: GUERRA FAGALDE LORENZO. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 153, S 8, H PO 58865, I/A 44(26.10.21).
03 de Noviembre de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: GUERRA FAGALDE LORENZO. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 151, S 8, H PO 58865, I/A 43(22.10.21).
26 de Octubre de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: CALVO DIEGUEZ MONICA. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 151, S 8, H PO 58865, I/A 42(15.10.21).
21 de Octubre de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: CUETO FAUS JOSE LUIS. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 150, S 8, H PO 58865, I/A 41(13.10.21).
19 de Octubre de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: CUETO FAUS JOSE LUIS. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 150, S 8, H PO 58865, I/A 40 ( 7.10.21).
07 de Junio de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: EIXERES RAMBLA RAQUEL. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 150, S 8, H PO 58865, I/A 39(27.05.21).
06 de Mayo de 2021Revocaciones. Apoderado: MORENO RODRIGUEZ DE GUZMAN SANDRA. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 150, S 8, H PO58865, I/A 38 (26.04.21).
07 de Abril de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: NU脩EZ GRANADOS BLANCA. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 149, S 8, H PO 58865, I/A 37(26.03.21).
07 de Agosto de 2020Nombramientos. Apoderado: FERRA GUILLEN MARIO-JOSE. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 149, S 8, H PO 58865, I/A 36(31.07.20).
26 de Junio de 2020Nombramientos. Apoderado: MORENO RODRIGUEZ DE GUZMAN SANDRA. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 149, S 8, H PO58865, I/A 35 (22.06.20).
24 de Junio de 2020Nombramientos. Apoderado: MARIN SORRIBES ANA. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 149, S 8, H PO 58865, I/A 34(18.06.20).
13 de Abril de 2020Revocaciones. Apo.Sol.: ORTS SAN JOSE ALFREDO. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 149, S 8, H PO 58865, I/A 33 (3.04.20).
23 de Octubre de 2019Revocaciones. Apo.Sol.: PRIEGO DEL RIO SANDRA. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 149, S 8, H PO 58865, I/A 32(15.10.19).
27 de Mayo de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: TABOADA FERNANDEZ MARIA. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 148, S 8, H PO 58865, I/A 31(16.05.19).
13 de Mayo de 2019Revocaciones. Apoderado: ESPIN FORJAN ANA. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 148, S 8, H PO 58865, I/A 30 ( 7.05.19).
16 de Noviembre de 2018Revocaciones. Apoderado: PENAS GARCIA MARIA JESUS. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 147, S 8, H PO 58865, I/A 28 (9.11.18).
Nombramientos. Apo.Sol.: SOLER VICENS ANTONI. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 147, S 8, H PO 58865, I/A 29 (12.11.18).
24 de Julio de 2018Nombramientos. Apoderado: LOPESINO SOUSA AGUSTIN MODESTO. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 146, S 8, H PO58865, I/A 27 (17.07.18).
02 de Julio de 2018Nombramientos. Apoderado: CUETO FAUS JOSE LUIS. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 146, S 8, H PO 58865, I/A 26(26.06.18).
12 de Junio de 2018Revocaciones. Apo.Sol.: RODRIGUEZ MARTINEZ ISABEL. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 146, S 8, H PO 58865, I/A 25 (6.06.18).
16 de Marzo de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: HUERTAS FERNANDEZ CELIA. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 145, S 8, H PO 58865, I/A 24 (9.03.18).
12 de Marzo de 2018Revocaciones. Apoderado: GALLOFRE PASCUAL ROMAN. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 145, S 8, H PO 58865, I/A 23 (2.03.18).
19 de Febrero de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: ROMERO VAN DER SCHOOT MANUEL. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 144, S 8, H PO 58865,I/A 20 (12.02.18).
Nombramientos. Apo.Sol.: ORTS SAN JOSE ALFREDO. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 145, S 8, H PO 58865, I/A 21(12.02.18).
Nombramientos. Apo.Sol.: GUTIERREZ HERREROS ARANTZAZU. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 145, S 8, H PO 58865, I/A22 (12.02.18).
16 de Febrero de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: SOLER VICENS ANTONI. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 144, S 8, H PO 58865, I/A 19 ( 9.02.18).
04 de Septiembre de 2017Nombramientos. Apoderado: SOLER VICENS ANTONI. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 143, S 8, H PO 58865, I/A 18(25.08.17).
30 de Agosto de 2017Nombramientos. Apoderado: VILLAVERDE MARTINEZ ANA. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 142, S 8, H PO 58865, I/A 15(23.08.17).
Nombramientos. Apoderado: RUBIO VALOR PABLO. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 142, S 8, H PO 58865, I/A 16 (23.08.17).
Nombramientos. Apoderado: ROJAS RODRIGUEZ VICTORIA. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 143, S 8, H PO 58865, I/A 17(23.08.17).
22 de Agosto de 2017Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: GERIAVI SA. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 142, S 8, H PO58865, I/A 14 (11.08.17).
28 de Julio de 2017Nombramientos. Apoderado: ESPIN FORJAN ANA. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 141, S 8, H PO 58865, I/A 11 (20.07.17).
Nombramientos. Apo.Sol.: DURAN MARI脩O MARIA;DEL CAMPO REDONDO LUCIA;MELON CASTRO MARIA JOSE. Datosregistrales. T 4204, L 4204, F 141, S 8, H PO 58865, I/A 12 (24.07.17).
Nombramientos. Apo.Sol.: PALENZUELA FERNANDEZ JAVIER;PITEL MENDEZ MARIA EUGENIA;RODRIGUEZ MARTINEZISABEL;PRIEGO DEL RIO SANDRA. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 142, S 8, H PO 58865, I/A 13 (24.07.17).
26 de Julio de 2017Nombramientos. Apoderado: JIMENEZ CALAVIA JAVIER. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 141, S 8, H PO 58865, I/A 10(19.07.17).
25 de Julio de 2017Nombramientos. Apoderado: SOLER VICENS ANTONI. Datos registrales. T 4060, L 4060, F 48, S 8, H PO 58865, I/A 9 (18.07.17).
26 de Junio de 2017Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ GARCIA ANTONIO. Datos registrales. T 4060, L 4060, F 47, S 8, H PO 58865, I/A 7(16.06.17).
Nombramientos. Apoderado: FERRA GUILLEN MARIO-JOSE. Datos registrales. T 4060, L 4060, F 48, S 8, H PO 58865, I/A 8(19.06.17).
23 de Junio de 2017Nombramientos. Apoderado: GALLOFRE PASCUAL ROMAN. Datos registrales. T 4060, L 4060, F 47, S 8, H PO 58865, I/A 6(15.06.17).
22 de Junio de 2017Nombramientos. Apoderado: LOPESINO SOUSA AGUSTIN. Datos registrales. T 4060, L 4060, F 46, S 8, H PO 58865, I/A 5(14.06.17).
21 de Junio de 2017Nombramientos. Apoderado: ROSELLO RIERA JOSE-LUIS. Datos registrales. T 4060, L 4060, F 43, S 8, H PO 58865, I/A 4(14.06.17).
20 de Junio de 2017Nombramientos. Apoderado: HUGUET LLULL ANDREU. Datos registrales. T 4060, L 4060, F 39, S 8, H PO 58865, I/A 3(12.06.17).
14 de Agosto de 2015Cambio de domicilio social. AVDA GARCIA BARBON 60 (VIGO). Datos registrales. T 4060, L 4060, F 35, S 8, H PO 58865, I/A 1 (6.08.15).
Otros conceptos: MODIFICADO el art铆culo 4 de los estatutos sociales correspondiente al DOMICILIO SOCIAL. Datos registrales. T4060, L 4060, F 39, S 8, H PO 58865, I/A 2 ( 6.08.15).
03 de Marzo de 2015Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: INVERSIONES SOCICARE SL. Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: LOPEZMORENO JOSE MARIA;SANTOS GONZALEZ BALTASAR. Nombramientos. Adm. Unico: FERNANDEZ MIGUELEZ JOSEFAISABEL. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores mancomunados a Administrador煤nico. Datos registrales. T 1040 , F 138, S 8, H TO 15914, I/A 4 (23.02.15).
Revocaciones. Apoderado: INFANTES LOPEZ LUIS. Nombramientos. Apoderado: PENAS GARCIA MARIA JESUS. Datosregistrales. T 1040 , F 138, S 8, H TO 15914, I/A 5 (23.02.15).
04 de Julio de 2014Nombramientos. Apoderado: INFANTES LOPEZ LUIS. Datos registrales. T 1040 , F 137, S 8, H TO 15914, I/A 3 (26.06.14).
17 de Marzo de 2011Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 9.616,00 Euros. Resultante Suscrito: 38.466,00 Euros. Ampliaci贸n de capital. Capital:9.616,00 Euros. Resultante Suscrito: 48.082,00 Euros. Datos registrales. T 1040 , F 137, S 8, H TO 15914, I/A 2 ( 7.03.11).