Actos BORME de Resinas Y Fibras De Galicia Sl
02 de Junio de 2022Fe de erratas: RECTIFICADA la escritura que caus贸 la inscripci贸n 14陋, referente a subsanar el error cometido en el orden de losapellidos de SONIA FERNANDEZ CONDE, constando equivocamente Conde Fern谩ndez, cuando lo correcto es SONIA FERNANDEZCONDE. Datos registrales. T 938 , F 49, S 8, H OR 4856, I/A 16 (25.05.22).
24 de Marzo de 2022Revocaciones. Apoderado: CUBELAS VIEITEZ LUIS. Apo.Manc.: COLMENERO VELOSO JOSE LUIS;MARTINEZ ALMEIDAJAVIER;CORTON TESOURO RUBEN. Apo.Sol.: COLMENERO VELOSO JOSE LUIS;MARTINEZ ALMEIDA JAVIER. Datosregistrales. T 359 , F 147, S 8, H OR 4856, I/A 15 (14.03.22).
02 de Marzo de 2022Ceses/Dimisiones. Secretario: GONZALEZ DONIZ RAMON FELIPE. Consejero: PEREZ MARTINEZ ELOY. Con.Delegado: PEREZMARTINEZ ELOY. Presidente: PEREZ MARTINEZ ELOY. Consejero: TERSUAL SA;SEIJAS PEREZ RAMON MARIA.Nombramientos. Adm. Unico: UNVI CARROCEROS SL. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo deadministraci贸n a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 359 , F 146, S 8, H OR 4856, I/A 12 (22.02.22).
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: UNVI CARROCEROS SL. Datos registrales. T 359 , F 147, S 8, H OR 4856, I/A 13(22.02.22).
Nombramientos. Apo.Manc.: LEGIDO MARI脩O EVA MARIA;GOMEZ COIRA ANDRES IGNACIO;PADRON CONDE JUAN CARLOS.Apo.Sol.: LEGIDO MARI脩O EVA MARIA;GOMEZ COIRA ANDRES IGNACIO;PADRON CONDE JUAN CARLOS;FERNANDEZCONDE SONIA. Datos registrales. T 359 , F 147, S 8, H OR 4856, I/A 14 (22.02.22).
20 de Julio de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: POLO ATLANTICO CONSULTORES SL;PEREZ NIETO EMILIO. Presidente: PEREZ NIETO EMILIO.Nombramientos. Presidente: PEREZ MARTINEZ ELOY. Consejero: TERSUAL SA;SEIJAS PEREZ RAMON MARIA. Datosregistrales. T 359 , F 146, S 8, H OR 4856, I/A 11 ( 1.07.21).
23 de Marzo de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: COLMENERO VELOSO JOSE LUIS;MARTINEZ ALMEIDA JAVIER. Datos registrales. T 359 , F 145, S8, H OR 4856, I/A 9 (16.03.18).
Nombramientos. Apo.Sol.: CABO PAREJO PATRICIA;CONDE GONZALEZ ANABEL. Datos registrales. T 359 , F 145, S 8, H OR4856, I/A 10 (16.03.18).
07 de Marzo de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: PEREZ RUMBAO SA. Cons.Del.Man: PEREZ NIETO EMILIO;LOPEZ PAZ RUBEN ALBERTO;PEREZMARTINEZ ELOY. Nombramientos. Consejero: PEREZ MARTINEZ ELOY. Con.Delegado: PEREZ MARTINEZ ELOY. Datosregistrales. T 359 , F 145, S 8, H OR 4856, I/A 8 (26.02.18).
01 de Febrero de 2018Nombramientos. Apo.Manc.: COLMENERO VELOSO JOSE LUIS;MARTINEZ ALMEIDA JAVIER;CORTON TESOURO RUBEN.Datos registrales. T 359 , F 145, S 8, H OR 4856, I/A 7 (23.01.18).
16 de Abril de 2010Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: CUBELAS VIEITEZ LUIS. Nombramientos. Consejero: PEREZ NIETO EMILIO. Presidente:PEREZ NIETO EMILIO. Consejero: POLO ATLANTICO CONSULTORES SL;PEREZ RUMBAO SA. Secretario: GONZALEZ DONIZRAMON FELIPE. Cons.Del.Man: PEREZ NIETO EMILIO;LOPEZ PAZ RUBEN ALBERTO;PEREZ MARTINEZ ELOY. Modificacionesestatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Consejo de administraci贸n. Datos registrales. T 359 , F143, S 8, H OR 4856, I/A 4 (23.03.10).
Nombramientos. Apoderado: CUBELAS VIEITEZ LUIS. Datos registrales. T 359 , F 145, S 8, H OR 4856, I/A 5 (23.03.10).
Nombramientos. Apoderado: GOMEZ COIRA ANDRES IGNACIO. Datos registrales. T 359 , F 144, S 8, H OR 4856, I/A 6(23.03.10).