Buscador CIF Logo

Actos BORME Resnova Sociedad Limitada

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Resnova Sociedad Limitada

Actos BORME Resnova Sociedad Limitada - B24073223

Tenemos registrados 29 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Resnova Sociedad Limitada con CIF B24073223

馃敊 Perfil de Resnova Sociedad Limitada
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Resnova Sociedad Limitada

28 de Diciembre de 2022
Ampliaci贸n de capital. Capital: 172.489,87 Euros. Resultante Suscrito: 1.646.767,40 Euros. Datos registrales. T 25980 , F 211, S 8,H M 48977, I/A 61 (20.12.22).

09 de Diciembre de 2022
Revocaciones. Apoderado: RODRIGUEZ RUIZ JULIA. Datos registrales. T 25980 , F 211, S 8, H M 48977, I/A 60 (30.11.22).

12 de Septiembre de 2022
Nombramientos. Apo.Manc.: GARCIA BANIELLO IRMA;MENENDEZ VELASCO CONCEPCION;TADEO GARCIA SARA. Datosregistrales. T 25980 , F 210, S 8, H M 48977, I/A 59 ( 5.09.22).

27 de Diciembre de 2021
Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DEL ARTICULO 24潞 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Cambio de objeto social.La actividad propia de una sociedad cabecera, matriz o dominante de un grupo de sociedades. - La compra y venta de sociedadesmercantiles o empresas individuales, as铆 como de sus bienes, inmuebles y semovientes, la mediaci贸n de cualquier tipo en lasmencionadas operaciones, ... Datos registrales. T 25980 , F 209, S 8, H M 48977, I/A 58 (20.12.21).

14 de Diciembre de 2021
Nombramientos. Apoderado: PEREZ GONZALEZ EDUARDO. Datos registrales. T 25980 , F 209, S 8, H M 48977, I/A 57 (3.12.21).

15 de Marzo de 2021
Nombramientos. Auditor: CENTIUM AUDITORES SL. Aud.C.Con.: CENTIUM AUDITORES SL. Datos registrales. T 25980 , F 209,S 8, H M 48977, I/A 56 ( 8.03.21).

04 de Junio de 2020
Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ CUERVO MANUEL. Datos registrales. T 25980 , F 208, S 8, H M 48977, I/A 55 (27.05.20).

02 de Junio de 2020
Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ RUIZ JULIA. Datos registrales. T 25980 , F 208, S 8, H M 48977, I/A 53 (27.05.20).

Revocaciones. Apoderado: SUAREZ FERNANDEZ SANTIAGO;MARTINEZ CUERVO ALFREDO. Datos registrales. T 25980 , F208, S 8, H M 48977, I/A 54 (27.05.20).

23 de Marzo de 2020
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: MARTINEZ CUERVO ALFREDO;MARTINEZ ALONSO ROSA;MARTINEZ ALONSO ALBERTO.Nombramientos. Consejero: MARTINEZ ALONSO ALFREDO;MARTINEZ ALONSO ROSA;MARTINEZ ALONSO ALBERTO.Presidente: MARTINEZ ALONSO ALFREDO. Vicepresid.: MARTINEZ ALONSO ROSA. Secretario: MARTINEZ ALONSO ALBERTO.Con.Delegado: MARTINEZ ALONSO ALFREDO;MARTINEZ ALONSO ROSA;MARTINEZ ALONSO PURIFICACION. Consejero:MARTINEZ ALONSO PURIFICACION. Con.Delegado: MARTINEZ ALONSO ALBERTO. Modificaciones estatutarias. Modificaci贸nde los art铆culos 16 y 17 de los estatutos sociales.. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico aConsejo de administraci贸n. Datos registrales. T 25980 , F 206, S 8, H M 48977, I/A 52 (16.03.20).

19 de Enero de 2018
Nombramientos. Auditor: CENTIUM AUDITORES SL. Reelecciones. Auditor: CENTIUM AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA.Datos registrales. T 25980 , F 206, S 8, H M 48977, I/A 51 (11.01.18).

08 de Marzo de 2016
Nombramientos. Apo.Manc.: CARRAGAL MARTINEZ MARIA-ISABEL. Datos registrales. T 25980 , F 206, S 8, H M 48977, I/A 50(29.02.16).

03 de Febrero de 2016
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: MARTINEZ CUERVO ALFREDO;ALONSO GARCIA MARIA PURIFICACION. Nombramientos.Adm. Solid.: MARTINEZ CUERVO ALFREDO;MARTINEZ ALONSO ROSA;MARTINEZ ALONSO ALBERTO. Datos registrales. T25980 , F 205, S 8, H M 48977, I/A 49 (26.01.16).

11 de Febrero de 2015
Nombramientos. Auditor: CENTIUM AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 25980 , F 205, S 8, H M 48977, I/A48 ( 3.02.15).

05 de Junio de 2014
Nombramientos. Apo.Sol.: PEREZ GONZALEZ EDUARDO. Datos registrales. T 25980 , F 205, S 8, H M 48977, I/A 47 (28.05.14).

31 de Enero de 2014
Reelecciones. Auditor: MAZARS AUDITORES SLP. Aud.C.Con.: MAZARS AUDITORES SLP. Datos registrales. T 25980 , F 204, S8, H M 48977, I/A 46 (22.01.14).

04 de Marzo de 2013
Reelecciones. Auditor: MAZARS AUDITORES SLP. Aud.C.Con.: MAZARS AUDITORES SLP. Datos registrales. T 25980 , F 204, S8, H M 48977, I/A 45 (21.02.13).

13 de Febrero de 2013
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 461.575,68 Euros. Resultante Suscrito: 1.474.277,53 Euros. Modificaciones estatutarias.Art铆culo de los estatutos: 5. Capital.-. Datos registrales. T 25980 , F 203, S 8, H M 48977, I/A 44 ( 5.02.13).

03 de Octubre de 2012
Modificaciones estatutarias. MODIFICADO EL ARTICULO 24潞 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.. Datos registrales. T 25980 , F203, S 8, H M 48977, I/A 43 (21.09.12).

06 de Febrero de 2012
Revocaciones. Apoderado: REGADERA RODRIGUEZ JUAN PABLO;DE LA FUENTE GARCIA COVADONGA. Datos registrales. T25980 , F 203, S 8, H M 48977, I/A 42 (24.01.12).

24 de Enero de 2012
Reelecciones. Auditor: MAZARS AUDITORES SL. Aud.C.Con.: MAZARS AUDITORES SL. Datos registrales. T 25980 , F 201, S 8,H M 48977, I/A 41 (11.01.12).

20 de Enero de 2012
Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ ALONSO ALBERTO. Datos registrales. T 25980 , F 200, S 8, H M 48977, I/A 38(10.01.12).

Nombramientos. Apoderado: CABIELLES ONDINA CRISTINA;DE LA FUENTE GARCIA COVADONGA. Datos registrales. T 25980, F 201, S 8, H M 48977, I/A 39 (10.01.12).

Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ ALONSO ROSA. Datos registrales. T 25980 , F 201, S 8, H M 48977, I/A 40 (11.01.12).

28 de Noviembre de 2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTINEZ CUERVO ALFREDO;ALONSO GARCIA MARIA PURIFICACION;MARTINEZ ALONSOMARIA PURIFICACION;MARTINEZ ALONSO ALFREDO;MARTINEZ ALONSO ROSA;MARTINEZ ALONSO ALBERTOPresidente:MARTINEZ CUERVO ALFREDO. Vicepresid.: ALONSO GARCIA MARIA PURIFICACION. Con.Delegado: MARTINEZ ALONSOMARIA PURIFICACION;MARTINEZ CUERVO ALFREDO;MARTINEZ ALONSO ROSA.Secretario: REGADERA RODRIGUEZ JUANPABLO. Nombramientos. Adm. Solid.: MARTINEZ CUERVO ALFREDO;ALONSO GARCIA MARIA PURIFICACION.Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Datosregistrales. T 25980 , F 200, S 8, H M 48977, I/A 37 (17.11.11).

28 de Enero de 2011
Reelecciones. Aud.C.Con.: MAZARS AUDITORES SL. Auditor: MAZARS AUDITORES SL. Datos registrales. T 25980 , F 200, S 8,H M 48977, I/A 36 (18.01.11).

22 de Septiembre de 2010
Modificaciones estatutarias. MODIFICADO EL ARTICULO 7 DE LOS ESTATUTOS REALTIVO A LA TRANSMISION DEPARTICIPACIONES.. Datos registrales. T 25980 , F 200, S 8, H M 48977, I/A 35 ( 9.09.10).

18 de Enero de 2010
Reelecciones. Aud.C.Con.: MAZARS AUDITORES SL. Auditor: MAZARS AUDITORES SL. Datos registrales. T 16257 , F 19, S 8, HM 48977, I/A 34 ( 4.01.10).

13 de Enero de 2009
Reelecciones. Auditor: MAZARS AUDITORES SL. Aud.C.Con.: MAZARS AUDITORES SL. Datos registrales. T 16257 , F 19, S 8, HM 48977, I/A 33 (29.12.08).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n