Buscador CIF Logo

Actos BORME Resona Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Resona Sa

Actos BORME Resona Sa - A78795952

Tenemos registrados 26 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Resona Sa con CIF A78795952

馃敊 Perfil de Resona Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Resona Sa

07 de Noviembre de 2023
Nombramientos. Apoderado: DE PORRES ORTIZ DE URBINA ENRIQUE;RODRIGUEZ-VILLA MATONS ANDRES;CABALLEROCABALLERO MARIANO;GARCIA CALLE LAURA;RAZQUIN ILLARRAMENDI PEDRO;HERNANDEZ MORENO-VENTAS RAUL.Datos registrales. T 31808 , F 114, S 8, H M 140821, I/A 32 (30.10.23).

10 de Marzo de 2023
Modificaciones estatutarias. Aprobaci贸n de un nuevo Texto de los Estatutos Sociales.-. Datos registrales. T 31808 , F 110, S 8, HM 140821, I/A 31 ( 3.03.23).

11 de Enero de 2023
Revocaciones. Apoderado: ALCALDE GOMEZ MARIA DOLORES;IVORRA MIRALLES FRANCISCO;DE PORRES ORTIZ DEURBINA ENRIQUE;GARCIA-LEGAZ RUIZ BENITO;CABALLERO CABALLERO MARIANO;LOPEZ JERICO FRANCISCOJAVIER;RODRIGUEZ VILLA MATONS ANDRES;ALCALDE GOMEZ MARIA DOLORES. Datos registrales. T 31808 , F 109, S 8, H M140821, I/A 30 ( 3.01.23).

28 de Junio de 2022
Nombramientos. Apo.Man.Soli: IVORRA MIRALLES FRANCISCO;RAZQUIN ILLARRAMENDI PEDRO;DE PORRES ORTIZ DEURBINA ENRIQUE;CABALLERO CABALLERO MARIANO. Datos registrales. T 31808 , F 107, S 8, H M 140821, I/A 28 (21.06.22).

Revocaciones. Apoderado: SORIA FERNANDEZ DE CORDOBA MANUEL;SORIA FERNANDEZ DE CORDOBA MANUEL. Datosregistrales. T 31808 , F 109, S 8, H M 140821, I/A 29 (21.06.22).

08 de Marzo de 2022
Ceses/Dimisiones. Consejero: SORIA FERNANDEZ DE CORDOBA MANUEL. Datos registrales. T 31808 , F 107, S 8, H M140821, I/A 27 ( 1.03.22).

29 de Julio de 2021
Reelecciones. Consejero: IVORRA MIRALLES FRANCISCO. Presidente: IVORRA MIRALLES FRANCISCO. Consejero: DEPORRES ORTIZ DE URBINA ENRIQUE;SORIA FERNANDEZ DE CORDOBA MANUEL;MAYERO FRANCO LUIS. SecreNoConsj:CABALLERO CABALLERO MARIANO. Datos registrales. T 31808 , F 106, S 8, H M 140821, I/A 26 (22.07.21).

22 de Abril de 2021
Nombramientos. Apoderado: RAZQUIN ILLARRAMENDI PEDRO;DE PORRES ORTIZ DE URBINA ENRIQUE;CABALLEROCABALLERO MARIANO;ALCALDE GOMEZ MARIA DOLORES. Datos registrales. T 31808 , F 104, S 8, H M 140821, I/A 25(15.04.21).

12 de Abril de 2021
Fe de erratas: Se public贸 por error en la inscripci贸n 24陋 la revocacion de 4 apoderados de la inscripci贸n 14陋 que deben quedarvigentes. Datos registrales. T 31808 , F 103, S 8, H M 140821, I/A 24 ( 3.11.20).

11 de Noviembre de 2020
Revocaciones. Apoderado: ALCALDE GOMEZ MARIA DOLORES;SORIA FERNANDEZ DE CORDOBA MANUEL;CABALLEROCABALLERO MARIANO;RODRIGUEZ VILLA MATONS ANDRES. Nombramientos. Apoderado: SORIA FERNANDEZ DECORDOBA MANUEL;RODRIGUEZ-VILLA MATONS ANDRES;CABALLERO CABALLERO MARIANO;ALCALDE GOMEZ MARIADOLORES;DELGADO SORIA MARIO. Datos registrales. T 31808 , F 103, S 8, H M 140821, I/A 24 ( 3.11.20).

03 de Julio de 2020
Nombramientos. Apoderado: RIVERA GONZALEZ JOSE MARTIN. Datos registrales. T 31808 , F 102, S 8, H M 140821, I/A 23(26.06.20).

21 de Mayo de 2019
Nombramientos. Apoderado: LORENZO PRADA JOSE MARIA. Datos registrales. T 31808 , F 102, S 8, H M 140821, I/A 22(13.05.19).

14 de Marzo de 2019
Revocaciones. Apoderado: GUISADO Y DEL TORO JOSE CARLOS. Datos registrales. T 31808 , F 102, S 8, H M 140821, I/A 21 (7.03.19).

03 de Mayo de 2018
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: HOSPITAL MONCLOA GRUPO HLA SA. Datos registrales. T31808 , F 101, S 8, H M 140821, I/A 20 (24.04.18).

17 de Noviembre de 2017
Revocaciones. Apoderado: NAVARRO MERINO LUIS;NAVARRO MERINO LUIS;TIRADO GUALLART JESUS. Datos registrales. T31808 , F 101, S 8, H M 140821, I/A 19 ( 8.11.17).

24 de Noviembre de 2016
Nombramientos. Apoderado: RIVERA GONZALEZ MARTIN. Datos registrales. T 31808 , F 101, S 8, H M 140821, I/A 18(16.11.16).

05 de Agosto de 2016
Reelecciones. SecreNoConsj: CABALLERO CABALLERO MARIANO. Consejero: IVORRA MIRALLES FRANCISCO. Presidente:IVORRA MIRALLES FRANCISCO. Consejero: DE PORRES ORTIZ DE URBINA ENRIQUE;SORIA FERNANDEZ DE CORDOBAMANUEL;MAYERO FRANCO LUIS. Datos registrales. T 31808 , F 101, S 8, H M 140821, I/A 17 (28.07.16).

17 de Junio de 2014
Cambio de objeto social. LA ORGANIZACION,DIRECCION, GESTION E INTERMEDIACION PARA LA PRESTACION DESERVICIOS SANITARIOS DE RADIODIAGNOSTICO,MEDIANTE LA REALIZACION DE PRUEBAS DIAGNOSTICAS DERADIOLOGIA Y EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS. LA CONSTRUCCION, ADQUISICION, ARRENDAMIENTO,INSTALACION Y EXPLOTACION DE CENTROS CLINICOS. Datos registrales. T 31808 , F 100, S 8, H M 140821, I/A 16 ( 9.06.14).

02 de Abril de 2014
Cambio de domicilio social. C/ JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 12 (MADRID). Datos registrales. T 31808 , F 100, S 8, H M140821, I/A 15 (25.03.14).

17 de Febrero de 2014
Revocaciones. Apoderado: DIEZ PASO TOMAS. Nombramientos. Apoderado: ALCALDE GOMEZ MARIA DOLORES;IVORRAMIRALLES FRANCISCO;DE PORRES ORTIZ DE URBINA ENRIQUE;SORIA FERNANDEZ DE CORDOBA MANUEL;GARCIA-LEGAZRUIZ BENITO;CABALLERO CABALLERO MARIANO;LOPEZ JERICO FRANCISCO JAVIER;NAVARRO MERINO LUIS;RODRIGUEZVILLA MATONS ANDRES;TIRADO GUALLART JESUS. Datos registrales. T 8752 , F 43, S 8, H M 140821, I/A 14 ( 6.02.14).

02 de Noviembre de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: MADRIGAL PARRILLA JUAN ANTONIO;SANCHEZ ALVAREZ PEDROSA CESAR;DIEZ PASOTOMAS;GUISADO Y DEL TORO JOSE CARLOS. Vicepresid.: SANCHEZ ALVAREZ PEDROSA CESAR. Nombramientos.SecreNoConsj: CABALLERO CABALLERO MARIANO. Consejero: DE PORRES ORTIZ DE URBINA ENRIQUE;SORIA FERNANDEZDE CORDOBA MANUEL;MAYERO FRANCO LUIS. Fe de erratas: SE PUBLICO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 10 LAREELECCION DE CONSEJEROSSE OMITIO POR ERROR EN LA INSCRIP. 10 EL NOMBRAMIENTO DE CONSEJEROSSIENDOLO CORRECTO:VOCALES D.ENRIQUE DE PORRES ORTIZ DE URBINA,D.MANUEL SORIA FERNANDEZ DECORDOBA,D.LUIS MAYERO FRANCO Y D.FRANCISCO IVORRA MIRALLES, PRESIDENTE D.FRANCISCO IVORRA MIRALLES YSECRETARIO D.MARIANO CABALLERO CABALLERO. Datos registrales. T 8752 , F 40, S 8, H M 140821, I/A 10 ( 1.06.12).

24 de Octubre de 2012
Fe de erratas: SE PUBLICO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 10 LA REELECCION COMO CONSEJERO Y PRESIDENTE DEDON ANDRES RODRIGUEZ VILLA MATONS Y SE OMITIO EL NOMBRAMIENTO COMO SECRETARIO NO CONSEJERO DE DONMARIANO CABALLERO CABALLERO. Datos registrales. T 8752 , F 40, S 8, H M 140821, I/A 10 ( 1.05.12).

06 de Agosto de 2012
Nombramientos. Apoderado: NAVARRO MERINO LUIS. Datos registrales. T 8752 , F 42, S 8, H M 140821, I/A 13 (25.07.12).

21 de Junio de 2012
Nombramientos. Apoderado: DE PORRES ORTIZ DE URBINA ENRIQUE. Datos registrales. T 8752 , F 40, S 8, H M 140821, I/A12 (11.06.12).

14 de Junio de 2012
Nombramientos. Apoderado: LOPEZ JERICO FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 8752 , F 40, S 8, H M 140821, I/A 11 (4.06.12).

13 de Junio de 2012
Reelecciones. Consejero: MADRIGAL PARRILLA JUAN ANTONIO;RODRIGUEZ VILLA MATONS ANDRES;SANCHEZ ALVAREZPEDROSA CESAR;IVORRA MIRALLES FRANCISCO;DIEZ PASO TOMAS;GUISADO Y DEL TORO JOSE CARLOS. Presidente:IVORRA MIRALLES FRANCISCO. Vicepresid.: SANCHEZ ALVAREZ PEDROSA CESAR. Secretario: RODRIGUEZ VILLA MATONSANDRES. Datos registrales. T 8752 , F 40, S 8, H M 140821, I/A 10 ( 1.06.12).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n