Actos BORME de Retama Real Estate Sa
28 de Diciembre de 2023Cambio de domicilio social. C/ AMALTEA 32 - 1陋 PLANTA (MADRID). Datos registrales. T 35601 , F 91, S 8, H M 30724, I/A 116(20.12.23).
26 de Septiembre de 2023Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: COLOMER BLASCO ROBERTO. Nombramientos. Adm. Unico: MONTEIRO DO AMARAL PEDROMANUEL MEGRE. Datos registrales. T 35601 , F 91, S 8, H M 30724, I/A 115 (19.09.23).
09 de Mayo de 2023Revocaciones. Apo.Sol.: MULET SANCHEZ EMILIO JOSE. Datos registrales. T 35601 , F 90, S 8, H M 30724, I/A 114 (29.04.23).
26 de Abril de 2023Cambio de domicilio social. C/ OMBU 3 - PLANTA 5 Y 12. TORRE OMBU (MADRID). Datos registrales. T 35601 , F 90, S 8, H M30724, I/A 113 (19.04.23).
14 de Abril de 2023Nombramientos. Apoderado: LAPORTE PHILIPPE JACQUES;CORTINA ROMERO EDUARDO ISIDRO. Datos registrales. T 35601, F 90, S 8, H M 30724, I/A 112 ( 5.04.23).
13 de Diciembre de 2022Revocaciones. Apo.Sol.: PI脩OL I ARNAL JOAN. Datos registrales. T 35601 , F 90, S 8, H M 30724, I/A 111 ( 2.12.22).
04 de Agosto de 2022Nombramientos. Apo.Manc.: JARA LOPEZ RAMON;COLOMER BLASCO ROBERTO;RODRIGUEZ OLIVIER;LAPORTE PHILIPPEJACQUES;MADRAZO PORRES DANIEL;RODRIGUEZ PEQUE脩O IGNACIO;GARCIA ALCANTARA JOSEFA. Datos registrales. T35601 , F 89, S 8, H M 30724, I/A 110 (28.07.22).
28 de Diciembre de 2021Nombramientos. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 35601 , F 89, S 8, H M 30724, I/A 109 (21.12.21).
02 de Octubre de 2020Nombramientos. Rep.SUC.: ARVANITAKIS ARISTIDIS. Otros conceptos: Establecimiento de una sucursal de la sociedad enGrecia, bajo la denominaci贸n "RETAMA REAL ESTATE SA"- Datos registrales. T 35601 , F 88, S 8, H M 30724, I/A 108 (25.09.20).
20 de Julio de 2020Reelecciones. Auditor: MAZARS AUDITORES SLP. Datos registrales. T 35601 , F 87, S 8, H M 30724, I/A 107 (10.07.20).
19 de Febrero de 2020Ampliacion del objeto social. La prestaci贸n de servicios de intermediaci贸n inmobiliaria. Datos registrales. T 35601 , F 87, S 8, H M30724, I/A 106 (12.02.20).
12 de Febrero de 2020Nombramientos. Apoderado: BARRANCO CANO NOELIA;GIMENEZ JURADO ANTONIO. Datos registrales. T 35601 , F 87, S 8, HM 30724, I/A 105 ( 5.02.20).
14 de Noviembre de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: SANCHEZ RELINQUE VICTOR FRANCISCO;CEREZO ROMERO YOLANDA;RIVEIRO DIAZ MARIAENCARNACION;DEL RIO RODRIGUEZ ENRIQUE;NIETO EIRIZ MARIA;CAIRO GONZALEZ MARIA ELVIRA;VIZOSO GARCIAMARIA TERESA;VANRELL SALAS BARTOMEU JOAN;CARRETERO TORRES MAGIN. Datos registrales. T 35601 , F 86, S 8, H M30724, I/A 104 ( 7.11.19).
27 de Mayo de 2019Reelecciones. Auditor: MAZARS AUDITORES SLP. Datos registrales. T 35601 , F 86, S 8, H M 30724, I/A 103 (20.05.19).
05 de Abril de 2019Reelecciones. Adm. Unico: COLOMER BLASCO ROBERTO. Datos registrales. T 35601 , F 86, S 8, H M 30724, I/A 102 (29.03.19).
01 de Febrero de 2019Nombramientos. Apoderado: VIDARTE MOJARRO ANA. Datos registrales. T 35601 , F 85, S 8, H M 30724, I/A 101 (25.01.19).
13 de Agosto de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: AVILA PEREZ ANA ISABEL;HIDALGO MARQUEZ INMACULADA;ORTIZ COPADO MANUEL. Datosregistrales. T 35601 , F 85, S 8, H M 30724, I/A 100 ( 6.08.18).
24 de Julio de 2018Reelecciones. Auditor: MAZARS AUDITORES SLP. Datos registrales. T 35601 , F 85, S 8, H M 30724, I/A 99 (16.07.18).
08 de Mayo de 2018Nombramientos. Apoderado: RABASSA CONDE JOAN;ANTOMIL NOVOA JAVIER;ANDELO CRESPO PASCUAL MIGUEL. Datosregistrales. T 35601 , F 84, S 8, H M 30724, I/A 98 (26.04.18).
09 de Marzo de 2018Nombramientos. Apoderado: PAEZ ORDO脩EZ SERGIO;GOMEZ ARREBOLA MARIA TERESA;NORTE JIMENEZ ELVIRA;MARINMURIEN JUAN IGNACIO. Datos registrales. T 35601 , F 84, S 8, H M 30724, I/A 97 (28.02.18).
29 de Enero de 2018Nombramientos. Apoderado: GARCIA PARRA JOSE. Datos registrales. T 35601 , F 83, S 8, H M 30724, I/A 95 (22.01.18).
Nombramientos. Apoderado: ROMERO SANCHEZ MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 35601 , F 84, S 8, H M 30724, I/A 96(22.01.18).
17 de Enero de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: BARRANCO CANO NOELIA;GIMENEZ JURADO ANTONIO. Datos registrales. T 35601 , F 83, S 8, H M30724, I/A 94 ( 8.01.17).
16 de Enero de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: ROBLES MELGOSA MARIA BEGO脩A. Datos registrales. T 35601 , F 83, S 8, H M 30724, I/A 93 (5.01.18).
03 de Noviembre de 2017Nombramientos. Apo.Sol.: MARIN MURIEN JUAN IGNACIO;PAEZ ORDO脩EZ SERGIO;GOMEZ ARREBOLA MARIATERESA;NORTE GIMENEZ ELVIRA. Datos registrales. T 35601 , F 82, S 8, H M 30724, I/A 92 (25.10.17).
18 de Agosto de 2017Nombramientos. Apo.Sol.: ARBONIES LERANOZ FERNANDO ANTONIO. Datos registrales. T 35601 , F 82, S 8, H M 30724, I/A90 ( 8.08.17).
Reelecciones. Auditor: MAZARS AUDITORES SLP. Datos registrales. T 35601 , F 82, S 8, H M 30724, I/A 91 (10.08.17).
07 de Agosto de 2017Nombramientos. Apo.Sol.: HEVIA GONZALEZ NANCY;SERO ROSELLO DANIEL;VALENTI FUSTE NARCIS. Datos registrales. T35601 , F 81, S 8, H M 30724, I/A 89 (31.07.17).
19 de Mayo de 2017Nombramientos. Apo.Manc.: GARCIA ALCANTARA JOSEFA;COLOMER BLASCO ROBERTO;RODRIGUEZ OLIVIER;LAPORTEPHILIPPE JACQUES;MADRAZO PORRES DANIEL. Datos registrales. T 35601 , F 81, S 8, H M 30724, I/A 88 (10.05.17).
18 de Abril de 2017Nombramientos. Apoderado: GRANERO GARCIA MARIA INMACULADA. Datos registrales. T 35601 , F 80, S 8, H M 30724, I/A 87( 6.04.17).
14 de Marzo de 2017Nombramientos. Apo.Sol.: SUAREZ ROMERO ANA-ISABEL;MARTIN-GAMBERO JIMENEZ JUAN JOSE;ROSAS DE LA VEGAJOSE LUIS. Datos registrales. T 30327 , F 104, S 8, H M 30724, I/A 83 ( 6.03.17).
Revocaciones. Apoderado: POZUELO PEREZ ALMUDENA. Datos registrales. T 35601 , F 80, S 8, H M 30724, I/A 84 ( 6.03.17).
Revocaciones. Apoderado: MACHADO SA脩UDO SERGIO. Datos registrales. T 35601 , F 80, S 8, H M 30724, I/A 85 ( 6.03.17).
Nombramientos. Apoderado: MOYA QUINTANA JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 35601 , F 80, S 8, H M 30724, I/A 86 (6.03.17).
21 de Febrero de 2017Nombramientos. Apoderado: LOPEZ ARNAU JESSICA;GARCIA ASTUDILLO SERGIO;MONTERO RODRIGUEZ DAVID;SABINASUAREZ MARIA ADASSA;DIEZ FRAILE GEMA;MORENO PEREZ MARIA DOLORES;HERNANDEZ MARTIN MARTA. Datosregistrales. T 30327 , F 104, S 8, H M 30724, I/A 82 (13.02.17).
23 de Diciembre de 2016Nombramientos. Apo.Sol.: HEVIA GONZALEZ NANCY;CANUDAS TEIXIDO MONTSERRAT. Datos registrales. T 30327 , F 103, S8, H M 30724, I/A 81 (14.12.16).
13 de Septiembre de 2016Nombramientos. Apoderado: GARCIA ALMECIJA ANA ISABEL. Datos registrales. T 30327 , F 103, S 8, H M 30724, I/A 80 (2.09.16).
17 de Mayo de 2016Nombramientos. Apoderado: FERRE脩O POMBO NATALIA;FRANCO MEIJIDE MONTSERRAT;PANIAGUA GUTIERREZBELEN;TORRES CUENCA FRANCISCO MANUEL;MENDOZA MORAL ANGEL;DELGADO RUBIO SANTIAGO;ESTEBANEZ CASASLAURA;YUSTE REYES ANTONIO. Datos registrales. T 30327 , F 103, S 8, H M 30724, I/A 79 ( 6.05.16).
05 de Mayo de 2016Reelecciones. Auditor: MAZARS AUDITORES SLP. Datos registrales. T 30327 , F 102, S 8, H M 30724, I/A 78 (27.04.16).
25 de Noviembre de 2015Revocaciones. Apoderado: REINA SANCHEZ JOSE MARIA. Datos registrales. T 30327 , F 102, S 8, H M 30724, I/A 77 (18.11.15).
25 de Agosto de 2015Nombramientos. Apo.Sol.: NAVARRO GONZALEZ-CONDE DAVID. Datos registrales. T 30327 , F 102, S 8, H M 30724, I/A 76 (7.08.15).
04 de Agosto de 2015Reelecciones. Auditor: MAZARS AUDITORES SLP. Datos registrales. T 30327 , F 102, S 8, H M 30724, I/A 75 (27.07.15).
30 de Julio de 2015Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ CARRASCO LUIS NICOLAS;FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL;MORA LORANFRANCISCO. Datos registrales. T 30327 , F 101, S 8, H M 30724, I/A 74 (22.07.15).
10 de Febrero de 2015Nombramientos. Apoderado: CONTRERAS RODRIGUEZ MARIA DOLORES. Datos registrales. T 30327 , F 101, S 8, H M 30724,I/A 72 ( 2.02.15).
Nombramientos. Apo.Sol.: FUENTES RIVAS AROA;CRUZ JIMENEZ VIRGINIA;RUANO VESCELA JUAN GABRIEL. Datosregistrales. T 30327 , F 101, S 8, H M 30724, I/A 73 ( 2.02.15).
05 de Febrero de 2015Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ SANCHEZ MARIA DEL CARMEN. Datos registrales. T 30327 , F 100, S 8, H M 30724, I/A70 (29.01.15).
Nombramientos. Apoderado: AMO MANCHE脩O FRANCISCO JOSE. Datos registrales. T 30327 , F 100, S 8, H M 30724, I/A 71(29.01.15).
27 de Enero de 2015Nombramientos. Apoderado: NAVAS ROMAN ALFONSO;ALCANTARILLA PARRA MARIA DEL MAR;CAMPOY LOPEZMAGDALENA. Datos registrales. T 30327 , F 100, S 8, H M 30724, I/A 69 (20.01.15).
05 de Diciembre de 2014Nombramientos. Apoderado: SERADIN SL. Datos registrales. T 30327 , F 99, S 8, H M 30724, I/A 67 (27.11.14).
Nombramientos. Apoderado: PEREZ MU脩OZ ANGELA;MENENDEZ GONZALEZ EMILIO. Datos registrales. T 30327 , F 99, S 8, HM 30724, I/A 68 (27.11.14).
13 de Noviembre de 2014Revocaciones. Apo.Sol.: DE LOS RIOS BOLLEROS ALVARO. Datos registrales. T 30327 , F 99, S 8, H M 30724, I/A 66 ( 4.11.14).
29 de Octubre de 2014Nombramientos. Apo.Sol.: SALAS PEREZ LUCIA;GARCIA NAVARRO CARMEN. Datos registrales. T 30327 , F 98, S 8, H M30724, I/A 65 (21.10.14).
21 de Octubre de 2014Revocaciones. Apo.Sol.: SORIANO BARON ANA ENCARNACION;TERROBA SALVICHE MARCO-ANTONIO. Datos registrales. T30327 , F 98, S 8, H M 30724, I/A 63 (10.10.14).
Nombramientos. Apo.Sol.: MIR CORDOBA ISABEL. Datos registrales. T 30327 , F 98, S 8, H M 30724, I/A 64 (10.10.14).
15 de Septiembre de 2014Revocaciones. Apoderado: LEON LEON ANTONIO;SERRANO BALBUENA JOSE FRANCISCO. Datos registrales. T 30327 , F 97,S 8, H M 30724, I/A 61 ( 8.09.14).
Nombramientos. Apoderado: PINGARRON CARRAZON RICARDO. Datos registrales. T 30327 , F 97, S 8, H M 30724, I/A 62 (8.09.14).
02 de Julio de 2014Nombramientos. Apo.Sol.: DE LOS RIOS BOLLEROS ALVARO. Datos registrales. T 30327 , F 97, S 8, H M 30724, I/A 60(24.06.14).
30 de Junio de 2014Nombramientos. Apoderado: REINA SANCHEZ JOSE MARIA. Datos registrales. T 30327 , F 97, S 8, H M 30724, I/A 59 (16.06.14).
18 de Junio de 2014Nombramientos. Apoderado: GAZQUEZ DIAZ ALFREDO JESUS. Datos registrales. T 30327 , F 96, S 8, H M 30724, I/A 58(10.06.14).
28 de Mayo de 2014Revocaciones. Apoderado: TOME MARTIN JESUS MARIA;RUIZ MONTOYA JOSE LUIS. Datos registrales. T 30327 , F 96, S 8, HM 30724, I/A 57 (20.05.14).
11 de Marzo de 2014Nombramientos. Apoderado: GARCIA PARRA JOSE. Datos registrales. T 30327 , F 96, S 8, H M 30724, I/A 56 (27.02.14).
28 de Febrero de 2014Nombramientos. Apo.Sol.: TOME MARTIN JESUS MARIA;LLANOS LOZANO RUBEN. Datos registrales. T 30327 , F 95, S 8, H M30724, I/A 55 (21.02.14).
06 de Febrero de 2014Nombramientos. Apoderado: AGUINACO GIL RODRIGO JAVIER;ALVAREZ RAMOS ALFONSO. Datos registrales. T 30327 , F 95,S 8, H M 30724, I/A 54 (29.01.14).
23 de Enero de 2014Revocaciones. Apo.Sol.: BELLIDO IBORRA MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 30327 , F 95, S 8, H M 30724, I/A 53 (14.01.14).
08 de Noviembre de 2013Nombramientos. Apo.Sol.: SORIANO BARON ANA ENCARNACION;TERROBA SALVICHE MARCO-ANTONIO. Datos registrales.T 30327 , F 95, S 8, H M 30724, I/A 52 (31.10.13).
11 de Septiembre de 2013Nombramientos. Apoderado: SERRANO LAZARO MARIA ROSA;MARIN BELLIDO FELICIDAD. Datos registrales. T 30327 , F 94,S 8, H M 30724, I/A 50 (27.08.13).
Nombramientos. Apoderado: JIMENEZ LORENZO SONIA;SANZ ALMANZOR RICARDO;FAZIO CASTEL ELENA. Datosregistrales. T 30327 , F 94, S 8, H M 30724, I/A 51 (27.08.13).
03 de Septiembre de 2013Nombramientos. Apoderado: GARCIA PARRA JOSE. Datos registrales. T 30327 , F 93, S 8, H M 30724, I/A 49 (26.08.13).
27 de Agosto de 2013Nombramientos. Apo.Sol.: VALLE SANCHEZ MARIA ESTHER;GUZMAN GARCIA CARMEN. Datos registrales. T 30327 , F 93, S8, H M 30724, I/A 48 (19.08.13).
26 de Agosto de 2013Nombramientos. Apoderado: DOMINGUEZ GARCIA ANGELES;FERNANDEZ ANDES CAMPA脩A CARMEN. Datos registrales. T30327 , F 93, S 8, H M 30724, I/A 47 (13.08.13).
08 de Agosto de 2013Nombramientos. Apo.Sol.: PEQUE脩O RODRIGUEZ IGNACIO;LLAMAS DOMINGUEZ ANA MARIA;SANZ CA脩AS ALBERTO;RUIZDURAN SAMUEL;MARTINEZ GUADIX ANA MARIA;VEINTIMILLA SANCHEZ ANA MARIA;REQUENA SANCHEZ ISABEL;SANANTONIO MARTINEZ TRECE脩O RAQUEL. Datos registrales. T 30327 , F 92, S 8, H M 30724, I/A 46 (31.07.13).
09 de Mayo de 2013Nombramientos. Apo.Sol.: ORTIZ BORRAS ISABEL;TORIBIO RODRIGUEZ Y REDONDO ADELA. Datos registrales. T 30327 , F89, S 8, H M 30724, I/A 44 (29.04.13).