Actos BORME de Reunion Joyera De Cordoba Sa
14 de Mayo de 2021Cierre provisional hoja registral por baja en el índice de Entidades Jurídicas. Datos registrales. T 1740 , F 185, S 8, H CO20625, I/A 1 H (21.04.21).
30 de Julio de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: JOYEROS MARTIN & RUIZ SA. Presidente: JOYEROS MARTIN & RUIZ SA. Cons.Del.Man:JOYEROS MARTIN & RUIZ SA. Tesorero: J MANUEL GARCIA MERINA SL. Consejero: J MANUEL GARCIA MERINA SL.Cons.Del.Man: J MANUEL GARCIA MERINA SL. Secretario: BERRAL CASTRO MANUEL. Nombramientos. Consejero: HOTELPUERTA NUEVA SL;GOMEZ SANCHEZ RAFAEL. Presidente: BERRAL CASTRO MANUEL. Cons.Del.Man: HOTEL PUERTA NUEVASL;GOMEZ SANCHEZ RAFAEL. Secretario: JORDANO TORRE BERNARDO. Datos registrales. T 1740 , F 198, S 8, H CO 20625,I/A 12 (20.07.12).
25 de Febrero de 2010Nombramientos. Cons.Del.Man: J MANUEL GARCIA MERINA SL. Datos registrales. T 1740 , F 197, S 8, H CO 20625, I/A 11(11.02.10).
19 de Febrero de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: BARBUDO DIAZ SL. Presidente: BARBUDO DIAZ SL. Consejero: COLONCENTER SL. Secretario:COLONCENTER SL. Consejero: ROSA BENITEZ SL;BARBUDO GOMEZ ANTONIO ANGEL. Con.Delegado: BARBUDO GOMEZANTONIO ANGEL. Consejero: JIMENEZ RAMIREZ JESUS. Con.Delegado: JIMENEZ RAMIREZ JESUS. Consejero: VALERORODRIGUEZ JOSE. Con.Delegado: VALERO RODRIGUEZ JOSE. Tesorero: ROSA BENITEZ SL. Nombramientos. Consejero:JOYEROS MARTIN & RUIZ SA. Presidente: JOYEROS MARTIN & RUIZ SA. Cons.Del.Man: JOYEROS MARTIN & RUIZ SA.Consejero: BERRAL CASTRO MANUEL. Secretario: BERRAL CASTRO MANUEL. Cons.Del.Man: BERRAL CASTRO MANUEL.Tesorero: J MANUEL GARCIA MERINA SL. Consejero: J MANUEL GARCIA MERINA SL. Datos registrales. T 1740 , F 197, S 8, HCO 20625, I/A 11 (11.02.10).
04 de Septiembre de 2009Fe de erratas: Que el desembolso correcto fue de 1.085.000 euros (98,33% del capital). Datos registrales. T 1740 , F 195, S 8, HCO 20625, I/A 8 (24.04.09).
Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 49.000,00 Euros. Datos registrales. T 1740 , F 197, S 8, H CO 20625, I/A 10(26.08.09).
26 de Mayo de 2009Ceses/Dimisiones. Auditor: VASCO MARTINEZ JOSE MANUEL. Aud.Supl.: INFANTE VICTOR HECTOR. Datos registrales. T1740 , F 196, S 8, H CO 20625, I/A 9 (15.05.09).
06 de Mayo de 2009Ampliación de capital. Suscrito: 1.134.000,00 Euros. Desembolsado: 1.134.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.937.000,00 Euros.Resultante Desembolsado: 2.937.000,00 Euros. Datos registrales. T 1740 , F 195, S 8, H CO 20625, I/A 8 (24.04.09).
11 de Marzo de 2009Nombramientos. Auditor: VASCO MARTINEZ JOSE MANUEL. Aud.Supl.: INFANTE VICTOR HECTOR. Datos registrales. T 1740 ,F 195, S 8, H CO 20625, I/A 7 ( 2.03.09).
02 de Febrero de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: RUSO JIMENEZ MANUEL. Presidente: RUSO JIMENEZ MANUEL. Consejero: CARRILLO BAEZAANTONIO. Secretario: CARRILLO BAEZA ANTONIO. Consejero: HEJIMSA 2003 SL. Revocaciones. Apo.Manc.: CARRILLO BAEZAANTONIO;RUSO JIMENEZ MANUEL;HEJIMSA 2003 SL. Nombramientos. Consejero: BARBUDO DIAZ SL. Presidente: BARBUDODIAZ SL. Consejero: COLONCENTER SL. Secretario: COLONCENTER SL. Consejero: ROSA BENITEZ SL;BARBUDO GOMEZANTONIO ANGEL. Con.Delegado: BARBUDO GOMEZ ANTONIO ANGEL. Consejero: JIMENEZ RAMIREZ JESUS. Con.Delegado:JIMENEZ RAMIREZ JESUS. Consejero: VALERO RODRIGUEZ JOSE. Con.Delegado: VALERO RODRIGUEZ JOSE. Tesorero: ROSABENITEZ SL. Datos registrales. T 1740 , F 194, S 8, H CO 20625, I/A 6 (22.01.09).