Buscador CIF Logo

Actos BORME Riberebro Integral Sociedad Anonima

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Riberebro Integral Sociedad Anonima

Actos BORME Riberebro Integral Sociedad Anonima - A26367698

Tenemos registrados 32 Actos BORME del Registro Mercantil de La Rioja para Riberebro Integral Sociedad Anonima con CIF A26367698

🔙 Perfil de Riberebro Integral Sociedad Anonima
🛒 Comprar listado completo de Empresas de La Rioja

Actos BORME de Riberebro Integral Sociedad Anonima

13 de Marzo de 2023
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 603 , F 72, S 8, H LO 9421, I/A 38 ( 1.03.23).

Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 603 , F 72, S 8, H LO 9421, I/A39 ( 1.03.23).

08 de Septiembre de 2022
Revocaciones. Apoderado: DIAGO MATACHANA LUIS-FERNANDO. Datos registrales. T 603 , F 71, S 8, H LO 9421, I/A 37 (1.09.22).

12 de Mayo de 2022
Nombramientos. Apo.Sol.: CAMPO BETRAN ALFONSO;FELIPO DEL PRADO MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 603 , F 70, S8, H LO 9421, I/A 36 ( 5.05.22).

05 de Enero de 2022
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 603 , F 70, S 8, H LO 9421, I/A 35 (28.12.21).

01 de Febrero de 2021
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 603 , F 69, S 8, H LO 9421, I/A 32 (21.01.21).

Revocaciones. Apo.Man.Soli: MARIN PLA RAFAEL;SANCHEZ MURO FRANCISCO JAVIER;VILLAFRANCA ITURRE IGNACIO.Apo.Manc.: MARTINEZ MOLINA JOSE LUIS;FRANCES BUSTO DAVID;MARIN PLA RAFAEL;SANCHEZ MURO FRANCISCOJAVIER;VILLAFRANCA ITURRE IGNACIO. Datos registrales. T 603 , F 69, S 8, H LO 9421, I/A 33 (21.01.21).

Nombramientos. Apoderado: VILLAFRANCA ITURRE IGNACIO. Datos registrales. T 603 , F 70, S 8, H LO 9421, I/A 34 (21.01.21).

10 de Marzo de 2020
Reelecciones. Adm. Unico: GRUPO RIBEREBRO INTEGRAL SL. Otros conceptos: Se designa como persona física representantedel administrador único reelegido a don Eduardo López Milagro. Datos registrales. T 603 , F 69, S 8, H LO 9421, I/A 31 (25.02.20).

25 de Marzo de 2019
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 603 , F 69, S 8, H LO 9421, I/A 30 (14.03.19).

30 de Mayo de 2018
Nombramientos. Apoderado: DIAGO MATACHANA LUIS-FERNANDO. Datos registrales. T 569 , F 77, S 8, H LO 9421, I/A 29(23.05.18).

21 de Febrero de 2018
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 569 , F 77, S 8, H LO 9421, I/A 28 (13.02.18).

19 de Enero de 2018
Revocaciones. Apo.Man.Soli: ROYO FERNANDEZ JOSE ANTONIO;D'OXANDABARATZ LOPEZ AITOR. Apo.Manc.:NAVARCORENA ZABALZA ALFONSO. Nombramientos. Apo.Manc.: MARTINEZ MOLINA JOSE LUIS;FRANCES BUSTODAVID;MARIN PLA RAFAEL;SANCHEZ MURO FRANCISCO JAVIER;VILLAFRANCA ITURRE IGNACIO. Datos registrales. T 569 ,F 77, S 8, H LO 9421, I/A 27 ( 3.01.18).

27 de Marzo de 2017
Reducción de capital. Importe reducción: 8.580.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.420.000,00 Euros. Datos registrales. T 569 , F76, S 8, H LO 9421, I/A 25 (17.03.17).

Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 569 , F 76, S 8, H LO 9421, I/A 26 (17.03.17).

17 de Junio de 2016
Revocaciones. Apo.Manc.: ROLDAN GOROSQUIETA FERNANDO;BARQUIN LOIS ALBERTO. Datos registrales. T 569 , F 76, S8, H LO 9421, I/A 24 ( 3.06.16).

27 de Abril de 2016
Revocaciones. Apo.Man.Soli: SANCHEZ FERNANDEZ CARLOS;ROYO FERNANDEZ JOSE ANTONIO;D'OXANDABARATZ LOPEZAITOR. Datos registrales. T 569 , F 75, S 8, H LO 9421, I/A 22 (18.04.16).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: ROYO FERNANDEZ JOSE ANTONIO;D'OXANDABARATZ LOPEZ AITOR;MARIN PLARAFAEL;SANCHEZ MURO FRANCISCO JAVIER. Apo.Manc.: ROLDAN GOROSTEQUIETA FERNANDO;BARQUIN LOISALBERTO;NAVARCORENA ZABALZA ALFONSO. Apo.Man.Soli: VILLAFRANCA ITURRE IGNACIO. Datos registrales. T 569 , F 75,S 8, H LO 9421, I/A 23 (18.04.16).

14 de Abril de 2016
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 569 , F 75, S 8, H LO 9421, I/A 21 ( 5.04.16).

24 de Julio de 2015
Otros conceptos: Sustituido don Francisco Javier Sánchez Muro como persona física representante del administrador único GRUPORIBEREBRO INTEGRAL, S.L.U., por don EDUARDO LOPEZ MILAGRO. Datos registrales. T 569 , F 75, S 8, H LO 9421, I/A 20(14.07.15).

07 de Julio de 2015
Otros conceptos: Sustituido don Sixto Jiménez Muniáin como persona física representante del administrador único persona jurídicapor don FRANCISCO JAVER SANCHEZ MURO. Datos registrales. T 569 , F 75, S 8, H LO 9421, I/A 19 ( 4.06.15).

17 de Marzo de 2015
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 569 , F 74, S 8, H LO 9421, I/A 17 ( 6.03.15).

Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 569 , F 74, S 8, H LO 9421, I/A 18 ( 6.03.15).

21 de Mayo de 2014
Nombramientos. Apo.Man.Soli: SANCHEZ FERNANDEZ CARLOS;ROYO FERNANDEZ JOSE ANTONIO;D'OXANDABARATZLOPEZ AITOR. Datos registrales. T 569 , F 74, S 8, H LO 9421, I/A 15 (12.05.14).

Revocaciones. Apoderado: CUEVAS VILLOSLADA EDUARDO;AYENSA AMBROSI JOSE MARIA. Datos registrales. T 569 , F 74,S 8, H LO 9421, I/A 16 (12.05.14).

24 de Abril de 2014
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: ESTUDIO DE CUENTAS Y VALORES SL. Nombramientos. Adm. Unico: GRUPO RIBEREBROINTEGRAL SL. Otros conceptos: Designado don EDUARDO LOPEZ MILAGRO como persona física representante deladministrador único persona jurídica. Datos registrales. T 569 , F 73, S 8, H LO 9421, I/A 13 (14.04.14).

Otros conceptos: Designado don SIXTO JIMENEZ MUNIAIN como persona física representante del administrador único, GrupoRiberebro Integral, S.L., en sustitución de don Eduardo López Milagro. Datos registrales. T 569 , F 73, S 8, H LO 9421, I/A 14(14.04.14).

15 de Julio de 2013
Reelecciones. Adm. Unico: ESTUDIO DE CUENTAS Y VALORES SL. Datos registrales. T 569 , F 73, S 8, H LO 9421, I/A 12 (8.07.13).

01 de Abril de 2013
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 569 , F 73, S 8, H LO 9421, I/A 11 (21.03.13).

02 de Julio de 2012
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 569 , F 73, S 8, H LO 9421, I/A 10 (21.06.12).

11 de Febrero de 2011
Ampliación de capital. Suscrito: 8.700.000,00 Euros. Desembolsado: 8.700.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 12.000.000,00 Euros.Resultante Desembolsado: 12.000.000,00 Euros. Datos registrales. T 569 , F 72, S 8, H LO 9421, I/A 9 (31.01.11).

20 de Abril de 2009
Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 569 , F 72, S 8, H LO 9421, I/A 8 ( 6.04.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información