Buscador CIF Logo

Actos BORME Richardson Rfpd Spain Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Richardson Rfpd Spain Sl

Actos BORME Richardson Rfpd Spain Sl - B86029501

Tenemos registrados 18 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Richardson Rfpd Spain Sl con CIF B86029501

馃敊 Perfil de Richardson Rfpd Spain Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Richardson Rfpd Spain Sl

05 de Diciembre de 2023
Nombramientos. Apoderado: GARCIA ALVAREZ ANGELA;DE SANTIS DANIELE;MENDEZ GARCIA DE QUESADA JOSEMANUEL;PEGUEROLES VALLES LLUIS GONCAGA;PEREIRA DOS SANTOS ANTONIO CARLOS. Datos registrales. T 38224 , F221, S 8, H M 507150, I/A 19 (28.11.23).

13 de Enero de 2023
Revocaciones. Apoderado: GARCIA LOPEZ FERNANDO;STANSBURY CHRISTOPHER DAVID;SHAW JOHN PAUL;UNDIKS EMMAJULISSA;KOPLITZ MARCUS PAUL. Datos registrales. T 38224 , F 221, S 8, H M 507150, I/A 18 ( 5.01.23).

13 de Octubre de 2022
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: STANSBURY CHRISTOPHER DAVID. Nombramientos. Adm. Solid.: SEIDLITZ RICHARDAUSTIN. Datos registrales. T 38224 , F 221, S 8, H M 507150, I/A 17 ( 5.10.22).

27 de Marzo de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: TARPINIAN GREGORY;BRUEDERL GEORG. Presidente: BRUEDERL GEORG. Consejero:STANSBURY CHRISTOPHER DAVID. SecreNoConsj: MENDEZ GARCIA DE QUESADA JOSE MANUEL. Revocaciones.Apoderado: TARPINIAN GREGORY. Apo.Sol.: LOPEZ DONOSO PEDRO. Nombramientos. Adm. Solid.: STANSBURYCHRISTOPHER DAVID;BRUEDERL GEORG. Apoderado: MENDEZ GARCIA DE QUESADA JOSE-MANUEL;ARANA KNIRSCHSILVESTRE;BRAGADO LORENZO FRANCISCO JAVIER;PRIEGO LUQUE MARIA DOLORES. Otros conceptos: Cambio delOrgano de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administradores solidarios. Datos registrales. T 38224 , F 220, S 8, H M507150, I/A 16 (20.03.20).

22 de Octubre de 2019
Nombramientos. Apo.Sol.: GAYO REBOLLO JAVIER;LOPEZ DONOSO PEDRO. Datos registrales. T 38224 , F 220, S 8, H M507150, I/A 15 (15.10.19).

03 de Mayo de 2019
Nombramientos. Apoderado: SHAW JOHN PAUL;UNDIKS EMMA JULISSA;KOPLITZ MARCUS PAUL;NOREEN KENNETHERIC;SCOTT JASON E. Datos registrales. T 38224 , F 219, S 8, H M 507150, I/A 14 (24.04.19).

16 de Noviembre de 2018
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: LOPEZ DONOSO PEDRO. Revocaciones. Apoderado: LOPEZ DONOSO PEDRO;REILLYPAUL J. Nombramientos. SecreNoConsj: MENDEZ GARCIA DE QUESADA JOSE MANUEL. Apoderado: TARPINIANGREGORY;STANSBURY CHRISTOPHER DAVID;BRUEDERL GEORG;MENDEZ GARCIA DE QUESADA JOSE-MANUEL. Datosregistrales. T 38224 , F 213, S 8, H M 507150, I/A 13 ( 7.11.18).

18 de Mayo de 2017
Revocaciones. Apoderado: RIA脩O GONZALEZ JUAN LUIS;MCNALLY BRIAN;BROWN PETER;GARCIA LOPEZ FERNANDO.Datos registrales. T 28151 , F 110, S 8, H M 507150, I/A 12 ( 9.05.17).

17 de Enero de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: REILLY PAUL J. Nombramientos. Consejero: STANSBURY CHRISTOPHER DAVID. Datosregistrales. T 28151 , F 110, S 8, H M 507150, I/A 11 (10.01.17).

11 de Mayo de 2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: EVANS MARTIN. Presidente: EVANS MARTIN. Nombramientos. Consejero: BRUEDERL GEORG.Presidente: BRUEDERL GEORG. Cambio de domicilio social. AVDA DE EUROPA 21 (ALCOBENDAS). Datos registrales. T28151 , F 109, S 8, H M 507150, I/A 10 ( 4.05.16).

07 de Agosto de 2015
Fe de erratas: Se public贸 por error en la Iscripci贸n 9& el nombramiento de TARPINIAN GREGORY como ADMINISTRADOR UNICO,siendo lo correcto CONSEJERO. Datos registrales. T 28151 , F 109, S 8, H M 507150, I/A 9 (21.07.15).

06 de Agosto de 2015
Fe de erratas: Se public贸 por error en la Inscricpi贸n 8& el nombramiento de MARTIN EVANS como ADMINISTRADOR UNICO,siendo lo correcto PRESIDENTE. Datos registrales. T 28151 , F 109, S 8, H M 507150, I/A 8 (21.07.15).

29 de Julio de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: MCNALLY BRIAN. Presidente: MCNALLY BRIAN. Nombramientos. Consejero: EVANS MARTIN.Adm. Unico: EVANS MARTIN. Datos registrales. T 28151 , F 109, S 8, H M 507150, I/A 8 (21.07.15).

Ceses/Dimisiones. Consejero: BROWN PETER. Nombramientos. Adm. Unico: TARPINIAN GREGORY. Datos registrales. T28151 , F 109, S 8, H M 507150, I/A 9 (21.07.15).

14 de Agosto de 2013
Revocaciones. Apoderado: CUELLO SEGURA GERMAN;GARCIA SACRISTAN MARIANO PEDRO;GARCIA SACRISTAN MARIANOPEDRO. Nombramientos. Apo.Man.Soli: GAYO REBOLLO JAVIER. Datos registrales. T 28151 , F 107, S 8, H M 507150, I/A 7 (1.08.13).

20 de Diciembre de 2011
Nombramientos. Apoderado: GARCIA LOPEZ FERNANDO;GARCIA SACRISTAN MARIANO PEDRO. Datos registrales. T 28151 ,F 107, S 8, H M 507150, I/A 6 ( 7.12.11).

26 de Abril de 2011
Nombramientos. Apoderado: GARCIA LOPEZ FERNANDO;GARCIA SACRISTAN MARIANO PEDRO. Datos registrales. T 28151 ,F 106, S 8, H M 507150, I/A 5 (13.04.11).

07 de Febrero de 2011
Nombramientos. SecreNoConsj: LOPEZ DONOSO PEDRO. Presidente: MCNALLY BRIAN. Apoderado: LOPEZ DONOSOPEDRO;RIA脩O GONZALEZ JUAN LUIS;CUELLO SEGURA GERMAN;MCNALLY BRIAN;BROWN PETER;REILLY PAUL J. Datosregistrales. T 28151 , F 105, S 8, H M 507150, I/A 4 (26.01.11).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n