Actos BORME de Riomovil Automocion Sociedad Limitada
13 de Septiembre de 2022Otros conceptos: "NITA, S.L." con NIF B41257981 designa como nuevo representante persona física a don José María BorrásMartín, con D.N.I. 45.118.449-Q, para el ejercicio del cargo de Administradora solidaria. Datos registrales. T 5532 , F 166, S 8, H SE45517, I/A 27 ( 5.09.22).
22 de Octubre de 2021Nombramientos. Apoderado: BORRAS MARTIN JOSE MARIA. Datos registrales. T 5532 , F 165, S 8, H SE 45517, I/A 26(15.10.21).
21 de Agosto de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: VILLAGRAN DE CARDENAS MANUEL;MARTINEZ MEJIAS Y GARCIA DEL CID JOSE JOAQUIN.Cons.Del.Sol: VILLAGRAN DE CARDENAS MANUEL;MARTINEZ MEJIAS Y GARCIA DEL CID JOSE JOAQUIN. Consejero: ROCADE TOGORES Y PEREZ DE GUZMAN MANUEL. Presidente: ROCA DE TOGORES Y PEREZ DE GUZMAN MANUEL. Consejero:ESCRIBANO IVISON JOSE MARIA. Vicepresid.: ESCRIBANO IVISON JOSE MARIA. Consejero: DELGADO DE COS CHOZASALFREDO;GONZALO DE BUSTOS FERNANDO;OSBORNE BORES EDUARDO;YBARRA OSBORNE FELIPE;ALVEAR ALMUNIACRISTOBAL. Cons.Del.Sol: ROCA DE TOGORES Y PEREZ DE GUZMAN MANUEL. Nombramientos. Adm. Solid.: COMERCIALAUTOTRACTOR SA;NITA SL. Modificaciones estatutarias. 20. Duración comienzo de operaciones y cierre de ejercicio.-. Otrosconceptos: Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios. Datos registrales. T5532 , F 164, S 8, H SE 45517, I/A 25 ( 9.08.18).
21 de Julio de 2016Reelecciones. Auditor: AUDITORIA Y CONSULTA SA. Datos registrales. T 5532 , F 164, S 8, H SE 45517, I/A 24 (13.07.16).
11 de Diciembre de 2015Reducción de capital. Importe reducción: 825.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 600.000,00 Euros. Modificaciones estatutarias.Artículo de los estatutos: 5. Capital.-. Datos registrales. T 5532 , F 164, S 8, H SE 45517, I/A 23 ( 1.12.15).
07 de Julio de 2014Nombramientos. Apo.Sol.: ESCRIBANO CASTILLO CLARA MARIA;MORALES MORENO IGNACIO JAVIER;ALVEAR ALMUNIAGUADALUPE. Datos registrales. T 5532 , F 163, S 8, H SE 45517, I/A 22 (26.06.14).
05 de Marzo de 2014Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: ARTICULO 3º: Domicilio.-. Cambio de domicilio social. CTRA DE SUEMINENCIA 26 (SEVILLA). Datos registrales. T 5532 , F 163, S 8, H SE 45517, I/A 21 (24.02.14).
12 de Septiembre de 2013Revocaciones. Apo.Manc.: NUÑEZ ALVAREZ ANTONIO. Apo.Sol.: NUÑEZ ALVAREZ ANTONIO. Apo.Manc.: NUÑEZ ALVAREZANTONIO. Apo.Sol.: NUÑEZ ALVAREZ ANTONIO. Otros conceptos: La Sociedad REVOCA el PODER NO INSCRITO, conferido afavor de DON ANTONIO NUÑEZ ALVAREZ, en virtud de escritura autorizada en Sevilla, el día 20 de abril de 2.007, por el Notario DonManuel Seda Hermosín, bajo el número 1.362 de su protocolo.- Datos registrales. T 5532 , F 163, S 8, H SE 45517, I/A 20(29.08.13).
22 de Agosto de 2013Nombramientos. Apo.Manc.: COSTILLA PURO ANGEL;LANCHA LANCHA JOSE MARIA;ALVEAR ALMUNIAGUADALUPE;MORALES MORENO IGNACIO JAVIER;ESCRIBANO CASTILLO CLARA MARIA. Datos registrales. T 5532 , F 162, S8, H SE 45517, I/A 19 ( 8.08.13).
17 de Octubre de 2012Nombramientos. Auditor: AUDITORIA Y CONSULTA SA. Datos registrales. T 5532 , F 161, S 8, H SE 45517, I/A 18 ( 3.10.12).
09 de Octubre de 2012Ampliación de capital. Capital: 650.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.425.000,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Artículode los estatutos: 5. Capital.-. Datos registrales. T 5532 , F 161, S 8, H SE 45517, I/A 17 (28.09.12).
20 de Junio de 2012Nombramientos. Auditor: AUDITORIA Y CONSULTA SA. Datos registrales. T 3323 , F 180, S 8, H SE 45517, I/A 16 ( 6.06.12).
01 de Junio de 2011Nombramientos. Apo.Sol.: DE LA TORRE PEREZ FERNANDO. Datos registrales. T 3323 , F 180, S 8, H SE 45517, I/A 15(17.05.11).
20 de Mayo de 2010Nombramientos. Apoderado: DE LA TORRE PEREZ FERNANDO. Datos registrales. T 3323 , F 179, S 8, H SE 45517, I/A 14(10.05.10).