Actos BORME de Risfer Sl
27 de Abril de 2022Modificaciones estatutarias. Art铆culo 19潞. Retribuci贸n de los Administradores.. Datos registrales. T 4086 , F 43, S 8, H A 157858,I/A 4 (19.04.22).
04 de Mayo de 2018Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: FERNANDEZ RUIZ CARLOS;RUIZ VIZCAINO ROSA. Nombramientos. Consejero: FERNANDEZLOPEZ LUIS;RUIZ VIZCAINO ROSA;FERNANDEZ RUIZ CAROLINA;FERNANDEZ RUIZ CARLOS. Presidente: FERNANDEZ LOPEZLUIS. SecreNoConsj: FREIRIA SANTOS FELICIANO. Apo.Sol.: FERNANDEZ LOPEZ LUIS;RUIZ VIZCAINO ROSA;FERNANDEZRUIZ CAROLINA;FERNANDEZ RUIZ CARLOS. Modificaciones estatutarias. Art铆culo 11潞. Organos sociales. Otros conceptos:Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores solidarios a Consejo de administraci贸n. Datos registrales. T 4086 , F 42, S 8,H A 157858, I/A 3 (24.04.18).
29 de Diciembre de 2017Cambio de domicilio social. AVDA DE LA INDUSTRIA S/N - POLIGONO INDUSTRIAL SAN (COX). Datos registrales. T 4086 , F42, S 8, H A 157858, I/A 2 (20.12.17).
10 de Marzo de 2016Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DEL ARTICULO 19 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. SISTEMA RETRIBUTIVO DELORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL. Datos registrales. T 29366 , F 164, S 8, H B 148230, I/A 8 ( 3.03.16).
26 de Junio de 2014Revocaciones. ADMINISTR.: FERNANDEZ LOPEZ LUIS. Nombramientos. ADM.SOLIDAR.: FERNANDEZ RUIZ CARLOS.Modificaciones estatutarias. ART.19.- SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL. Datosregistrales. T 29366 , F 164, S 8, H B 148230, I/A 7 (18.06.14).
15 de Febrero de 2012Ampliaci贸n de capital. Capital: 1.873.713,66 Euros. Resultante Suscrito: 2.080.637,96 Euros. Datos registrales. T 29366 , F 162, S8, H B 148230, I/A 6 ( 3.02.12).
26 de Enero de 2012Cambio de objeto social. AMPLIAR A:GESTION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO YEXPLOTACION TURISTICA DE FINCAS E INMUEBLES. Datos registrales. T 29366 , F 161, S 8, H B 148230, I/A 5 (13.01.12).
02 de Junio de 2009Nombramientos. APODERADO: FERNANDEZ RUIZ CARLOS. Datos registrales. T 29366 , F 161, S 8, H B 148230, I/A 4(21.05.09).