Actos BORME de Rittenhosting Sl
06 de Febrero de 2023Cambio de domicilio social. C/ DORMITALERIA 74 BAJO (PAMPLONA). Datos registrales. T 1761 , F 104, S 8, H NA 34930, I/A10 (30.01.23).
01 de Febrero de 2022Revocaciones. Apoderado: GANDOLFO PATRICIA CLAIRETTE GERMAINE. Apo.Sol.: GANDOLFO PATRICIA CLAIRETTEGERMAINE. Apoderado: GANDOLFO PATRICIA CLAIRETTE GERMAINE. Datos registrales. T 1761 , F 103, S 8, H NA 34930, I/A 9
08 de Noviembre de 2016Nombramientos. Apoderado: ADARRAGA VILLAR MIKEL GOTZON. Datos registrales. T 1761 , F 103, S 8, H NA 34930, I/A 8(28.10.16).
16 de Septiembre de 2016Nombramientos. Apoderado: ADARRAGA VILLAR MIKEL GOTZON;GANDOLFO PATRICIA CLAIRETTE GERMAINE. Datosregistrales. T 1761 , F 102, S 8, H NA 34930, I/A 7 ( 7.09.16).
29 de Febrero de 2016Nombramientos. Apo.Sol.: ADARRAGA VILLAR MIKEL GOTZON;GANDOLFO PATRICIA CLAIRETTE GERMAINE. Datosregistrales. T 1761 , F 102, S 8, H NA 34930, I/A 6 (18.02.16).
25 de Noviembre de 2015Nombramientos. Apoderado: ADARRAGA VILLAR MIKEL GOTZON;GANDOLFO PATRICIA CLAIRETTE GERMAINE. Datosregistrales. T 1761 , F 101, S 8, H NA 34930, I/A 5 (12.11.15).
23 de Noviembre de 2015Pérdida del caracter de unipersonalidad. Datos registrales. T 1761 , F 101, S 8, H NA 34930, I/A 4 (12.11.15).