Buscador CIF Logo

Actos BORME Rivera Campano Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Rivera Campano Sa

Actos BORME Rivera Campano Sa - A28608529

Tenemos registrados 10 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Rivera Campano Sa con CIF A28608529

馃敊 Perfil de Rivera Campano Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Rivera Campano Sa

07 de Octubre de 2021
Cambio de domicilio social. CMNO DE LA ZARZUELA 10 BAJO A (MADRID). Datos registrales. T 30340 , F 59, S 8, H M 117503,I/A 35 (30.09.21).

15 de Septiembre de 2021
Modificaciones estatutarias. MODIFICADO EL ARTICULO 15 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.. Datos registrales. T 30340 , F58, S 8, H M 117503, I/A 34 ( 8.09.21).

11 de Agosto de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: GONZALEZ DE LA OBRA MARIA;GONZALEZ DE LA OBRA ANA JULIA;MU脩OZ GIL PEDRO.Presidente: GONZALEZ DE LA OBRA MARIA. Secretario: GONZALEZ DE LA OBRA ANA JULIA. Cons.Del.Man: GONZALEZ DE LAOBRA MARIA;GONZALEZ DE LA OBRA ANA JULIA. Nombramientos. Consejero: GONZALEZ DE LA OBRA MARIA;GONZALEZDE LA OBRA ANA JULIA;MU脩OZ GIL PEDRO. Presidente: GONZALEZ DE LA OBRA MARIA. Secretario: GONZALEZ DE LA OBRAANA JULIA. Cons.Del.Man: GONZALEZ DE LA OBRA ANA JULIA;GONZALEZ DE LA OBRA MARIA. Datos registrales. T 30340 , F57, S 8, H M 117503, I/A 33 ( 4.08.21).

02 de Septiembre de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: GONZALEZ DE LA OBRA MARIA;GONZALEZ DE LA OBRA ANA JULIA;MU脩OZ GIL PEDRO.Presidente: GONZALEZ DE LA OBRA MARIA. Secretario: GONZALEZ DE LA OBRA ANA JULIA. Cons.Del.Man: GONZALEZ DE LAOBRA MARIA;GONZALEZ DE LA OBRA ANA JULIA. Nombramientos. Consejero: GONZALEZ DE LA OBRA MARIA;GONZALEZDE LA OBRA ANA JULIA;MU脩OZ GIL PEDRO. Presidente: GONZALEZ DE LA OBRA MARIA. Secretario: GONZALEZ DE LA OBRAANA JULIA. Cons.Del.Man: GONZALEZ DE LA OBRA MARIA;GONZALEZ DE LA OBRA ANA JULIA. Datos registrales. T 30340 , F57, S 8, H M 117503, I/A 32 (26.08.15).

09 de Octubre de 2013
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 100.016,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.250.048,00 Euros. Datos registrales. T 30340 ,F 56, S 8, H M 117503, I/A 31 ( 1.10.13).

10 de Diciembre de 2012
Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ DE LA OBRA MARIA. Datos registrales. T 13474 , F 199, S 8, H M 117503, I/A 29(29.11.12).

Nombramientos. Apoderado: DE LA OBRA FERRARI CATALINA. Datos registrales. T 30340 , F 55, S 8, H M 117503, I/A 30(29.11.12).

31 de Agosto de 2011
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 204.286,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.350.064,00 Euros. Datos registrales. T 13474 ,F 199, S 8, H M 117503, I/A 28 (19.08.11).

07 de Julio de 2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: DE LA OBRA FERRARI CATALINA;GONZALEZ DE LA OBRA ANA JULIA;GONZALEZ DE LA OBRAMARIA;JOMAI SA. Presidente: DE LA OBRA FERRARI CATALINA. Secretario: GONZALEZ DE LA OBRA ANA JULIA. Con.Delegado:DE LA OBRA FERRARI CATALINA. Nombramientos. Consejero: GONZALEZ DE LA OBRA MARIA;GONZALEZ DE LA OBRA ANAJULIA;MU脩OZ GIL PEDRO. Presidente: GONZALEZ DE LA OBRA MARIA. Secretario: GONZALEZ DE LA OBRA ANA JULIA.Cons.Del.Man: GONZALEZ DE LA OBRA MARIA;GONZALEZ DE LA OBRA ANA JULIA. Datos registrales. T 13474 , F 198, S 8, HM 117503, I/A 27 (27.06.11).

05 de Enero de 2010
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 1.114.744,76 Euros. Resultante Suscrito: 1.554.350,00 Euros. Datos registrales. T 13474, F 196, S 8, H M 117503, I/A 26 (23.12.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n