Actos BORME de Rivera Campano Sa
07 de Octubre de 2021Cambio de domicilio social. CMNO DE LA ZARZUELA 10 BAJO A (MADRID). Datos registrales. T 30340 , F 59, S 8, H M 117503,I/A 35 (30.09.21).
15 de Septiembre de 2021Modificaciones estatutarias. MODIFICADO EL ARTICULO 15 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.. Datos registrales. T 30340 , F58, S 8, H M 117503, I/A 34 ( 8.09.21).
11 de Agosto de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: GONZALEZ DE LA OBRA MARIA;GONZALEZ DE LA OBRA ANA JULIA;MU脩OZ GIL PEDRO.Presidente: GONZALEZ DE LA OBRA MARIA. Secretario: GONZALEZ DE LA OBRA ANA JULIA. Cons.Del.Man: GONZALEZ DE LAOBRA MARIA;GONZALEZ DE LA OBRA ANA JULIA. Nombramientos. Consejero: GONZALEZ DE LA OBRA MARIA;GONZALEZDE LA OBRA ANA JULIA;MU脩OZ GIL PEDRO. Presidente: GONZALEZ DE LA OBRA MARIA. Secretario: GONZALEZ DE LA OBRAANA JULIA. Cons.Del.Man: GONZALEZ DE LA OBRA ANA JULIA;GONZALEZ DE LA OBRA MARIA. Datos registrales. T 30340 , F57, S 8, H M 117503, I/A 33 ( 4.08.21).
02 de Septiembre de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: GONZALEZ DE LA OBRA MARIA;GONZALEZ DE LA OBRA ANA JULIA;MU脩OZ GIL PEDRO.Presidente: GONZALEZ DE LA OBRA MARIA. Secretario: GONZALEZ DE LA OBRA ANA JULIA. Cons.Del.Man: GONZALEZ DE LAOBRA MARIA;GONZALEZ DE LA OBRA ANA JULIA. Nombramientos. Consejero: GONZALEZ DE LA OBRA MARIA;GONZALEZDE LA OBRA ANA JULIA;MU脩OZ GIL PEDRO. Presidente: GONZALEZ DE LA OBRA MARIA. Secretario: GONZALEZ DE LA OBRAANA JULIA. Cons.Del.Man: GONZALEZ DE LA OBRA MARIA;GONZALEZ DE LA OBRA ANA JULIA. Datos registrales. T 30340 , F57, S 8, H M 117503, I/A 32 (26.08.15).
09 de Octubre de 2013Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 100.016,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.250.048,00 Euros. Datos registrales. T 30340 ,F 56, S 8, H M 117503, I/A 31 ( 1.10.13).
10 de Diciembre de 2012Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ DE LA OBRA MARIA. Datos registrales. T 13474 , F 199, S 8, H M 117503, I/A 29(29.11.12).
Nombramientos. Apoderado: DE LA OBRA FERRARI CATALINA. Datos registrales. T 30340 , F 55, S 8, H M 117503, I/A 30(29.11.12).
31 de Agosto de 2011Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 204.286,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.350.064,00 Euros. Datos registrales. T 13474 ,F 199, S 8, H M 117503, I/A 28 (19.08.11).
07 de Julio de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: DE LA OBRA FERRARI CATALINA;GONZALEZ DE LA OBRA ANA JULIA;GONZALEZ DE LA OBRAMARIA;JOMAI SA. Presidente: DE LA OBRA FERRARI CATALINA. Secretario: GONZALEZ DE LA OBRA ANA JULIA. Con.Delegado:DE LA OBRA FERRARI CATALINA. Nombramientos. Consejero: GONZALEZ DE LA OBRA MARIA;GONZALEZ DE LA OBRA ANAJULIA;MU脩OZ GIL PEDRO. Presidente: GONZALEZ DE LA OBRA MARIA. Secretario: GONZALEZ DE LA OBRA ANA JULIA.Cons.Del.Man: GONZALEZ DE LA OBRA MARIA;GONZALEZ DE LA OBRA ANA JULIA. Datos registrales. T 13474 , F 198, S 8, HM 117503, I/A 27 (27.06.11).
05 de Enero de 2010Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 1.114.744,76 Euros. Resultante Suscrito: 1.554.350,00 Euros. Datos registrales. T 13474, F 196, S 8, H M 117503, I/A 26 (23.12.09).