Actos BORME de Rivulis Irrigation Sociedad Limitada
27 de Diciembre de 2023Reelecciones. Auditor: MOORE ADDVERIS AUDITORES Y CONSULTORES SOCIEDAD LI. Datos registrales. T 721 , F 78, S 8, HCR 23885, I/A 20 (18.12.23).
05 de Septiembre de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: PORTABELLA SENDRA MARC;CIUDAD CEPRIAN CARLOS;ROMAN OLMEDO JESUS;LAVILLAORTEGA CARLOS ANDRES. Datos registrales. T 607 , F 225, S 8, H CR 23885, I/A 19 (30.08.23).
07 de Agosto de 2023Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: NAANDAN JAIN IBERICA, SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 607 , F 159,S 8, H CR 23885, I/A 18 (31.07.23).
25 de Julio de 2023Cambio de domicilio social. POLIG INDUSTRIAL DE MANZANARES, CALLE III, ESQUINA (MANZANARES). Datos registrales. T607 , F 158, S 8, H CR 23885, I/A 17 (19.07.23).
01 de Diciembre de 2022Nombramientos. Auditor: MOORE ADDVERIS AUDITORES Y CONSULTORES SOCIEDAD LI. Datos registrales. T 607 , F 158, S8, H CR 23885, I/A 16 (24.11.22).
14 de Diciembre de 2021Nombramientos. Auditor: MOORE ADDVERIS AUDITORES Y CONSULTORES SOCIEDAD LI. Datos registrales. T 607 , F 158, S8, H CR 23885, I/A 15 ( 1.12.21).
03 de Diciembre de 2020Reelecciones. Auditor: MOORE STEPHENS ADDVERIS AUDITORES Y CONSULTORES SO. Datos registrales. T 607 , F 158, S8, H CR 23885, I/A 14 (25.11.20).
25 de Febrero de 2020Nombramientos. Apo.Manc.: OSSMY ERAN;PORTABELLA SENDRA MARC;CIUDAD CEPRIAN CARLOS;KLAPHOLZRICHARD;EZRA ERAN;KANNOR ALEXANDER. Datos registrales. T 607 , F 156, S 8, H CR 23885, I/A 13 (18.02.20).
24 de Diciembre de 2019Otros conceptos: Modificaci贸n del plazo de vigencia establecido en el apartado 2.9 de la resoluci贸n individual, el cual finalizar谩 el d铆a01/09/2019. Datos registrales. T 607 , F 157, S 8, H CR 23885, I/A Nota I (12.12.19).
30 de Noviembre de 2018Otros conceptos: Subvenci贸n a fondo perdido por un importe de 76.547,36 euros, resultado de aplicar el porcentaje del 8% a lainversi贸n aprobada, de 956.842,00 euros. Datos registrales. T 607 , F 156, S 8, H CR 23885, I/A Nota I (19.11.18).
09 de Mayo de 2018Nombramientos. Auditor: MOORE STEPHENS ADDVERIS AUDITORES Y CONSULTORES SO. Datos registrales. T 607 , F 156,S 8, H CR 23885, I/A 12 (27.04.18).
20 de Abril de 2016Revocaciones. Apoderado: BERNABE LIDDELL TRISTAN. Datos registrales. T 607 , F 156, S 8, H CR 23885, I/A 11 (12.04.16).
26 de Enero de 2016Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 1.771.773,54 Euros. Resultante Suscrito: 1.231.232,46 Euros. Datos registrales. T 586 , F113, S 8, H CR 23885, I/A 10 (18.01.16).
29 de Septiembre de 2015Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: BEN-HAIM RON. Nombramientos. Adm. Unico: KANNOR ALEXANDER. Datos registrales. T586 , F 113, S 8, H CR 23885, I/A 9 (18.09.15).
26 de Noviembre de 2014Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 586 , F 113, S 8, H CR 23885, I/A 8
14 de Noviembre de 2014Nombramientos. Apo.Sol.: PORTABELLA SENDRA MARC;ROMAN OLMEDO JESUS. Datos registrales. T 586 , F 112, S 8, H CR23885, I/A 6 (31.10.14).
Otros conceptos: SE MODIFICA el ARTICULO 12 de los Estatutos Sociales referente al cierre del ejercicio social. Datosregistrales. T 586 , F 112, S 8, H CR 23885, I/A 7 (31.10.14).
03 de Octubre de 2014Revocaciones. Apo.Sol.: HERNANDO REVUELTA CARLOS. Apoderado: ARGI RONY. Datos registrales. T 586 , F 112, S 8, H CR23885, I/A 5 (24.09.14).