Buscador CIF Logo

Actos BORME Roche Sociedad Anonima Municipal

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Roche Sociedad Anonima Municipal

Actos BORME Roche Sociedad Anonima Municipal - A11004082

Tenemos registrados 27 Actos BORME del Registro Mercantil de Cadiz para Roche Sociedad Anonima Municipal con CIF A11004082

🔙 Perfil de Roche Sociedad Anonima Municipal
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Cadiz

Actos BORME de Roche Sociedad Anonima Municipal

10 de Noviembre de 2023
Nombramientos. Auditor: BRAINSTORMIGN AUDIT SL. Datos registrales. T 2200 , F 162, S 8, H CA 13343, I/A 44 (24.10.23).

27 de Septiembre de 2023
Revocaciones. Apo.Man.Soli: LAURA SERRANO ROMERO. Datos registrales. T 2200 , F 160, S 8, H CA 13343, I/A 40 (19.09.23).

Ceses/Dimisiones. Vicesecret.: JOSE ANTONIO FERNANDEZ ENRIQUEZ. D. Gerente: JOSE ANTONIO FERNANDEZ ENRIQUEZ.Revocaciones. Apoderado: JOSE ANTONIO FERNANDEZ ENRIQUEZ. Datos registrales. T 2200 , F 160, S 8, H CA 13343, I/A 41(19.09.23).

Ceses/Dimisiones. Consejero: JUAN ANTONIO RODRIGUEZ ALMAGRO. Datos registrales. T 2200 , F 161, S 8, H CA 13343, I/A42 (19.09.23).

Ceses/Dimisiones. Consejero: JUAN MANUEL BERMUDEZ ESCAMEZ;ATILANO CORRALES MARISCAL;JUANA SANCHEZROMERO;JOSE PEREZ PIÑA;PETRONILA GONZALEZ OLMEDO;LAURA SANCHEZ MUÑOZ;MARIA DEL CARMEN GARCIACARO;ALONSO CAMACHO NAHARRO. Presidente: JUAN MANUEL BERMUDEZ ESCAMEZ. Nombramientos. Consejero:INMACULADA SANCHEZ ZARA. Presidente: INMACULADA SANCHEZ ZARA. Consejero: ANTONIO JESUS ARAGONDORCA;SERGIO CACERES BASALLOTE;GREGORIO CALDERON DE ALBA;DANIEL GONZALEZ FERNANDEZ;FRANCISCOPEÑA AGUILAR;MANUEL MARIN TRUJILLO;DIEGO AMAYA GONZALEZ;MARIA FUENSANTA UREBA RUBIO. Datos registrales.T 2200 , F 161, S 8, H CA 13343, I/A 43 (19.09.23).

19 de Julio de 2023
Otros conceptos: Inscripción de Ampliación de Facultades del Directo Gerente. Datos registrales. T 2200 , F 159, S 8, H CA 13343,I/A 39 (12.07.23).

07 de Junio de 2023
Modificaciones estatutarias. Artículo 22º.- Resumen. Nuevo ARTICULO 22 BIS: Resumen. Cambio de objeto social. La sociedadse constituye como medio propio y servicio técnico del Ayuntamiento de Conil de la Frontera y sus entidades y organismos públicos, enlos términos contemplados en la Ley de Contratos del Sector Público y demás normativa que la complemente, desarrolle o sustituya,para cualquier encomiend. Datos registrales. T 2200 , F 158, S 8, H CA 13343, I/A 38 (29.05.23).

16 de Octubre de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: BERMUDEZ ESCAMEZ JUAN MANUEL. Presidente: BERMUDEZ ESCAMEZ JUAN MANUEL.Consejero: GONZALEZ OLMEDO PETRONILA;PEREZ PIÑA JOSE;SANCHEZ ROMERO JUANA;ALBA RAMIREZ ANTONIO;MUÑOZARAGON MARIA DEL CARMEN;GUERRERO RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE;UREBA SANCHEZ JOSE ANTONIO;CORRALESMARISCAL ATILANO. Nombramientos. Consejero: BERMUDEZ ESCAMEZ JUAN MANUEL;GARCIA CARO MARIA DELCARMEN;SANCHEZ MUÑOZ LAURA;GONZALEZ OLMEDO PETRONILA;PEREZ PIÑA JOSE;SANCHEZ ROMEROJUANA;CORRALES MARISCAL ATILANO;RODRIGUEZ ALMAGRO JUAN ANTONIO;CAMACHO NAHARRO ALONSO. Presidente:BERMUDEZ ESCAMEZ JUAN MANUEL. Datos registrales. T 2200 , F 157, S 8, H CA 13343, I/A 37 ( 4.10.19).

18 de Junio de 2018
Nombramientos. Apoderado: AMAYA ROSADO JOSE MANUEL. Gerente: AMAYA ROSADO JOSE MANUEL. Datos registrales. T2200 , F 157, S 8, H CA 13343, I/A 36 ( 7.06.18).

29 de Marzo de 2017
Nombramientos. Consejero: CORRALES MARISCAL ATILANO. Datos registrales. T 2200 , F 156, S 8, H CA 13343, I/A 35(22.03.17).

23 de Marzo de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: ALBA ARAGON ERNESTO. Datos registrales. T 2200 , F 156, S 8, H CA 13343, I/A 34 (14.03.17).

09 de Diciembre de 2016
Cambio de objeto social. La Sociedad se constituye como medio propio y servicio técnico del Ayuntamiento de Conil de la Frontera.Las encomiendas que se le puedan conferir y la adjudicación de los contratos que se le puedan hacer por el Ayuntamiento de Conil dela Frontera, deberán contar con el correspondiente acuerdo de e. Datos registrales. T 2200 , F 156, S 8, H CA 13343, I/A 33(30.11.16).

06 de Julio de 2016
Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ ENRIQUEZ JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 2200 , F 155, S 8, H CA 13343, I/A32 (29.06.16).

16 de Junio de 2016
Nombramientos. Consejero: MUÑOZ ARAGON MARIA DEL CARMEN;GUERRERO RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE. Datosregistrales. T 2084 , F 182, S 8, H CA 13343, I/A 31 (31.05.16).

08 de Junio de 2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: LOPEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL;MESA VARELA ANTONIO;LEAL DE LA FLOR FRANCISCOJAVIER;SENA TRUJILLLO MARIA DE LA LUZ;SERRANO ROMERO LAURA. Vicepresid.: SERRANO ROMERO LAURA. Consejero:BERMUDEZ ESCAMEZ JUAN MANUEL. Presidente: BERMUDEZ ESCAMEZ JUAN MANUEL. Con.Delegado: BERMUDEZESCAMEZ JUAN MANUEL. Consejero: SANCHEZ MUÑOZ LAURA;PUENTE LEAL MANUELA;GONZALEZ OLMO PETRONILA.Nombramientos. Consejero: BERMUDEZ ESCAMEZ JUAN MANUEL. Presidente: BERMUDEZ ESCAMEZ JUAN MANUEL.Consejero: GONZALEZ OLMEDO PETRONILA;PEREZ PIÑA JOSE;SANCHEZ ROMERO JUANA;ALBA RAMIREZ ANTONIO;UREBASANCHEZ JOSE ANTONIO;ALBA ARAGON ERNESTO. Datos registrales. T 2084 , F 182, S 8, H CA 13343, I/A 30 (31.05.16).

22 de Julio de 2014
Nombramientos. Apo.Man.Soli: SERRANO ROMERO LAURA. Datos registrales. T 2084 , F 180, S 8, H CA 13343, I/A 28 (8.07.14).

Ceses/Dimisiones. Consejero: ROMAN CABRERA PILAR. Nombramientos. Consejero: GONZALEZ OLMO PETRONILA.Modificaciones estatutarias. Artículo 1º.- . PREAMBULO. . Artículo 4º.-. DISPOSICION FINAL. Artículo 35. . Cambio de domiciliosocial. AVDA DOLORES IBARRURI 2 LOCAL D (CONIL DE LA FRONTERA). Cambio de objeto social. Es objeto de la sociedad.a) La promoción y gestión de urbanizaciones, con independencia del sistema que se adopte, para la elaboración y ejecución delplaneamiento urbanístico, actuando por sí o para terceros, en cualquier lugar del termino municipal, incluso ejerciendo la figura delagente urbani. Datos registrales. T 2084 , F 181, S 8, H CA 13343, I/A 29 ( 8.07.14).

21 de Marzo de 2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: AMADO BRENES JUAN;DE ALBA AMAYA FRANCISCO JAVIER. Nombramientos. Consejero:SANCHEZ MUÑOZ LAURA;PUENTE LEAL MANUELA. Datos registrales. T 2084 , F 179, S 8, H CA 13343, I/A 27 (14.03.14).

07 de Junio de 2013
Nombramientos. Vicepresid.: SERRANO ROMERO LAURA. Consejero: BERMUDEZ ESCAMEZ JUAN MANUEL. Presidente:BERMUDEZ ESCAMEZ JUAN MANUEL. Con.Delegado: BERMUDEZ ESCAMEZ JUAN MANUEL. Consejero: ROMAN CABRERAPILAR. Datos registrales. T 1161 , F 20, S 8, H CA 13343, I/A 26 (30.05.13).

26 de Febrero de 2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: JURGEN HIPP HERMANN. Presidente: ROLDAN MUÑOZ ANTONIO JESUS. Datos registrales. T1161 , F 20, S 8, H CA 13343, I/A 25 (13.02.13).

28 de Octubre de 2011
Modificaciones estatutarias. Artículo 13.- CUORUM Y ACUERDOS.- 1. Para la válida constitución de la Junta, será necesaria laasistencia de un tercio de los miembros de la misma, cuorum que deberá mantenerse durante toda la sesión. 2. Los acuerdos de laJunta General se adoptarán por mayoría simple, con las siguientes. Datos registrales. T 1161 , F 19, S 8, H CA 13343, I/A 23(19.10.11).

Ceses/Dimisiones. Consejero: ROLDAN MUÑOZ ANTONIO JESUS. Presidente: ROLDAN MUÑOZ ANTONIO JESUS. Consejero:RAMIREZ SANCHEZ BARTOLOME;LOPEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL;TRUJILLO GOMEZ JOSE ANTONIO;AMADO BRENES JUAN.Con.Delegado: ROLDAN MUÑOZ ANTONIO JESUS;AMADO BRENES JUAN. Consejero: ALBA SANCHEZ FRANCISCO;SANCHEZDE ALBA JOSE ANTONIO;LEAL DE LA FLOR SALVADOR;JURGEN HIPP HERMANN. Nombramientos. Consejero: LOPEZ LOPEZMIGUEL ANGEL;ROLDAN MUÑOZ ANTONIO JESUS;AMADO BRENES JUAN;MESA VARELA ANTONIO;DE ALBA AMAYAFRANCISCO JAVIER;JURGEN HIPP HERMANN;LEAL DE LA FLOR FRANCISCO JAVIER;SENA TRUJILLLO MARIA DE LALUZ;SERRANO ROMERO LAURA. Presidente: ROLDAN MUÑOZ ANTONIO JESUS. Datos registrales. T 1161 , F 19, S 8, H CA13343, I/A 24 (19.10.11).

16 de Agosto de 2011
Nombramientos. D. Gerente: FERNANDEZ ENRIQUEZ JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 1161 , F 18, S 8, H CA 13343, I/A 22( 4.08.11).

03 de Enero de 2011
Nombramientos. Consejero: ALBA SANCHEZ FRANCISCO;SANCHEZ DE ALBA JOSE ANTONIO;LEAL DE LA FLORSALVADOR;JURGEN HIPP HERMANN. Modificaciones estatutarias. Artículo 15.- COMPOSICION. 1º.- El Consejo deAdministración estará integrado por nueve miembros (Presidente y ocho vocalías) designados por la Junta General, de los cuales tresserán miembros del Ayuntamiento (el Alcalde y dos Concejales) y los seis restantes, personas especialmente capacitadas. Datosregistrales. T 1161 , F 18, S 8, H CA 13343, I/A 21 (22.12.10).

29 de Septiembre de 2010
Ceses/Dimisiones. Secretario: RODRIGUEZ DIAZ MARIA LUZ. Vicesecret.: SERRANO BRAVO JOSE ANTONIO. Secretario:FERNANDEZ ENRIQUEZ JOSE ANTONIO. Nombramientos. Secretario: FERNANDEZ ENRIQUEZ JOSE ANTONIO;CAMBASDIESTRO MARIA DEL CARMEN. Vicesecret.: FERNANDEZ ENRIQUEZ JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 1161 , F 17, S 8, HCA 13343, I/A 20 ( 9.09.10).

06 de Mayo de 2010
Nombramientos. Auditor: AUDIHISPANA SUR SL. Datos registrales. T 1161 , F 17, S 8, H CA 13343, I/A 19 (22.04.10).

15 de Diciembre de 2009
Nombramientos. Con.Delegado: ROLDAN MUÑOZ ANTONIO JESUS;AMADO BRENES JUAN. Datos registrales. T 1161 , F 15, S8, H CA 13343, I/A 18 ( 2.12.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información