Buscador CIF Logo

Actos BORME Rodman Enterprises Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Rodman Enterprises Sl

Actos BORME Rodman Enterprises Sl - B29787355

Tenemos registrados 9 Actos BORME del Registro Mercantil de Barcelona para Rodman Enterprises Sl con CIF B29787355

馃敊 Perfil de Rodman Enterprises Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Barcelona

Actos BORME de Rodman Enterprises Sl

20 de Diciembre de 2016
Revocaciones. LIQUIDADOR: JEAN FRANCOIS YVON ESNAULT. Extinci贸n. Datos registrales. T 41104 , F 117, S 8, H B379110, I/A 15 (12.12.16).

24 de Febrero de 2015
Revocaciones. CONSEJERO: ANNE MARIE THERESE ESNAULT;JEAN FRANCOISE YVON ESNAULT;DOROTHEE JULIEALEXANDRA BRUET EP SAUSSEZ. PRESIDENTE: JEAN FRANCOIS YVON ESNAULT. CONS. DELEG.: JEAN FRANCOIS YVONESNAULT. SECR.NO CONS: SERRA ALBO JUDITH. Nombramientos. LIQUIDADOR: JEAN FRANCOIS YVON ESNAULT.Disoluci贸n. Voluntaria. Datos registrales. T 41104 , F 117, S 8, H B 379110, I/A 14 (16.02.15).

07 de Agosto de 2013
Modificaciones estatutarias. ART.8:CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL. Datos registrales. T 41104 , F 116, S 8, H B379110, I/A 13 (30.07.13).

28 de Junio de 2012
Revocaciones. CONSEJERO: VERONIQUE GABRIELLE ESNAULT. Datos registrales. T 41104 , F 116, S 8, H B 379110, I/A 12(18.06.12).

12 de Mayo de 2011
Revocaciones. SECR.NO CONS: SALLES VANCELLS ANNA. Nombramientos. CONS. DELEG.: JEAN FRANCOIS YVONESNAULT. SECR.NO CONS: SERRA ALBO JUDITH. Datos registrales. T 41104 , F 116, S 8, H B 379110, I/A 11 ( 2.05.11).

27 de Enero de 2011
Nombramientos. APODERADO: SERRA ALBO MIREIA;SERRA ALBO JUDITH;SALLES VANCELLS ANNA;GIL RAMON XAVIER.Datos registrales. T 41104 , F 115, S 8, H B 379110, I/A 10 (14.01.11).

23 de Diciembre de 2010
Revocaciones. PRESIDENTE: DOROTHEE JULIE ALEXANDRA BRUET EP SAUSSEZ. VICEPRESIDEN: JEAN FRANCOISE YVONESNAULT. Nombramientos. PRESIDENTE: JEAN FRANCOIS YVON ESNAULT. Datos registrales. T 41104 , F 115, S 8, H B379110, I/A 9 (13.12.10).

02 de Abril de 2009
Cambio de domicilio social. CL ARQUIMEDES Num.155 P.2 PTA.B (TERRASSA). Datos registrales. T 41104 , F 115, S 8, H B379110, I/A 8 (17.03.09).

10 de Febrero de 2009
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: SPIER JEANINE. Nombramientos. Consejero: ESNAULT ANNE MARIE THERESE;ESNAULTJEAN FRANCOISE YVON;ESNAULT VERONIQUE GABRIELLE;EP SAUSSEZ DOROTHEE JULIE ALEXANDRA BUET. Presidente:EP SAUSSEZ DOROTHEE JULIE ALEXANDRA BUET. Vicepresid.: ESNAULT JEAN FRANCOISE YVON. SecreNoConsj: SALLESVANCELLS ANNA. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Consejo deadministraci贸n.Adici贸n del art铆culo 9 bis a los estatutos sociales. Datos registrales. T 1846, L 759, F 78, S 8, H MA 24956, I/A 7(21.01.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n