Buscador CIF Logo

Actos BORME Roldan Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Roldan Sa

Actos BORME Roldan Sa - A28073963

Tenemos registrados 36 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Roldan Sa con CIF A28073963

馃敊 Perfil de Roldan Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Roldan Sa

26 de Octubre de 2023
Revocaciones. Apoderado: VAZQUEZ DEL CAMPO JORGE. Nombramientos. Apo.Sol.: VAZQUEZ DEL CAMPO JORGE. Datosregistrales. T 31346 , F 27, S 8, H M 101170, I/A 175 (19.10.23).

Revocaciones. Apo.Man.Soli: WOLFE GOMEZ OSWALD. Nombramientos. Apo.Sol.: CAMOS GARCIA ESTHER;MANZANERODE LA IGLESIA RAQUEL. Datos registrales. T 31346 , F 28, S 8, H M 101170, I/A 176 (19.10.23).

04 de Octubre de 2023
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 31346 , F 27, S 8, H M 101170, I/A174 (27.09.23).

27 de Julio de 2023
Reelecciones. Adm. Mancom.: FERRANDIS TORRES MIGUEL;HELMRICH HANS. Datos registrales. T 31346 , F 27, S 8, H M101170, I/A 173 (20.07.23).

05 de Diciembre de 2022
Revocaciones. Apo.Sol.: PANTOJA CAMACHO ANTONIO. Apo.Man.Soli: PANTOJA CAMACHO ANTONIO-JESUS;GABALDONFOLLA JUAN. Apo.Sol.: PANTOJA CAMACHO ANTONIO-JESUS;PINILLA PAGNON ALEJANDRA. Nombramientos. Apoderado:LOPEZ VEGA RUBEN LUIS;VAZQUEZ DEL CAMPO JORGE. Datos registrales. T 31346 , F 25, S 8, H M 101170, I/A 171(28.11.22).

Nombramientos. Apoderado: BELTEJAR CAMPOS JESUS. Datos registrales. T 31346 , F 26, S 8, H M 101170, I/A 172 (28.11.22).

29 de Septiembre de 2022
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 31346 , F 25, S 8, H M 101170, I/A170 (22.09.22).

01 de Agosto de 2022
Reelecciones. Adm. Mancom.: FERRANDIS TORRES MIGUEL;HELMRICH HANS. Datos registrales. T 31346 , F 25, S 8, H M101170, I/A 169 (22.07.22).

22 de Abril de 2022
Nombramientos. Apoderado: DAFAUCE BUENO MARIA-LUISA. Datos registrales. T 31346 , F 25, S 8, H M 101170, I/A 168(13.04.22).

12 de Abril de 2022
Revocaciones. Apo.Man.Soli: MORENO ZORRILLA ANTONIO. Nombramientos. Apoderado: PINDADO RODRIGUEZ JOSEANGEL. Datos registrales. T 31346 , F 24, S 8, H M 101170, I/A 167 ( 5.04.22).

27 de Septiembre de 2021
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 31346 , F 24, S 8, H M 101170, I/A166 (20.09.21).

06 de Septiembre de 2021
Nombramientos. Apo.Manc.: DE LA ROCHA SUANZES ANA MARIA;GONZALEZ DURAN ENRIQUE;SANCHEZ SAIZ IVAN;PEREZMORANTE CARLOS;PINTO RODRIGUEZ JUAN PEDRO;AGUIRRE CADARSO JORGE. Datos registrales. T 31346 , F 24, S 8, H M101170, I/A 165 (30.08.21).

23 de Julio de 2021
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: MORENO ZORRILLA ANTONIO. Nombramientos. Adm. Mancom.: HELMRICH HANS.Reelecciones. Adm. Mancom.: FERRANDIS TORRES MIGUEL. Datos registrales. T 31346 , F 23, S 8, H M 101170, I/A 164(16.07.21).

05 de Octubre de 2020
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 31346 , F 23, S 8, H M 101170, I/A163 (28.09.20).

16 de Julio de 2020
Reelecciones. Adm. Mancom.: FERRANDIS TORRES MIGUEL;MORENO ZORRILLA ANTONIO. Datos registrales. T 31346 , F 22,S 8, H M 101170, I/A 162 ( 9.07.20).

23 de Julio de 2019
Reelecciones. Adm. Mancom.: FERRANDIS TORRES MIGUEL;MORENO ZORRILLA ANTONIO. Datos registrales. T 31346 , F 22,S 8, H M 101170, I/A 161 (16.07.19).

19 de Julio de 2018
Reelecciones. Adm. Mancom.: FERRANDIS TORRES MIGUEL;MORENO ZORRILLA ANTONIO. Datos registrales. T 31346 , F 22,S 8, H M 101170, I/A 160 (12.07.18).

06 de Febrero de 2018
Revocaciones. Apoderado: RODRIGUEZ ROVIRA JORGE;PINEDA NIETO ALFONSO;VELAZQUEZ HERREROSBERNARDO;FERRANDIS TORRES MIGUEL;MASI SAINZ DE LOS TERREROS JOSE LUIS;CARRASCOSA OZORES JUANCARLOS;PANTOJA CAMACHO ANTONIO-JESUS;WOLFE GOMEZ OSWALD;ALONSO DE NORIEGA MU脩IZ MARIALUCIA;VELAZQUEZ HERREROS BERNARDO;FERRANDIS TORRES MIGUEL;MASI SAINZ DE LOS TERREROS JOSELUIS;CARRASCOSA OZORES JUAN CARLOS;WOLFE GOMEZ OSWALD;ALONSO DE NORIEGA MU脩IZ MARIA LUCIA;GARCIADE LA FUENTE JUAN;VALENCIA DIAZ JOSE CARLOS. Apo.Man.Soli: RODRIGUEZ ROVIRA JORGE;PINEDA NIETOALFONSO;PANTOJA CAMACHO ANTONIO-JESUS;BLANCO GONZALEZ ROBERTO;GABALDON FOLLA JUAN;GONZALEZGONZALEZ FERNANDO;RODRIGUEZ MARTINEZ NESTOR. Apoderado: GIMENO VALLEDOR LUIS;GARCIA-VEGA REDONDORODRIGO;CASTILLO PLAZA CARLOS-AUGUSTO;HERRERO DE HOYOS BLANCA. Nombramientos. Apo.Man.Soli: VELAZQUEZHERREROS BERNARDO;FERRANDIS TORRES MIGUEL;GIMENO VALLEDOR LUIS;AZPITARTE ZEMP DANIEL TOMAS;MORENOZORRILLA ANTONIO;WOLFE GOMEZ OSWALD;RODRIGUEZ ROVIRA JORGE;GARCIA DE LA FUENTE JUAN;VACA ESCOLANOISABEL MARIA;CAMOS GARCIA ESTHER;DIAZ-URGORRI EMPARANZA EMILIO;GARCIA VEGA REDONDORODRIGO;GUTIERREZ GONZALEZ FERNANDO;GUTIERREZ MAS LUIS;PANTOJA CAMACHO ANTONIO-JESUS;PINEDA NIETOALFONSO;BLANCO GONZALEZ ROBERTO;GABALDON FOLLA JUAN;GONZALEZ GONZALEZ FERNANDO;RODRIGUEZMARTINEZ NESTOR;VAZQUEZ DEL CAMPO JORGE. Apo.Sol.: PANTOJA CAMACHO ANTONIO-JESUS;GARCIA VEGAREDONDO RODRIGO;CASTILLO PLAZA CARLOS;BLANCA HERRERO DE HOYOS;PINILLA PAGNONALEJANDRA;ECHAVARREN CRESPO JAVIER JOSE;LOPEZ IGUALADA ANTONIO. Datos registrales. T 31346 , F 19, S 8, H M101170, I/A 159 (30.01.18).

07 de Septiembre de 2017
Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 31346 , F 18, S 8, H M 101170,I/A 158 (31.08.17).

04 de Septiembre de 2017
Modificaciones estatutarias. Modificaci贸n del art铆culo 19潞 de los estatutos sociales. Datos registrales. T 31346 , F 18, S 8, H M101170, I/A 157 (28.08.17).

04 de Agosto de 2016
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 31346 , F 18, S 8, H M 101170, I/A 156 (27.07.16).

27 de Julio de 2015
Modificaciones estatutarias. Modificacion de los articulos 11, 12, 22, 25 y derogacion del articulo 29 de los estatutos sociales yrefundicion de la totalidad de los estatutos sociales. . Datos registrales. T 31346 , F 15, S 8, H M 101170, I/A 154 (17.07.15).

Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 31346 , F 17, S 8, H M 101170, I/A 155 (17.07.15).

25 de Julio de 2014
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 31346 , F 15, S 8, H M 101170, I/A 153(17.07.14).

13 de Septiembre de 2013
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 31346 , F 15, S 8, H M 101170, I/A 152 (4.09.13).

09 de Septiembre de 2013
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: MASI SAINZ DE LOS TERREROS JOSE LUIS. Nombramientos. Adm. Mancom.: MORENOZORRILLA ANTONIO. Reelecciones. Adm. Mancom.: FERRANDIS TORRES MIGUEL. Datos registrales. T 14206 , F 170, S 8, HM 101170, I/A 151 (30.08.13).

18 de Abril de 2013
Nombramientos. Apo.Sol.: RODRIGUEZ ROVIRA JORGE;BLANCO GONZALEZ ROBERTO. Datos registrales. T 14206 , F 170, S8, H M 101170, I/A 150 (10.04.13).

13 de Agosto de 2012
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 14206 , F 170, S 8, H M 101170, I/A 149(31.07.12).

20 de Febrero de 2012
Revocaciones. Apoderado: HERRERO GARCIA DAVID;GUARNER MU脩OZ JORGE;CARRASCOSA OZORES JUANCARLOS;FERNANDEZ ARIAS MANUEL ANGEL;RODRIGUEZ ROVIRA JORGE;FERNANDEZ ARIAS MANUEL ANGEL;FERNANDEZARIAS MANUEL ANGEL;RIESTRA PITA JOSE;RIESTRA PITA JOSE. Nombramientos. Apo.Man.Soli: RODRIGUEZ ROVIRAJORGE;PINEDA NIETO ALFONSO;PANTOJA CAMACHO ANTONIO-JESUS;BLANCO GONZALEZ ROBERTO;GABALDON FOLLAJUAN;GONZALEZ GONZALEZ FERNANDO;RODRIGUEZ MARTINEZ NESTOR. Apoderado: GIMENO VALLEDOR LUIS;GARCIA-VEGA REDONDO RODRIGO;CASTILLO PLAZA CARLOS-AUGUSTO;HERRERO DE HOYOS BLANCA;LOPEZ IGUALADAANTONIO. Datos registrales. T 14206 , F 168, S 8, H M 101170, I/A 148 ( 9.02.12).

15 de Febrero de 2012
Modificaciones estatutarias. INCLUIDO EN LOS ESTATUTOS SOCIALES EL ARTICULO 14-BIS DE NUEVA CREACION. Datosregistrales. T 14206 , F 168, S 8, H M 101170, I/A 147 ( 3.02.12).

11 de Agosto de 2011
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 14206 , F 168, S 8, H M 101170, I/A 146 (2.08.11).

23 de Diciembre de 2010
Nombramientos. Apo.Sol.: GIMENO VALLEDOR LUIS;GARCIA VEGA REDONDO RODRIGO;PANTOJA CAMACHO ANTONIO.Datos registrales. T 14206 , F 167, S 8, H M 101170, I/A 145 (10.12.10).

13 de Agosto de 2010
Modificaciones estatutarias. MODIFICADOS LOS ARTS. 6 Y 14 DE LOS ESTATUTOS.. Otros conceptos: MODIFICADA LAFORMA DE REPRESENTACION DE LAS ACCIONES, QUEPASAN A SER NOMINATIVAS, MODIFICANDO ASIMISMO ELARTICULO 6潞 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 14206 , F 166, S 8, H M 101170, I/A 144 ( 4.08.10).

10 de Agosto de 2010
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 14206 , F 166, S 8, H M 101170, I/A 143(29.07.10).

24 de Marzo de 2009
Revocaciones. Apoderado: HERRERO GARCIA DAVID;HERRERO GARCIA DAVID;CARRASCOSA OZORES JUANCARLOS;CARRASCOSA OZORES JUAN CARLOS;MU脩OZ CAMOS CATALINA;MU脩OZ CAMOS CATALINA;MU脩OZ CAMOSVICTORIANO;MU脩OZ CAMOS VICTORIANO;FERRANDIS TORRES MIGUEL;FERRANDIS TORRES MIGUEL;PANTOJA CAMACHOANTONIO JESUS;PANTOJA CAMACHO ANTONIO JESUS;FERNANDEZ ARIAS MANUEL ANGEL. Nombramientos. Apoderado:VELAZQUEZ HERREROS BERNARDO;FERRANDIS TORRES MIGUEL;MASI SAINZ DE LOS TERREROS JOSELUIS;CARRASCOSA OZORES JUAN CARLOS;FERNANDEZ ARIAS MANUEL ANGEL;RIESTRA PITA JOSE;PANTOJA CAMACHOANTONIO JESUS;WOLFE GOMEZ OSWALD;ALONSO DE NORIEGA MU脩IZ MARIA LUCIA;VELAZQUEZ HERREROSBERNARDO;FERRANDIS TORRES MIGUEL;MASI SAINZ DE LOS TERREROS JOSE LUIS;CARRASCOSA OZORES JUANCARLOS;RIESTRA PITA JOSE;WOLFE GOMEZ OSWALD;ALONSO DE NORIEGA MU脩IZ MARIA LUCIA;GARCIA DE LA FUENTEJUAN;VALENCIA DIAZ JOSE CARLOS. Datos registrales. T 14206 , F 164, S 8, H M 101170, I/A 142 (11.03.09).

19 de Enero de 2009
Ceses/Dimisiones. Secretario: HERRERO GARCIA DAVID. Consejero: FERRANDIS TORRES MIGUEL. Presidente: MU脩OZ CAVAVICTORIANO. Consejero: MU脩OZ CAVA VICTORIANO;MU脩OZ CAMOS VICTORIANO;NARANJO OLMEDO RAFAEL;LOPEZ DE LAPARTE MANUEL;VELAZQUEZ HERREROS BERNARDO;LEJEUNE CASTRILLO JOSE LUIS;RIESTRA PITA JOSEMARIA;ROBLEDANO GASCON ALFREDO;HERRERO GARCIA DAVID;MASI SAINZ DE LOS TERREROS JOSE LUIS.Nombramientos. Adm. Mancom.: MASI SAINZ DE LOS TERREROS JOSE LUIS;FERRANDIS TORRES MIGUEL. Modificacionesestatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administradores mancomunados. Otrosconceptos: COMO CONSECUENCIA DEL CAMBIO DE ORGANO DE ADMINISTRACION SEMODIFICAN Y SUPRIMEN ALGUNOSARTICULOS, DANDOSE UNA NUEVA REDACCION A LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 14206 , F 163, S 8, H M101170, I/A 141 ( 7.01.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n