Actos BORME de Romero Hormelec Sa
10 de Mayo de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: ARROYO ORDO脩EZ JOSE MANUEL;VALDIVIESO PASTOR DICTINIO. Datos registrales. T 41442 , F63, S 8, H M 734361, I/A 5 (30.04.21).
07 de Mayo de 2021Nombramientos. Apoderado: FUENTES ARROYO GASPAR. Datos registrales. T 41442 , F 63, S 8, H M 734361, I/A 4 (29.04.21).
04 de Mayo de 2021Revocaciones. Apoderado: GRAN HERRERIAS EMILIO;LALAGUNA BOSQUED FRANCISCO. Datos registrales. T 41442 , F 62, S8, H M 734361, I/A 3 (26.04.21).
11 de Febrero de 2021Cambio de domicilio social. C/ MAURICIO LEGENDRE 16 OFICINA 2122 - EDIFICIO CE (MADRID). Datos registrales. T 41442 ,F 62, S 8, H M 734361, I/A 2 ( 4.02.21).
17 de Noviembre de 2020Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: PROYECTOS FERROVIARIOS SL. Nombramientos. Adm. Unico: MIMBRAJADA SL. Datosregistrales. T 2841 , F 7, S 8, H Z 7084, I/A 42 ( 9.11.20).
08 de Mayo de 2020Ceses/Dimisiones. D. Gerente: ARBIDE PORTUGAL RAIMUNDO. Datos registrales. T 2841 , F 7, S 8, H Z 7084, I/A 41 (29.04.20).
10 de Agosto de 2017Reelecciones. Adm. Unico: PROYECTOS FERROVIARIOS SL. Datos registrales. T 2841 , F 7, S 8, H Z 7084, I/A 40 ( 1.08.17).
23 de Noviembre de 2016Revocaciones. Apoderado: ROMERO EGUILUZ RAMON;JARA SORIA JOSE CARLOS;GARCIA RAMOS OSCAR;ARBIDEPORTUGAL RAIMUNDO;RODRIGUEZ CLAVER RICARDO. Datos registrales. T 2841 , F 7, S 8, H Z 7084, I/A 39 (15.11.16).
17 de Febrero de 2016Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 450.750,00 Euros. Desembolsado: 450.750,00 Euros. Resultante Suscrito: 955.590,00 Euros.Resultante Desembolsado: 955.590,00 Euros. Datos registrales. T 2841 , F 6, S 8, H Z 7084, I/A 38 ( 9.02.16).
09 de Abril de 2015Otros conceptos: Cesado Don RAIMUNDO ARBIDE PORTUGAL, como persona f铆sica representante del Administrador Unico"PROYECTOS FERROVIARIOS, S. L." y designado nuevo representante persona f铆sica a DON EMILIO GRAN HERRERIAS. Datosregistrales. T 2841 , F 6, S 8, H Z 7084, I/A 37 (30.03.15).
11 de Octubre de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: ARBIDE PORTUGAL RAIMUNDO. Presidente: ARBIDE PORTUGAL RAIMUNDO. Consejero:JUAREZ TOME JOSE. Secretario: JUAREZ TOME JOSE. Consejero: GARCIA MORENO ENRIQUE. Vicepresid.: GARCIA MORENOENRIQUE. Nombramientos. Adm. Unico: PROYECTOS FERROVIARIOS SL. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo deAdministraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 2841 , F 6, S 8, H Z 7084, I/A 36 ( 1.10.12).
06 de Septiembre de 2011Nombramientos. Apoderado: LALAGUNA BOSQUED FRANCISCO. Datos registrales. T 2566 , F 104, S 8, H Z 7084, I/A 35(25.08.11).
10 de Marzo de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: JUAREZ TOME JOSE. Secretario: JUAREZ TOME JOSE. Vicepresid.: GARCIA MORENO ENRIQUE.Consejero: GARCIA MORENO ENRIQUE;ARBIDE PORTUGAL RAIMUNDO. Presidente: ARBIDE PORTUGAL RAIMUNDO.Nombramientos. Consejero: ARBIDE PORTUGAL RAIMUNDO. Presidente: ARBIDE PORTUGAL RAIMUNDO. Consejero: JUAREZTOME JOSE. Secretario: JUAREZ TOME JOSE. Consejero: GARCIA MORENO ENRIQUE. Vicepresid.: GARCIA MORENOENRIQUE. Datos registrales. T 2566 , F 104, S 8, H Z 7084, I/A 34 ( 1.03.11).
05 de Febrero de 2010Nombramientos. Apoderado: GRAN HERRERIAS EMILIO. Datos registrales. T 2566 , F 104, S 8, H Z 7084, I/A 33 (27.01.10).
07 de Agosto de 2009Ceses/Dimisiones. Dir. General: ARBIDE PORTUGAL RAIMUNDO. Datos registrales. T 2566 , F 104, S 8, H Z 7084, I/A 32(29.07.09).
03 de Julio de 2009Revocaciones. Apoderado: RUIZ SANJOAQUIN JOSE. Datos registrales. T 2566 , F 103, S 8, H Z 7084, I/A 30 (24.06.09).
Revocaciones. Apoderado: MATEO IBA脩EZ LUIS. Datos registrales. T 2566 , F 103, S 8, H Z 7084, I/A 31 (24.06.09).
26 de Mayo de 2009Revocaciones. Apoderado: MATEO IBA脩EZ LUIS. Datos registrales. T 2566 , F 103, S 8, H Z 7084, I/A 29 (15.05.09).
02 de Febrero de 2009Nombramientos. Auditor: CGM AUDITORES SL. Datos registrales. T 2566 , F 103, S 8, H Z 7084, I/A 28 (21.01.09).