Buscador CIF Logo

Actos BORME Romovil Sociedad Anonima

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Romovil Sociedad Anonima

Actos BORME Romovil Sociedad Anonima - A02155208

Tenemos registrados 10 Actos BORME del Registro Mercantil de Albacete para Romovil Sociedad Anonima con CIF A02155208

🔙 Perfil de Romovil Sociedad Anonima
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Albacete

Actos BORME de Romovil Sociedad Anonima

22 de Noviembre de 2021
Reelecciones. Auditor: CHINCHILLA NUÑO DE LA ROSA FRANCISCO. Aud.Supl.: GOMEZ ESCRIBANO MARIA JOSEFA. Datosregistrales. T 785, L 549, F 100, S 8, H AB 1075, I/A 18 (15.11.21).

17 de Marzo de 2020
Ceses/Dimisiones. Vicepresid.: GARRIDO ARAGONES JOSE LUIS. Cons.Del.Man: GARRIDO ARAGONES JOSE LUIS. Consejero:GARRIDO ARAGONES JOSE LUIS. Presidente: GARRIDO ARAGONES JUAN ANTONIO. Cons.Del.Man: GARRIDO ARAGONESJUAN ANTONIO. Consejero: GARRIDO ARAGONES JUAN ANTONIO. Secretario: PEREZ CORDOBA JOSE LUIS NICOLAS.Cons.Del.Man: PEREZ CORDOBA JOSE LUIS NICOLAS. Consejero: PEREZ CORDOBA JOSE LUIS NICOLAS. Nombramientos.Adm. Mancom.: GARRIDO ARAGONES JOSE LUIS;GARRIDO ARAGONES JUAN ANTONIO. Modificaciones estatutarias.ARTICULO 13º.- El cargo de Administrador será retribuido. Dicha retribución consistirá en una cantidad dineraria fija que para cadaejercicio determianara la Junta General. on. ARTICULO 11º.- Los Administradores tendrán las mas amplias facultades en orden a larepresentación de la Sociedad, pudiendo celebrar todos aquellos actos y contratos necesarios o convenientes al mejordesenvolvimiento de los negocios sociales. La representación de la Sociedad en juicio o fuera de él se extenderá a todos los actoscomprendidos en el objeto so. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración aAdministradores mancomunados. Datos registrales. T 785, L 549, F 100, S 8, H AB 1075, I/A 17 (10.03.20).

28 de Octubre de 2019
Reelecciones. Presidente: GARRIDO ARAGONES JUAN ANTONIO. Cons.Del.Man: GARRIDO ARAGONES JUAN ANTONIO.Consejero: GARRIDO ARAGONES JUAN ANTONIO. Secretario: PEREZ CORDOBA JOSE LUIS NICOLAS. Cons.Del.Man: PEREZCORDOBA JOSE LUIS NICOLAS. Consejero: PEREZ CORDOBA JOSE LUIS NICOLAS. Vicepresid.: GARRIDO ARAGONES JOSELUIS. Cons.Del.Man: GARRIDO ARAGONES JOSE LUIS. Consejero: GARRIDO ARAGONES JOSE LUIS. Datos registrales. T 785,L 549, F 99, S 8, H AB 1075, I/A 16 (21.10.19).

14 de Agosto de 2018
Reelecciones. Auditor: CHINCHILLA NUÑO DE LA ROSA FRANCISCO. Aud.Supl.: GOMEZ ESCRIBANO MARIA JOSEFA. Datosregistrales. T 785, L 549, F 99, S 8, H AB 1075, I/A 15 ( 8.08.18).

12 de Febrero de 2016
Nombramientos. Auditor: CHINCHILLA NUÑO DE LA ROSA FRANCISCO. Aud.Supl.: GOMEZ ESCRIBANO MARIA JOSEFA.Datos registrales. T 785, L 549, F 99, S 8, H AB 1075, I/A 14 ( 5.02.16).

25 de Septiembre de 2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: GARRIDO ARAGONES JOSE LUIS;GARRIDO ARAGONES JUAN ANTONIO;PEREZ CORDOBAJOSE LUIS NICOLAS. Cons.Del.Man: GARRIDO ARAGONES JUAN ANTONIO;GARRIDO ARAGONES JOSE LUIS;PEREZCORDOBA JOSE LUIS NICOLAS. Presidente: GARRIDO ARAGONES JOSE LUIS. Vicepresid.: PEREZ CORDOBA JOSE LUISNICOLAS. Secretario: GARRIDO ARAGONES JUAN ANTONIO. Nombramientos. Consejero: GARRIDO ARAGONES JUANANTONIO;GARRIDO ARAGONES JOSE LUIS;PEREZ CORDOBA JOSE LUIS NICOLAS. Presidente: GARRIDO ARAGONES JUANANTONIO. Vicepresid.: GARRIDO ARAGONES JOSE LUIS. Secretario: PEREZ CORDOBA JOSE LUIS NICOLAS. Cons.Del.Man:PEREZ CORDOBA JOSE LUIS NICOLAS;GARRIDO ARAGONES JUAN ANTONIO;GARRIDO ARAGONES JOSE LUIS. Datosregistrales. T 785, L 549, F 99, S 8, H AB 1075, I/A 13 (18.09.14).

17 de Enero de 2013
Reelecciones. Auditor: CHINCHILLA NUÑO DE LA ROSA FRANCISCO. Aud.Supl.: GOMEZ ESCRIBANO MARIA JOSEFA. Datosregistrales. T 785, L 549, F 98, S 8, H AB 1075, I/A 12 (11.01.13).

13 de Julio de 2012
Cambio de domicilio social. POLIG INDUSTRIAL CAMPOLLANO - ZONA NORTE, AVENIDA (ALBACETE). Datos registrales. T785, L 549, F 98, S 8, H AB 1075, I/A 11 ( 4.07.12).

26 de Febrero de 2010
Nombramientos. Auditor: CHINCHILLA NUÑO DE LA ROSA FRANCISCO;GOMEZ ESCRIBANO MARIA JOSEFA. Datosregistrales. T 785, L 549, F 98, S 8, H AB 1075, I/A 10 (17.02.10).

09 de Octubre de 2009
Ceses/Dimisiones. Consejero: PADILLA SANCHEZ AVELINO. Presidente: PEREZ CORDOBA JOSE LUIS NICOLAS. Vicepresid.:GARRIDO ARAGONES JUAN ANTONIO. Secretario: GARRIDO ARAGONES JOSE LUIS. Nombramientos. Presidente: GARRIDOARAGONES JOSE LUIS. Vicepresid.: PEREZ CORDOBA JOSE LUIS NICOLAS. Secretario: GARRIDO ARAGONES JUAN ANTONIO.Reelecciones. Consejero: GARRIDO ARAGONES JOSE LUIS;GARRIDO ARAGONES JUAN ANTONIO;PEREZ CORDOBA JOSELUIS NICOLAS. Cons.Del.Man: GARRIDO ARAGONES JUAN ANTONIO;GARRIDO ARAGONES JOSE LUIS;PEREZ CORDOBAJOSE LUIS NICOLAS. Datos registrales. T 785, L 549, F 98, S 8, H AB 1075, I/A 9 (30.09.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información