Actos BORME de Roundlake Spain Sl
04 de Diciembre de 2023Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: MULTI STRATEGY JV II SL. Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.:RODRIGUEZ DE SANTOS ANTONIO;GUISADO TRUEBA EVA. Nombramientos. Adm. Unico: TMF SOCIEDAD DE DIRECCIONSL. Representan: MUÑOZ UBEDA ALVARO. Modificaciones estatutarias. Modificación de los artículos 14º y 20º de los EstatutosSociales. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único. Cambio dedenominación social. PLANET OCIO SPV SL. Cambio de domicilio social. C/ VILLANUEVA 2B Esc.1 SM (MADRID). Datosregistrales. T 36459 , F 163, S 8, H M 655054, I/A 11 (27.11.23).
29 de Noviembre de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: RODRIGUEZ HEREDIA FRANCISCO JAVIER;GONZALEZ DIEZ MARIA DEL MAR;VALLE DURANMARTIN FRANCISCO. Apo.Manc.: RODRIGUEZ HEREDIA FRANCISCO JAVIER;GONZALEZ DIEZ MARIA DEL MAR;VALLE DURANMARTIN FRANCISCO. Datos registrales. T 36459 , F 161, S 8, H M 655054, I/A 10 (22.11.23).
15 de Diciembre de 2021Revocaciones. Apoderado: FOSTER GRAHAM. Nombramientos. Apoderado: SEDDON LUCINDA JANE. Datos registrales. T36459 , F 160, S 8, H M 655054, I/A 9 ( 8.12.21).
23 de Abril de 2021Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: BARBAGALLO CIBRIAN FABIO MARCELLO. Nombramientos. Adm. Solid.: GUISADO TRUEBAEVA. Datos registrales. T 36459 , F 160, S 8, H M 655054, I/A 8 (16.04.21).
05 de Abril de 2019Revocaciones. Apo.Sol.: RODRIGUEZ DE SANTOS ANTONIO;GITTENS CATHERINE;DEACON BARRY;LANGLEYJASON;FOSTER GRAHAM. Nombramientos. Apoderado: BARBAGALLO CIBRIAN FABIO MARCELLO;RODRIGUEZ DE SANTOSANTONIO;OLIVES CANTALEJO DAVID;GARRIGUES CALDERON BELEN;GITTENS CATHERINE;DEACON BARRY;LANGLEYJASON;FOSTER GRAHAM. Datos registrales. T 36459 , F 159, S 8, H M 655054, I/A 7 (29.03.19).
19 de Febrero de 2019Cambio de domicilio social. C/ PRINCIPE DE VERGARA 112 4ª (MADRID). Datos registrales. T 36459 , F 159, S 8, H M 655054,I/A 6 (12.02.19).
24 de Diciembre de 2018Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: GARRIGUES CALDERON MARIA-BELEN. Datos registrales. T 36459 , F 159, S 8, H M 655054,I/A 5 (14.12.18).
07 de Junio de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: RODRIGUEZ DE SANTOS ANTONIO;GITTENS CATHERINE;DEACON BARRY;LANGLEYJASON;FOSTER GRAHAM. Datos registrales. T 36459 , F 158, S 8, H M 655054, I/A 4 (31.05.18).
31 de Mayo de 2018Nombramientos. Apoderado: CBRE REAL ESTATE SA. Datos registrales. T 36459 , F 158, S 8, H M 655054, I/A 3 (23.05.18).
16 de Enero de 2018Declaración de unipersonalidad. Socio único: BONNYVILLE SPAIN SL. Datos registrales. T 36459 , F 158, S 8, H M 655054, I/A2 ( 8.01.18).
24 de Octubre de 2017Constitución. Comienzo de operaciones: 3.10.17. Objeto social: LA CONSTITUCION, PARTICIPACION POR SI MISMA O DEFORMA INDIRECTA EN LA GESTION Y CONTROL DE OTRAS EMPRESAS Y SOCIEDADES. ETC. Domicilio: C/ PRINCIPE DEVERGARA - 131 (MADRID). Capital: 3.000,00 Euros. Nombramientos. Adm. Solid.: GARRIGUES CALDERON BELEN;RODRIGUEZDE SANTOS ANTONIO;BARBAGALLO CIBRIAN FABIO MARCELLO. Datos registrales. T 36459 , F 156, S 8, H M 655054, I/A 1(16.10.17).