Buscador CIF Logo

Actos BORME Rp Alcorcon Acquisitions Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Rp Alcorcon Acquisitions Sl

Actos BORME Rp Alcorcon Acquisitions Sl - B87734018

Tenemos registrados 21 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Rp Alcorcon Acquisitions Sl con CIF B87734018

馃敊 Perfil de Rp Alcorcon Acquisitions Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Rp Alcorcon Acquisitions Sl

07 de Diciembre de 2022
Revocaciones. Apo.Sol.: STIJGER MARIELLE FLORENCE. Apoderado: STIJGER MARIELLE FLORENCE. Apo.Sol.: STIJGERMARIELLE FLORENCE;ECUYER ALEXIS JACQUES G. DE MONTPELLIER D'ANNEVOIE. Datos registrales. T 35594 , F 217, S 8,H M 639716, I/A 23 (29.11.22).

05 de Abril de 2022
Ceses/Dimisiones. Vicesecret.: ARMERO MONTES DIEGO. Consejero: STIJGER MARIELLE FLORENCE. Secretario: STIJGERMARIELLE FLORENCE. Consejero: ECUYER ALEXIS JACQUES G. DE MONTPELLIER D'ANNEVOIE. Vicepresid.: ECUYER ALEXISJACQUES G. DE MONTPELLIER D'ANNEVOIE. Nombramientos. VsecrNoConsj: MACHUCA MENENDEZ LAURA. Consejero:RUIZ GALLARDO MARIA DEL PILAR;RUA-FIGUEROA DIAZ-CANEJA ANA. SecreNoConsj: ARMERO MONTES DIEGO. Datos

05 de Noviembre de 2021
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 35594 , F 216, S 8, H M 639716,I/A 21 (28.10.21).

22 de Febrero de 2021
Revocaciones. Apoderado: PATRIMONY REAL ESTATE MANAGEMENT SL. Nombramientos. Apo.Sol.: MARTINEZ LASCURAINFERNANDO;SOLIS GARCIA JAVIER;STIJGER MARIELLE FLORENCE;ECUYER ALEXIS JACQUES G. DE MONTPELLIERD'ANNEVOIE. Datos registrales. T 35594 , F 215, S 8, H M 639716, I/A 20 (15.02.21).

22 de Diciembre de 2020
Ampliaci贸n de capital. Capital: 1.500.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.378.600,00 Euros. Datos registrales. T 35594 , F 214, S8, H M 639716, I/A 19 (15.12.20).

21 de Octubre de 2020
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 35594 , F 213, S 8, H M 639716,I/A 18 (14.10.20).

14 de Octubre de 2020
Revocaciones. Apoderado: COLINO SANCHEZ VENTURA JAVIER;SIMBOR ORTEGA BELEN;BLAZQUEZ SALSOIGNACIO;GARCIA DE FUENTES IGNACIO MARTIN NAGELE. Datos registrales. T 35594 , F 213, S 8, H M 639716, I/A 17 (6.10.20).

15 de Junio de 2020
Revocaciones. Apoderado: AZZAM VIVIENDA SL. Datos registrales. T 35594 , F 213, S 8, H M 639716, I/A 16 ( 8.06.20).

28 de Enero de 2020
Nombramientos. Apo.Sol.: CBRE REAL ESTATE SA. Datos registrales. T 35594 , F 211, S 8, H M 639716, I/A 15 (21.01.20).

23 de Enero de 2020
Revocaciones. Consejero: MARTINEZ LASCURAIN FERNANDO. Fe de erratas: Se omiti贸 por error en la Inscripci贸n 14陋 el cesecomo Consejero de MARTINEZ LASCURAIN FERNANDO. Datos registrales. T 35594 , F 211, S 8, H M 639716, I/A 14 (14.11.19).

21 de Noviembre de 2019
Ceses/Dimisiones. Presidente: MARTINEZ LASCURAIN FERNANDO. Nombramientos. Consejero: SOLIS GARCIA JAVIER.Presidente: SOLIS GARCIA JAVIER. Datos registrales. T 35594 , F 211, S 8, H M 639716, I/A 14 (14.11.19).

14 de Mayo de 2019
Revocaciones. Apo.Sol.: ESTRADA LOPEZ ANA;MARINACCE GUILLAUME. Apoderado: ESTRADA LOPEZ ANA;MARINACCEGUILLAUME. Datos registrales. T 35594 , F 211, S 8, H M 639716, I/A 13 ( 7.05.19).

28 de Marzo de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: MARINACCE GUILLAUME. Presidente: MARINACCE GUILLAUME. Consejero: ESTRADA LOPEZANA. Vicepresid.: ESTRADA LOPEZ ANA. Nombramientos. Consejero: MARTINEZ LASCURAIN FERNANDO;ECUYER ALEXISJACQUES G. DE MONTPELLIER D'ANNEVOIE. Presidente: MARTINEZ LASCURAIN FERNANDO. Vicepresid.: ECUYER ALEXISJACQUES G. DE MONTPELLIER D'ANNEVOIE. Datos registrales. T 35594 , F 189, S 8, H M 639716, I/A 12 (21.03.19).

14 de Febrero de 2019
Nombramientos. Apoderado: MOLINA-MARTELL RAMIS ALEXANDRA;MACHUCA MENENDEZ LAURA. Datos registrales. T35594 , F 189, S 8, H M 639716, I/A 11 ( 7.02.19).

01 de Febrero de 2018
Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 35594 , F 189, S 8, H M 639716,I/A 10 (24.01.18).

05 de Octubre de 2017
Nombramientos. Apoderado: CBRE REAL ESTATE SA;ESTRADA LOPEZ ANA;STIJGER MARIELLE FLORENCE;MARINACCEGUILLAUME. Datos registrales. T 35594 , F 187, S 8, H M 639716, I/A 8 (27.09.17).

Revocaciones. Apoderado: JOHNSON NIKITA;PENNINGTON ANNE;LU CAROLINE;MILLA RUBEN. Datos registrales. T 35594 , F188, S 8, H M 639716, I/A 9 (27.09.17).

22 de Septiembre de 2017
Nombramientos. Apoderado: AZZAM VIVIENDA SL. Datos registrales. T 35594 , F 186, S 8, H M 639716, I/A 7 (15.09.17).

01 de Junio de 2017
Nombramientos. Apoderado: PATRIMONY REAL ESTATE MANAGEMENT SL. Apo.Sol.: ESTRADA LOPEZ ANA;STIJGERMARIELLE FLORENCE;MARINACCE GUILLAUME. Datos registrales. T 35594 , F 185, S 8, H M 639716, I/A 6 (24.05.17).

17 de Mayo de 2017
Ampliaci贸n de capital. Capital: 875.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 878.600,00 Euros. Datos registrales. T 35594 , F 184, S 8,H M 639716, I/A 5 ( 8.05.17).

10 de Abril de 2017
Nombramientos. Apoderado: JOHNSON NIKITA;PENNINGTON ANNE;LU CAROLINE;MILLA RUBEN. Datos registrales. T 35594 ,F 184, S 8, H M 639716, I/A 4 (31.03.17).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n