Buscador CIF Logo

Actos BORME Rugauto Sa

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Rugauto Sa

Actos BORME Rugauto Sa - A09030537

Tenemos registrados 26 Actos BORME del Registro Mercantil de Burgos para Rugauto Sa con CIF A09030537

🔙 Perfil de Rugauto Sa
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Burgos

Actos BORME de Rugauto Sa

01 de Diciembre de 2022
Reelecciones. Auditor: ARRIBAS AUDITORES SLP. Datos registrales. T 749, L 540, F 188, S 8, H BU 689, I/A 48 (25.11.22).

10 de Enero de 2022
Reelecciones. Auditor: ARRIBAS AUDITORES SLP. Datos registrales. T 749, L 540, F 188, S 8, H BU 689, I/A 46 ( 3.01.22).

Reelecciones. Adm. Solid.: POLVOROSA MIES RAMON. Datos registrales. T 749, L 540, F 188, S 8, H BU 689, I/A 47 ( 3.01.22).

16 de Noviembre de 2020
Reelecciones. Auditor: ARRIBAS AUDITORES SLP. Datos registrales. T 749, L 540, F 188, S 8, H BU 689, I/A 45 ( 6.11.20).

06 de Noviembre de 2019
Reelecciones. Auditor: ARRIBAS AUDITORES SLP. Datos registrales. T 749, L 540, F 188, S 8, H BU 689, I/A 44 (30.10.19).

Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ PUEBLA LAURA. Datos registrales. T 749, L 540, F 187, S 8, H BU 689, I/A 43(30.10.19).

04 de Junio de 2019
Revocaciones. Apoderado: GALLO BARRIO JOSE MOISES;GALLO BARRIO JOSE MOISES. Datos registrales. T 749, L 540, F187, S 8, H BU 689, I/A 42 (29.05.19).

15 de Abril de 2019
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: GARCIA SANZ EUGENIO. Nombramientos. Adm. Solid.: POLVOROSA GOMEZ CESAR. Datosregistrales. T 749, L 540, F 186, S 8, H BU 689, I/A 41 ( 9.04.19).

05 de Febrero de 2019
Nombramientos. Apoderado: MARTIN FADRIQUE MARTA. Datos registrales. T 715, L 506, F 186, S 8, H BU 689, I/A 40(30.01.19).

23 de Octubre de 2018
Ampliacion del objeto social. Alquiler de vehículos sin conductor. Datos registrales. T 715, L 506, F 185, S 8, H BU 689, I/A 39(17.10.18).

26 de Junio de 2018
Reelecciones. Auditor: ARRIBAS AUDITORES SLP. Datos registrales. T 715, L 506, F 185, S 8, H BU 689, I/A 38 (20.06.18).

06 de Marzo de 2018
Revocaciones. Apoderado: GONZALEZ VELAZQUEZ JOSE LUIS. Datos registrales. T 715, L 506, F 185, S 8, H BU 689, I/A 37(28.02.18).

12 de Septiembre de 2017
Nombramientos. Apoderado: GALLO BARRIO JOSE MOISES. Datos registrales. T 715, L 506, F 185, S 8, H BU 689, I/A 36 (6.09.17).

24 de Agosto de 2017
Revocaciones. Apoderado: RUERA MORENO JUAN MANUEL;RUERA GARCIA VICTOR MANUEL;GARCIA ARRANZ CELIA MARIALAURA. Datos registrales. T 715, L 506, F 185, S 8, H BU 689, I/A 35 (17.08.17).

11 de Julio de 2017
Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ VELAZQUEZ JOSE LUIS. Datos registrales. T 715, L 506, F 184, S 8, H BU 689, I/A 34 (5.07.17).

13 de Junio de 2017
Reelecciones. Auditor: ARRIBAS AUDITORES SLP. Datos registrales. T 715, L 506, F 184, S 8, H BU 689, I/A 33 ( 7.06.17).

04 de Octubre de 2016
Nombramientos. Apoderado: GALLO BARRIO JOSE MOISES. Datos registrales. T 582, L 373, F 194, S 8, H BU 689, I/A 31(28.09.16).

Revocaciones. Apoderado: GARCIA ARRANZ CELIA MARIA LAURA;RUERA GARCIA VICTOR MANUEL;RUERA GARCIA LAURAMONICA. Datos registrales. T 715, L 506, F 184, S 8, H BU 689, I/A 32 (28.09.16).

30 de Agosto de 2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: RUERA MORENO JUAN MANUEL. Presidente: RUERA MORENO JUAN MANUEL. Consejero:GARCIA ARRANZ CELIA MARIA LAURA. Secretario: GARCIA ARRANZ CELIA MARIA LAURA. Consejero: RUERA GARCIA VICTORMANUEL. Con.Delegado: RUERA MORENO JUAN MANUEL. Consejero: RUERA GARCIA LAURA MONICA. Nombramientos. Adm.Solid.: POLVOROSA MIES RAMON;GARCIA SANZ EUGENIO. Modificaciones estatutarias. 16. Organos sociales y 28. Podrá seradministrada por: 1º Un administrador único. 2º Dos o más administradores, hasta un máximo de doce, que actúen solidariamente. 3ºDos administradores que actúen conjuntamente. 4º Un Consejo entre por un mínimo de tres y un máximo de siete miembros.. Otrosconceptos: Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios. Datos registrales. T582, L 373, F 193, S 8, H BU 689, I/A 28 (24.08.16).

Declaración de unipersonalidad. Socio único: PALAUSA 2001 SL. Datos registrales. T 582, L 373, F 194, S 8, H BU 689, I/A 29(24.08.16).

Ceses/Dimisiones. Auditor: ARRIBAS AUDITORES SL. Nombramientos. Auditor: ARRIBAS AUDITORES SLP. Datos registrales.T 582, L 373, F 194, S 8, H BU 689, I/A 30 (24.08.16).

20 de Julio de 2016
Revocaciones. Apoderado: GARCIA MIGUEL FRANCISCO JAVIER;RUERA MORENO AURORA. Datos registrales. T 582, L 373,F 192, S 8, H BU 689, I/A 26 (13.07.16).

Nombramientos. Apoderado: PEREZ GARCIA JAVIER. Datos registrales. T 582, L 373, F 192, S 8, H BU 689, I/A 27 (13.07.16).

16 de Octubre de 2013
Reelecciones. Auditor: ARRIBAS AUDITORES SL. Datos registrales. T 582, L 373, F 192, S 8, H BU 689, I/A 25 (10.10.13).

24 de Octubre de 2012
Nombramientos. Consejero: RUERA GARCIA LAURA MONICA. Reelecciones. Consejero: RUERA MORENO JUAN MANUEL.Presidente: RUERA MORENO JUAN MANUEL. Consejero: GARCIA ARRANZ CELIA MARIA LAURA. Secretario: GARCIA ARRANZCELIA MARIA LAURA. Consejero: RUERA GARCIA VICTOR MANUEL. Con.Delegado: RUERA MORENO JUAN MANUEL. Datosregistrales. T 582, L 373, F 191, S 8, H BU 689, I/A 24 (16.10.12).

27 de Diciembre de 2010
Reelecciones. Auditor: ARRIBAS AUDITORES SL. Datos registrales. T 582, L 373, F 191, S 8, H BU 689, I/A 23 (14.12.10).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información