Buscador CIF Logo

Actos BORME Rural Servicios Informaticos Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Rural Servicios Informaticos Sl

Actos BORME Rural Servicios Informaticos Sl - B80458417

Tenemos registrados 21 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Rural Servicios Informaticos Sl con CIF B80458417

馃敊 Perfil de Rural Servicios Informaticos Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Rural Servicios Informaticos Sl

13 de Noviembre de 2023
Nombramientos. Apoderado: CERVERO DEL POZO CARLOS. Datos registrales. T 41404 , F 213, S 8, H M 651322, I/A 22 (3.11.23).

08 de Septiembre de 2022
Ceses/Dimisiones. Representan: CABALLO ARROYO URBANO. Nombramientos. Representan: PALACIOS GOMEZ JUAN.Datos registrales. T 41404 , F 203, S 8, H M 651322, I/A 20 ( 1.09.22).

26 de Agosto de 2022
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Ampliaci贸n de capital. Capital: 7.185.211,75 Euros. Resultante Suscrito:60.414.731,50 Euros. Datos registrales. T 41404 , F 196, S 8, H M 651322, I/A 19 (19.08.22).

06 de Abril de 2022
Nombramientos. Apo.Sol.: HERAS GARCIA MARIA DOLORES. Datos registrales. T 41404 , F 196, S 8, H M 651322, I/A 18(30.03.22).

31 de Marzo de 2022
Ceses/Dimisiones. Representan: PORTILLO MELO JOSE MARIA. Nombramientos. Representan: CABALLO ARROYO URBANO.Datos registrales. T 41404 , F 195, S 8, H M 651322, I/A 17 (24.03.22).

26 de Agosto de 2021
Revocaciones. Apo.Man.Soli: MORADELL VALGA脩ON CARLOS;MARTINEZ RODRIGUEZ FERNANDO. Apoderado: MORADELLVALGA脩ON CARLOS;MARTINEZ BENAVIDES CONCEPCION;MARTINEZ BENAVIDES CONCEPCION;MARTINEZ BENAVIDESCONCEPCION. Datos registrales. T 41404 , F 195, S 8, H M 651322, I/A 16 (19.08.21).

26 de Julio de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: CAJA RURAL DE JAEN BARCELONA Y MADRID SCC. Representan: GARCIA-LOMASHERNANDEZ JOSE LUIS. Nombramientos. Representan: MENDEZ ALVAREZ CEDRON JESUS. Consejero: CAIXA RURALGALEGA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO. Datos registrales. T 41404 , F 194, S 8, H M 651322, I/A 15 (19.07.21).

20 de Julio de 2021
Ampliaci贸n de capital. Capital: 11.957.869,25 Euros. Resultante Suscrito: 53.229.519,75 Euros. Datos registrales. T 36248 , F 139,S 8, H M 651322, I/A 14 (13.07.21).

25 de Junio de 2021
Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DEL ARTICULO 32潞 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.. Datos registrales. T 36248 ,F 138, S 8, H M 651322, I/A 13 (20.06.21).

28 de Enero de 2021
Revocaciones. Apo.Man.Soli: CERVERO DEL POZO CARLOS. Apo.Sol.: CERVERO DEL POZO CARLOS. Nombramientos.Apoderado: CERVERO DEL POZO CARLOS;GARCIA PALACIOS ALVAREZ JOSE LUIS;ROMERO CASADO ANTONIO;MARTINEZBENAVIDES CONCEPCION;PEREZ GARCIA ANA;LLANO GALLEGO JOSE MANUEL;CERVERO DEL POZO CARLOS;PEREZGARCIA ANA;LLANO GALLEGO JOSE MANUEL;MARTINEZ BENAVIDES CONCEPCION. Datos registrales. T 36248 , F 136, S 8,H M 651322, I/A 12 (21.01.21).

10 de Junio de 2020
Ampliaci贸n de capital. Capital: 10.350.163,50 Euros. Resultante Suscrito: 41.271.650,50 Euros. Datos registrales. T 36248 , F 131,S 8, H M 651322, I/A 11 ( 3.06.20).

01 de Abril de 2020
Nombramientos. Apoderado: LLANO GALLEGO JOSE MANUEL;MORADELL VALGA脩ON CARLOS;MARTINEZ BENAVIDESCONCEPCION;CERVERO DEL POZO CARLOS. Datos registrales. T 36248 , F 131, S 8, H M 651322, I/A 10 (25.03.20).

07 de Noviembre de 2019
Ceses/Dimisiones. Representan: MARTINEZ RODRIGUEZ FERNANDO. Nombramientos. Representan: ROMERO CASADOANTONIO. Datos registrales. T 36248 , F 130, S 8, H M 651322, I/A 9 (30.10.19).

18 de Septiembre de 2019
Nombramientos. Consejero: CAJA RURAL DE JAEN BARCELONA Y MADRID SCC. Auditor: ERNST &YOUNG SL. Representan:GARCIA-LOMAS HERNANDEZ JOSE LUIS. Datos registrales. T 36248 , F 130, S 8, H M 651322, I/A 8 (11.09.19).

01 de Julio de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: CAJA RURAL DE TERUEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDI. Representan: PEREZ CEBRIANJOSE ANTONIO. Datos registrales. T 36248 , F 130, S 8, H M 651322, I/A 7 (25.06.19).

27 de Julio de 2018
Modificaciones estatutarias. 10. Transmisi贸n de Participaciones.-. 16. Convocatoria de la Junta General.-. Datos registrales. T36248 , F 128, S 8, H M 651322, I/A 6 (18.07.18).

27 de Febrero de 2018
Revocaciones. Apo.Man.Soli: MORADELL VALGA脩ON CARLOS. Apo.Manc.: LOPEZ TARRUELLA MARTIN RAFAEL;MARTINEZRODRIGUEZ FERNANDO. Apo.Man.Soli: MARTINEZ BENAVIDES CONCEPCION;CERVERO DEL POZO CARLOS.Nombramientos. Apo.Man.Soli: MORADELL VALGA脩ON CARLOS;GARCIA PALACIOS ALVAREZ JOSE LUIS;MARTINEZRODRIGUEZ FERNANDO;MARTINEZ BENAVIDES CONCEPCION;CERVERO DEL POZO CARLOS. Apo.Sol.: MORADELLVALGA脩ON CARLOS;MARTINEZ BENAVIDES CONCEPCION;CERVERO DEL POZO CARLOS. Datos registrales. T 36248 , F 125,S 8, H M 651322, I/A 5 (19.02.18).

22 de Febrero de 2018
Ceses/Dimisiones. Representan: LOPEZ TARRUELLA MARTIN RAFAEL. Nombramientos. Representan: GARCIA PALACIOSALVAREZ JOSE LUIS. Datos registrales. T 36248 , F 124, S 8, H M 651322, I/A 4 (12.02.18).

25 de Enero de 2018
Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Modificaciones estatutarias. Se modifica el art铆culo 17潞 de los Estatutos Sociales-Junta General-. Datos registrales. T 36248 , F 124, S 8, H M 651322, I/A 3 (17.01.18).

17 de Enero de 2018
Otros conceptos: Como consecuencia de la transformaci贸n de la sociedad en sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad tienecomo nuevo NIF el siguiente: B80458417. Datos registrales. T 36248 , F 111, S 8, H M 651322, I/A 1-M (10.01.18).

16 de Noviembre de 2017
Revocaciones. Apoderado: MORADELL VALGA脩ON CARLOS;LOPEZ TARRUELLA MARTIN RAFAEL;MARTINEZ RODRIGUEZ

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n