Buscador CIF Logo

Actos BORME Rymoil Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Rymoil Sa

Actos BORME Rymoil Sa - A33053562

Tenemos registrados 16 Actos BORME del Registro Mercantil de Asturias para Rymoil Sa con CIF A33053562

馃敊 Perfil de Rymoil Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Asturias

Actos BORME de Rymoil Sa

21 de Noviembre de 2023
Revocaciones. VsecrNoConsj: MARTINEZ RODRIGUEZ RUBEN. Secretario: ZAPICO GARCIA ANA MARIA. Consejero: MARTINEZZAPICO SATURNINO;MARTINEZ ALVAREZ JUAN MANUEL;BUZNEGO SUAREZ LUIS ABELARDO;MARTINEZ ESPINAR RAUL.Presidente: MARTINEZ ZAPICO SATURNINO. Con.Delegado: BUZNEGO SUAREZ LUIS ABELARDO. Nombramientos.SecreNoConsj: MARTINEZ RODRIGUEZ RUBEN. Consejero: CASADO MARTINEZ ARCADIO;BUZNEGO SUAREZ LUISABELARDO;GARCIA ALVAREZ AMANCIO;ARIAS ALVAREZ JOSE MANUEL. Presidente: CASADO MARTINEZ ARCADIO.Consejero: MARTINEZ ALVAREZ JUAN MANUEL. Con.Delegado: BUZNEGO SUAREZ LUIS ABELARDO. Datos registrales. T 4132, F 14, S 8, H AS 6320, I/A 31 (15.11.23).

20 de Diciembre de 2022
Nombramientos. VsecrNoConsj: MARTINEZ RODRIGUEZ RUBEN. Datos registrales. T 4132 , F 14, S 8, H AS 6320, I/A 30(12.12.22).

21 de Abril de 2022
Otros conceptos: MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 4 BIS, 14 BIS, 15 BIS PRIMERO, 15 BIS SEGUNDO, 15 BIS TERCERO,15 BIS CUARTO, 22 BIS PRIMERO, 22 BIS SEGUNDO, 22 BIS TERCERO, 22 BIS CUARTO, 22 BIS QUINTO, 22 BIS SEXTOREFERENTES A LA CELEBRACION DE JUNTAS Y CONSEJOS TELEMATICOS. Datos registrales. T 4132 , F 13, S 8, H AS 6320,I/A 29 (11.04.22).

30 de Diciembre de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: ARROYO ARISTE ANGEL MANUEL. Datos registrales. T 4132 , F 13, S 8, H AS 6320, I/A 28(22.12.21).

29 de Julio de 2019
Revocaciones. Consejero: MARTINEZ ALVAREZ JUAN MANUEL;MARTINEZ ZAPICO SATURNINO;ARROYO ARISTE ANGELMANUEL;MARTINEZ ESPINAR JOSE IGNACIO;MARTINEZ RODRIGUEZ RUBEN. Presidente: MARTINEZ ZAPICO SATURNINO.Con.Delegado: MARTINEZ ESPINAR JOSE IGNACIO. Nombramientos. Consejero: MARTINEZ ZAPICO SATURNINO;MARTINEZALVAREZ JUAN MANUEL;ARROYO ARISTE ANGEL MANUEL;BUZNEGO SUAREZ LUIS ABELARDO;MARTINEZ ESPINAR RAUL.Presidente: MARTINEZ ZAPICO SATURNINO. Con.Delegado: BUZNEGO SUAREZ LUIS ABELARDO. Reelecciones. Secretario:ZAPICO GARCIA ANA MARIA. Datos registrales. T 4132 , F 12, S 8, H AS 6320, I/A 27 (22.07.19).

18 de Marzo de 2019
Nombramientos. Apoderado: PEREIRA VILLAR ALBERTO. Datos registrales. T 4132 , F 12, S 8, H AS 6320, I/A 26 ( 8.03.19).

17 de Octubre de 2016
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 7.843,05 Euros. Resultante Suscrito: 82.306,95 Euros. Modificaciones estatutarias.Art铆culo de los estatutos: 4. Capital social.-. Datos registrales. T 4132 , F 12, S 8, H AS 6320, I/A 25 ( 6.10.16).

04 de Febrero de 2016
Nombramientos. Apoderado: PEREIRA VILLAR ALBERTO. Datos registrales. T 4132 , F 11, S 8, H AS 6320, I/A 24 (26.01.16).

22 de Abril de 2015
Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ ZAPICO SATURNINO. Datos registrales. T 1398 , F 225, S 8, H AS 6320, I/A 23(14.04.15).

02 de Octubre de 2014
Modificaciones estatutarias. 15. Funcionamiento Junta Gral.-. Datos registrales. T 1398 , F 225, S 8, H AS 6320, I/A 22 (24.09.14).

01 de Septiembre de 2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTINEZ ZAPICO SATURNINO;MARTINEZ ALVAREZ JUAN MANUEL;ARROYO ARISTE ANGELMANUEL;MARTINEZ ESPINAR JOSE IGNACIO;MARTINEZ RODRIGUEZ RUBEN. Presidente: MARTINEZ ZAPICO SATURNINO.Vicepresid.: MARTINEZ ALVAREZ JUAN MANUEL. Cons.Del.Sol: MARTINEZ ZAPICO SATURNINO. Nombramientos. Consejero:MARTINEZ ZAPICO SATURNINO;MARTINEZ ALVAREZ JUAN MANUEL. Con.Delegado: MARTINEZ ESPINAR JOSE IGNACIO.Consejero: ARROYO ARISTE ANGEL MANUEL;MARTINEZ ESPINAR JOSE IGNACIO;MARTINEZ RODRIGUEZ RUBEN. Presidente:MARTINEZ ZAPICO SATURNINO. Reelecciones. Secretario: ZAPICO GARCIA ANA MARIA. Modificaciones estatutarias. 3.

31 de Marzo de 2014
Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Sol: MARTINEZ ALVAREZ JUAN MANUEL. Datos registrales. T 1398 , F 224, S 8, H AS 6320, I/A 20(20.03.14).

25 de Marzo de 2014
Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ ALVAREZ JUAN MANUEL. Datos registrales. T 1398 , F 224, S 8, H AS 6320, I/A 19(14.03.14).

27 de Diciembre de 2013
Modificaciones estatutarias. 10. Transmisi贸n de Acciones/Participaciones.-. 11. Transmisi贸n de Acciones/Participaciones.-. Datosregistrales. T 1398 , F 223, S 8, H AS 6320, I/A 18 (18.12.13).

29 de Abril de 2013
Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ ESPINAR JOSE IGNACIO. Datos registrales. T 1398 , F 222, S 8, H AS 6320, I/A 17(19.04.13).

06 de Mayo de 2011
Revocaciones. Consejero: REDONDO CANAL FRANCISCO JAVIER. Cons.Del.Sol: MARTINEZ ZAPICO SATURNINO;MARTINEZALVAREZ JUAN MANUEL. Nombramientos. Consejero: MARTINEZ RODRIGUEZ RUBEN. Cons.Del.Sol: MARTINEZ ZAPICOSATURNINO;MARTINEZ ALVAREZ JUAN MANUEL. Reelecciones. Consejero: MARTINEZ ZAPICO SATURNINO;MARTINEZALVAREZ JUAN MANUEL;ARROYO ARISTE ANGEL MANUEL;MARTINEZ ESPINAR JOSE IGNACIO. Secretario: ZAPICO GARCIAANA MARIA. Presidente: MARTINEZ ZAPICO SATURNINO. Vicepresid.: MARTINEZ ALVAREZ JUAN MANUEL. Datos registrales. T1398 , F 222, S 8, H AS 6320, I/A 16 (20.04.11).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n