Buscador CIF Logo

Actos BORME Sabel De Servicios Sl

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Sabel De Servicios Sl

Actos BORME Sabel De Servicios Sl - B58875048

Tenemos registrados 19 Actos BORME del Registro Mercantil de Barcelona para Sabel De Servicios Sl con CIF B58875048

🔙 Perfil de Sabel De Servicios Sl
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Barcelona

Actos BORME de Sabel De Servicios Sl

10 de Febrero de 2023
Revocaciones. CONSEJERO: MACANA SA. PRESIDENTE: MACANA SA. REPR.143 RRM: VALLET GARRIGA MANUEL.Nombramientos. CONSEJERO: CONSTRUCCIONES INMOBILIARIAS TEYMA UNO SL. REPR.143 RRM: VALLET GARRIGAMANUEL. Datos registrales. T 46706 , F 54, S 8, H B 55800, I/A 71 ( 2.02.23).

Nombramientos. PRESIDENTE: CONSTRUCCIONES INMOBILIARIAS TEYMA UNO SL. Datos registrales. T 46706 , F 54, S 8, HB 55800, I/A 72 ( 2.02.23).

18 de Noviembre de 2021
Cambio de objeto social. EL ESTUDIO, PROYECTO, CREACION, ORGANIZACION, ASISTENCIA, ADMINISTRACION YPROMOCION DE TODA CLASE DE EMPRESAS Y NEGOCIOS DEDICADOS A ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, TURISTICAS YHOTELERAS. LA GESTION, LA ADMINISTRACION... Datos registrales. T 46706 , F 53, S 8, H B 55800, I/A 70 (10.11.21).

27 de Mayo de 2021
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: QS AUDIT CONSULTOR SLP. Datos registrales. T 46706 , F 53, S 8, H B 55800, I/A 69(19.05.21).

24 de Febrero de 2021
Revocaciones. APODERADO: VALLET GOMEZ MANUEL. Datos registrales. T 46706 , F 53, S 8, H B 55800, I/A 68 (15.02.21).

26 de Noviembre de 2020
Revocaciones. REPR.143 RRM: VALLET GOMEZ MANUEL. Nombramientos. REPR.143 RRM: VALLET GARRIGA MANUEL.Datos registrales. T 46706 , F 53, S 8, H B 55800, I/A 67 (18.11.20).

21 de Agosto de 2020
Otros conceptos: DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD, SOCIO UNICO: PROMOTORA KASDE S.A. Datos registrales. T46706 , F 53, S 8, H B 55800, I/A 66 (13.08.20).

12 de Agosto de 2020
Nombramientos. APODERAD.SOL: VALLET GARRIGA MANUEL. Datos registrales. T 46706 , F 52, S 8, H B 55800, I/A 65 (4.08.20).

29 de Noviembre de 2019
Revocaciones. CONSEJERO: SOLER RODRIGUEZ ISMAELA. Datos registrales. T 46706 , F 51, S 8, H B 55800, I/A 64(21.11.19).

26 de Marzo de 2019
Revocaciones. CONSEJERO: ESPEJA SANZ FELIPA. Datos registrales. T 46706 , F 51, S 8, H B 55800, I/A 63 (19.03.19).

25 de Enero de 2019
Nombramientos. APODERAD.SOL: NAVAS MARQUES FELIX. Datos registrales. T 36666 , F 126, S 8, H B 55800, I/A 62(18.01.19).

06 de Junio de 2018
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: QS AUDIT CONSULTOR SLP. Datos registrales. T 36666 , F 126, S 8, H B 55800, I/A 61(30.05.18).

07 de Junio de 2016
Nombramientos. APODERAD.SOL: NAVAS MARQUES FELIX;VALENZUELA MORALES MANUEL. Datos registrales. T 36666 , F125, S 8, H B 55800, I/A 60 (30.05.16).

26 de Agosto de 2015
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: QUADRAS Y SERRA AUDITORES SL. Datos registrales. T 36666 , F 124, S 8, H B 55800, I/A59 (18.08.15).

12 de Febrero de 2013
Modificaciones estatutarias. ART.19:SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL. Datos registrales.T 36666 , F 124, S 8, H B 55800, I/A 58 ( 4.02.13).

25 de Mayo de 2012
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: QUADRAS Y SERRA AUDITORES SL. Datos registrales. T 36666 , F 124, S 8, H B 55800, I/A57 (16.05.12).

04 de Mayo de 2011
Revocaciones. CONSEJERO: MONZO LASALA JUAN. Datos registrales. T 36666 , F 124, S 8, H B 55800, I/A 56 (18.04.11).

24 de Noviembre de 2009
Revocaciones. APODERADO: CANAL PUSO JOSEP. Datos registrales. T 36666 , F 123, S 8, H B 55800, I/A 55 (11.11.09).

24 de Agosto de 2009
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: QUADRAS Y SERRA AUDITORES SL. Datos registrales. T 36666 , F 123, S 8, H B 55800, I/A54 (11.08.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información