Actos BORME de Sabic Innovative Plastics Gp B. V. S. Com
14 de Diciembre de 2023Ceses/Dimisiones. Representan: JUAN ANTONIO ALEMANY SAN JOSE. Revocaciones. Apo.Sol.: MARTI MORENO JORGEJUAN. Apo.Manc.: EMMA SIMO PINATELLA. Apo.Man.Soli: TIMOTHY CHARLES STONESIFER;MARK-ROELAND DE-GROOT;JOHN-ANDREW BOUDREAU;WILLIAM GRANT COOPER DAKIN;JEFFREY TODD KENNEL;MARGARITA GARCIASANCHEZ. Apo.Manc.: MARGARITA GARCIA SANCHEZ;EMMA SIMO PINATELLA;TIMOTHY CHARLES STONESIFER;MARK-ROELAND DE-GROOT;JOHN-ANDREW BOUDREAU;WILLIAM GRANT COOPER DAKIN;JEFFREY TODD KENNEL;ESTHERGARCIA TOLEDO;MARGARITA GARCIA SANCHEZ;EMMA SIMO PINATELLA;TIMOTHY CHARLES STONESIFER;MARK-ROELANDDE-GROOT;JOHN-ANDREW BOUDREAU;WILLIAM GRANT COOPER DAKIN;JEFFREY TODD KENNEL. Apo.Sol.: SABIC CAPITALBV. Apo.Manc.: SUSANA GUIJARRO CASTA脩ER;SUSANA GUIJARRO CASTA脩ER;ALFREDO MARTINEZ LOPEZ;ESTHERGARCIA TOLEDO;MARGARITA GARCIA SANCHEZ. Apo.Sol.: DANIEL GURREA BOIX;EDUARDO BAYONA GALVEZ;MARTAROCABERT CRUZ. Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 3213 , F 175, S 8, H MU 70533, I/A 19 ( 5.12.23).
23 de Febrero de 2022Revocaciones. Apo.Manc.: ALFREDO MARTINEZ LOPEZ;ALFREDO MARTINEZ LOPEZ;ALFREDO MARTINEZ LOPEZ;ERIC RENEWOONS;DARIA VADIMOVNA SEVERINA. Datos registrales. T 3213 , F 175, S 8, H MU 70533, I/A 18 (16.02.22).
06 de Noviembre de 2020Revocaciones. Apo.Sol.: FRANCISCO JAVIER MARTINEZ NADAL;JAVIER RODRIGUEZ MARTINEZ;MARIA FERRANDOORTOLA;VICTORIA-ELISA PERERA NAVAS;MIGUEL BOLIVAR TEJEDO. Nombramientos. Apo.Sol.: DANIEL GURREABOIX;EDUARDO BAYONA GALVEZ;MARTA ROCABERT CRUZ. Datos registrales. T 3213 , F 175, S 8, H MU 70533, I/A 17(29.10.20).
01 de Febrero de 2017Nombramientos. Apo.Sol.: SABIC CAPITAL BV. Apo.Manc.: SUSANA GUIJARRO CASTA脩ER;ERIC RENE WOONS;DARIAVADIMOVNA SEVERINA. Datos registrales. T 2662 , F 65, S 8, H MU 70533, I/A 15 (25.01.17).
Nombramientos. Apo.Manc.: SUSANA GUIJARRO CASTA脩ER;ALFREDO MARTINEZ LOPEZ;ESTHER GARCIATOLEDO;MARGARITA GARCIA SANCHEZ. Datos registrales. T 2662 , F 65, S 8, H MU 70533, I/A 16 (25.01.17).
09 de Diciembre de 2016Ceses/Dimisiones. Representan: THEODORUS ARNOLDUS VAN ELDIK. Nombramientos. Representan: JUAN ANTONIOALEMANY SAN JOSE. Datos registrales. T 2662 , F 65, S 8, H MU 70533, I/A 14 (30.11.16).
25 de Febrero de 2016Ampliaci贸n de capital. Capital: 3.100,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.131.000,00 Euros. Datos registrales. T 2662 , F 64, S 8, HMU 70533, I/A 13 (18.02.16).
12 de Julio de 2013Ampliaci贸n de capital. Capital: 3.100,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.127.900,00 Euros. Datos registrales. T 2662 , F 64, S 8, HMU 70533, I/A 11 ( 8.07.13).
Otros conceptos: Modifican los Articulos 5.2, 5.3, 6, 9,10 y 14 de los Estatutos Sociales. Datos registrales. T 2662 , F 64, S 8, HMU 70533, I/A 12 ( 8.07.13).
07 de Septiembre de 2012Revocaciones. Apo.Sol.: CRISTINA ARIAS PORTACELI;MARTA DE RAMON FERRANDO;JOSE MANUEL NIETO RANERO.Nombramientos. Apo.Sol.: JAVIER RODRIGUEZ MARTINEZ;MARIA FERRANDO ORTOLA;VICTORIA-ELISA PERERANAVAS;MIGUEL BOLIVAR TEJEDO. Datos registrales. T 2662 , F 63, S 8, H MU 70533, I/A 10 (30.08.12).
16 de Septiembre de 2011Articulo 378.5 del Reglamento del Registro Mercantil. Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2010 mediantecertificacion del organo de administracion. Datos registrales. T 2662 , F 63, S 8, H MU 70533, I/A 9 ( 6.09.11).
28 de Marzo de 2011Modificaciones estatutarias. Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/12. Datos registrales. T 2662 , F 63, S 8, H MU 70533, I/A 8(18.03.11).
02 de Agosto de 2010Ceses/Dimisiones. Representan: JOHANNES FRANCISCUS ROMULDUS CASTELIJN. Nombramientos. Representan:THEODORUS ARNOLDUS VAN ELDIK. Datos registrales. T 2662 , F 63, S 8, H MU 70533, I/A 7 (22.07.10).
07 de Julio de 2010Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: SABIC INNOVATIVE PLASTICS GP BV. Nombramientos. Adm. Unico: SABIC INNOVATIVEPLASTICS GP BV. Datos registrales. T 2662 , F 62, S 8, H MU 70533, I/A 6 (29.06.10).
11 de Junio de 2010Nombramientos. Apo.Manc.: ESTHER GARCIA TOLEDO;MARGARITA GARCIA SANCHEZ;ALFREDO MARTINEZ LOPEZ;EMMASIMO PINATELLA;TIMOTHY CHARLES STONESIFER;MARK-ROELAND DE-GROOT;JOHN-ANDREW BOUDREAU;WILLIAMGRANT COOPER DAKIN;JEFFREY TODD KENNEL. Datos registrales. T 2662 , F 62, S 8, H MU 70533, I/A 5 ( 1.06.10).
09 de Septiembre de 2009Revocaciones. Apo.Manc.: EDUARDO POUSADA PRADEL. Apo.Man.Soli: SERGIO CASADO LLORENTE. Nombramientos.Apo.Manc.: MARGARITA GARCIA SANCHEZ;ALFREDO MARTINEZ LOPEZ;EMMA SIMO PINATELLA;TIMOTHY CHARLESSTONESIFER;MARK-ROELAND DE-GROOT;JOHN-ANDREW BOUDREAU;WILLIAM GRANT COOPER DAKIN;JEFFREY TODDKENNEL. Datos registrales. T 2662 , F 61, S 8, H MU 70533, I/A 4 ( 1.09.09).
20 de Abril de 2009Nombramientos. Apo.Man.Soli: TIMOTHY CHARLES STONESIFER;MARK-ROELAND DE-GROOT;JOHN-ANDREWBOUDREAU;WILLIAM GRANT COOPER DAKIN;JEFFREY TODD KENNEL;SERGIO CASADO LLORENTE;MARGARITA GARCIASANCHEZ. Datos registrales. T 2662 , F 60, S 8, H MU 70533, I/A 3 ( 8.04.09).
09 de Febrero de 2009Cambio de domicilio social. CTRA CARTAGENA-ALHAMA DE MURCIA Km 13 - LA ALJORR (CARTAGENA). Datos registrales. T2662 , F 60, S 8, H MU 70533, I/A 2 (29.01.09).