Buscador CIF Logo

Actos BORME Sabic Innovative Plastics Gp B. V. S. Com

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Sabic Innovative Plastics Gp B. V. S. Com

Actos BORME Sabic Innovative Plastics Gp B. V. S. Com - D97930036

Tenemos registrados 18 Actos BORME del Registro Mercantil de Murcia para Sabic Innovative Plastics Gp B. V. S. Com con CIF D97930036

馃敊 Perfil de Sabic Innovative Plastics Gp B. V. S. Com
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Murcia

Actos BORME de Sabic Innovative Plastics Gp B. V. S. Com

14 de Diciembre de 2023
Ceses/Dimisiones. Representan: JUAN ANTONIO ALEMANY SAN JOSE. Revocaciones. Apo.Sol.: MARTI MORENO JORGEJUAN. Apo.Manc.: EMMA SIMO PINATELLA. Apo.Man.Soli: TIMOTHY CHARLES STONESIFER;MARK-ROELAND DE-GROOT;JOHN-ANDREW BOUDREAU;WILLIAM GRANT COOPER DAKIN;JEFFREY TODD KENNEL;MARGARITA GARCIASANCHEZ. Apo.Manc.: MARGARITA GARCIA SANCHEZ;EMMA SIMO PINATELLA;TIMOTHY CHARLES STONESIFER;MARK-ROELAND DE-GROOT;JOHN-ANDREW BOUDREAU;WILLIAM GRANT COOPER DAKIN;JEFFREY TODD KENNEL;ESTHERGARCIA TOLEDO;MARGARITA GARCIA SANCHEZ;EMMA SIMO PINATELLA;TIMOTHY CHARLES STONESIFER;MARK-ROELANDDE-GROOT;JOHN-ANDREW BOUDREAU;WILLIAM GRANT COOPER DAKIN;JEFFREY TODD KENNEL. Apo.Sol.: SABIC CAPITALBV. Apo.Manc.: SUSANA GUIJARRO CASTA脩ER;SUSANA GUIJARRO CASTA脩ER;ALFREDO MARTINEZ LOPEZ;ESTHERGARCIA TOLEDO;MARGARITA GARCIA SANCHEZ. Apo.Sol.: DANIEL GURREA BOIX;EDUARDO BAYONA GALVEZ;MARTAROCABERT CRUZ. Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 3213 , F 175, S 8, H MU 70533, I/A 19 ( 5.12.23).

23 de Febrero de 2022
Revocaciones. Apo.Manc.: ALFREDO MARTINEZ LOPEZ;ALFREDO MARTINEZ LOPEZ;ALFREDO MARTINEZ LOPEZ;ERIC RENEWOONS;DARIA VADIMOVNA SEVERINA. Datos registrales. T 3213 , F 175, S 8, H MU 70533, I/A 18 (16.02.22).

06 de Noviembre de 2020
Revocaciones. Apo.Sol.: FRANCISCO JAVIER MARTINEZ NADAL;JAVIER RODRIGUEZ MARTINEZ;MARIA FERRANDOORTOLA;VICTORIA-ELISA PERERA NAVAS;MIGUEL BOLIVAR TEJEDO. Nombramientos. Apo.Sol.: DANIEL GURREABOIX;EDUARDO BAYONA GALVEZ;MARTA ROCABERT CRUZ. Datos registrales. T 3213 , F 175, S 8, H MU 70533, I/A 17(29.10.20).

01 de Febrero de 2017
Nombramientos. Apo.Sol.: SABIC CAPITAL BV. Apo.Manc.: SUSANA GUIJARRO CASTA脩ER;ERIC RENE WOONS;DARIAVADIMOVNA SEVERINA. Datos registrales. T 2662 , F 65, S 8, H MU 70533, I/A 15 (25.01.17).

Nombramientos. Apo.Manc.: SUSANA GUIJARRO CASTA脩ER;ALFREDO MARTINEZ LOPEZ;ESTHER GARCIATOLEDO;MARGARITA GARCIA SANCHEZ. Datos registrales. T 2662 , F 65, S 8, H MU 70533, I/A 16 (25.01.17).

09 de Diciembre de 2016
Ceses/Dimisiones. Representan: THEODORUS ARNOLDUS VAN ELDIK. Nombramientos. Representan: JUAN ANTONIOALEMANY SAN JOSE. Datos registrales. T 2662 , F 65, S 8, H MU 70533, I/A 14 (30.11.16).

25 de Febrero de 2016
Ampliaci贸n de capital. Capital: 3.100,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.131.000,00 Euros. Datos registrales. T 2662 , F 64, S 8, HMU 70533, I/A 13 (18.02.16).

12 de Julio de 2013
Ampliaci贸n de capital. Capital: 3.100,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.127.900,00 Euros. Datos registrales. T 2662 , F 64, S 8, HMU 70533, I/A 11 ( 8.07.13).

Otros conceptos: Modifican los Articulos 5.2, 5.3, 6, 9,10 y 14 de los Estatutos Sociales. Datos registrales. T 2662 , F 64, S 8, HMU 70533, I/A 12 ( 8.07.13).

07 de Septiembre de 2012
Revocaciones. Apo.Sol.: CRISTINA ARIAS PORTACELI;MARTA DE RAMON FERRANDO;JOSE MANUEL NIETO RANERO.Nombramientos. Apo.Sol.: JAVIER RODRIGUEZ MARTINEZ;MARIA FERRANDO ORTOLA;VICTORIA-ELISA PERERANAVAS;MIGUEL BOLIVAR TEJEDO. Datos registrales. T 2662 , F 63, S 8, H MU 70533, I/A 10 (30.08.12).

16 de Septiembre de 2011
Articulo 378.5 del Reglamento del Registro Mercantil. Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2010 mediantecertificacion del organo de administracion. Datos registrales. T 2662 , F 63, S 8, H MU 70533, I/A 9 ( 6.09.11).

28 de Marzo de 2011
Modificaciones estatutarias. Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/12. Datos registrales. T 2662 , F 63, S 8, H MU 70533, I/A 8(18.03.11).

02 de Agosto de 2010
Ceses/Dimisiones. Representan: JOHANNES FRANCISCUS ROMULDUS CASTELIJN. Nombramientos. Representan:THEODORUS ARNOLDUS VAN ELDIK. Datos registrales. T 2662 , F 63, S 8, H MU 70533, I/A 7 (22.07.10).

07 de Julio de 2010
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: SABIC INNOVATIVE PLASTICS GP BV. Nombramientos. Adm. Unico: SABIC INNOVATIVEPLASTICS GP BV. Datos registrales. T 2662 , F 62, S 8, H MU 70533, I/A 6 (29.06.10).

11 de Junio de 2010
Nombramientos. Apo.Manc.: ESTHER GARCIA TOLEDO;MARGARITA GARCIA SANCHEZ;ALFREDO MARTINEZ LOPEZ;EMMASIMO PINATELLA;TIMOTHY CHARLES STONESIFER;MARK-ROELAND DE-GROOT;JOHN-ANDREW BOUDREAU;WILLIAMGRANT COOPER DAKIN;JEFFREY TODD KENNEL. Datos registrales. T 2662 , F 62, S 8, H MU 70533, I/A 5 ( 1.06.10).

09 de Septiembre de 2009
Revocaciones. Apo.Manc.: EDUARDO POUSADA PRADEL. Apo.Man.Soli: SERGIO CASADO LLORENTE. Nombramientos.Apo.Manc.: MARGARITA GARCIA SANCHEZ;ALFREDO MARTINEZ LOPEZ;EMMA SIMO PINATELLA;TIMOTHY CHARLESSTONESIFER;MARK-ROELAND DE-GROOT;JOHN-ANDREW BOUDREAU;WILLIAM GRANT COOPER DAKIN;JEFFREY TODDKENNEL. Datos registrales. T 2662 , F 61, S 8, H MU 70533, I/A 4 ( 1.09.09).

20 de Abril de 2009
Nombramientos. Apo.Man.Soli: TIMOTHY CHARLES STONESIFER;MARK-ROELAND DE-GROOT;JOHN-ANDREWBOUDREAU;WILLIAM GRANT COOPER DAKIN;JEFFREY TODD KENNEL;SERGIO CASADO LLORENTE;MARGARITA GARCIASANCHEZ. Datos registrales. T 2662 , F 60, S 8, H MU 70533, I/A 3 ( 8.04.09).

09 de Febrero de 2009
Cambio de domicilio social. CTRA CARTAGENA-ALHAMA DE MURCIA Km 13 - LA ALJORR (CARTAGENA). Datos registrales. T2662 , F 60, S 8, H MU 70533, I/A 2 (29.01.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n