Actos BORME de Sabico Seguridad Sociedad Anonima
21 de Octubre de 2022Revocaciones. Apoderado: HERNANDEZ GARCIA IKER. Datos registrales. T 2616 , F 107, S 8, H SS 4097, I/A 204 ( 5.10.22).
20 de Mayo de 2022Revocaciones. Apoderado: OLAZABAL CAMIO JUAN;ERQUICIA RODRIGUEZ MARIA-LUISA;MATA LORENZO RICARDO.Apo.Manc.: CULLA HERNANDEZ JOSE FRANCISCO;BADIA DOMENECH PABLO. Apo.Sol.: GONZALEZ GARCIAEDUARDO;MOLINERO MANTECON JUAN RAMON. Apoderado: BARRENA CRESPO ASIER. Datos registrales. T 2616 , F 107, S8, H SS 4097, I/A 203 ( 4.05.22).
26 de Agosto de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: VANACLOY ZANON JOSE VICENTE. Datos registrales. T 2616 , F 106, S 8, H SS 4097, I/A 202(16.08.21).
15 de Julio de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: PE脩A GOMEZ DIEGO. Datos registrales. T 2616 , F 104, S 8, H SS 4097, I/A 199 (30.06.21).
Nombramientos. Apo.Sol.: MEDINA SOLA ANA MARIA. Datos registrales. T 2616 , F 105, S 8, H SS 4097, I/A 200 (30.06.21).
Ceses/Dimisiones. Consejero: BARRANCO JIMENEZ VICTOR RAMON. Datos registrales. T 2616 , F 106, S 8, H SS 4097, I/A 201(30.06.21).
10 de Junio de 2021Nombramientos. Con.Delegado: ELOSEGUI SOTOS JOAQUIN. Datos registrales. T 2616 , F 104, S 8, H SS 4097, I/A 198 (1.06.21).
15 de Abril de 2021Reelecciones. Consejero: ELOSEGUI SOTOS JOAQUIN;ELOSEGUI AZCARATE JOAQUIN;LUZURIAGA SANTO DOMINGOBEATRIZ;RECALDE GONZALEZ VENANCIO;ERQUICIA RODRIGUEZ MARIA-LUISA;GALAGURU SL;ALUSTIZA GARCIAANGEL;ARRIZABALAGA IRAOLA JOSE-FRANCISCO;VALSECA 1 INVERSIONES SL. Presidente: ELOSEGUI SOTOS JOAQUIN.Secretario: ELOSEGUI AZCARATE JOAQUIN. Datos registrales. T 2616 , F 104, S 8, H SS 4097, I/A 197 ( 6.04.21).
16 de Noviembre de 2020Nombramientos. Apoderado: BATALLA RODRIGUEZ UNAI. Datos registrales. T 2616 , F 102, S 8, H SS 4097, I/A 195 (26.10.20).
Nombramientos. Apoderado: MORO MORO FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 2616 , F 103, S 8, H SS 4097, I/A 196(26.10.20).
19 de Diciembre de 2019Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 2616 , F 102, S 8, H SS 4097, I/A 194 ( 3.12.19).
27 de Noviembre de 2019Cambio de objeto social. Vigilancia y protecci贸n de bienes, establecimientos, espect谩culos, cert谩menes o convenciones. Protecci贸nde personas determinadas, previa la autorizaci贸n correspondiente. Dep贸sito, custodia, recuento y clasificaci贸n de monedas y billetes,t铆tulos-valores y dem谩s objetos ETC. Datos registrales. T 2616 , F 101, S 8, H SS 4097, I/A 193 (14.11.19).
20 de Agosto de 2019Revocaciones. Apoderado: BATALLA HERNAIZ JOSE-RAMON. Apo.Sol.: MORENO VIVAS PEDRO. Datos registrales. T 2616 , F101, S 8, H SS 4097, I/A 192 ( 2.08.19).
12 de Marzo de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: MOLINERO MANTECON JUAN RAMON. Datos registrales. T 2616 , F 99, S 8, H SS 4097, I/A 181(25.02.19).
Nombramientos. Apo.Sol.: ANDRES PRIETO AGUSTIN. Datos registrales. T 2616 , F 100, S 8, H SS 4097, I/A 182 (25.02.19).
Nombramientos. Apo.Sol.: CASTRO SILVA JOSE MARIA. Datos registrales. T 2616 , F 100, S 8, H SS 4097, I/A 183 (25.02.19).
Nombramientos. Apo.Sol.: CORTES SANCHEZ ANGEL. Datos registrales. T 2616 , F 100, S 8, H SS 4097, I/A 184 (25.02.19).
Nombramientos. Apo.Sol.: ESPA脩A IGLESIAS ANTONIO. Datos registrales. T 2616 , F 100, S 8, H SS 4097, I/A 185 (25.02.19).
Nombramientos. Apo.Sol.: BOSCH PE脩A NICOLAS. Datos registrales. T 2616 , F 100, S 8, H SS 4097, I/A 186 (25.02.19).
Nombramientos. Apo.Sol.: JIMENEZ DE LA PLATA RUIZ MARIA TERESA. Datos registrales. T 2616 , F 100, S 8, H SS 4097, I/A187 (25.02.19).
Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA DE LA FUENTE JUAN PABLO. Datos registrales. T 2616 , F 100, S 8, H SS 4097, I/A 188(25.02.19).
Nombramientos. Apo.Sol.: TORTOSA MARTINEZ ANTONIO. Datos registrales. T 2616 , F 101, S 8, H SS 4097, I/A 189 (25.02.19).
Revocaciones. Apo.Manc.: NISTAL RAMON PEDRO;ANDRES PRIETO AGUSTIN. Datos registrales. T 2616 , F 101, S 8, H SS4097, I/A 190 (25.02.19).
Nombramientos. Apo.Sol.: BOSCH LUNA JUAN LUIS. Datos registrales. T 2616 , F 101, S 8, H SS 4097, I/A 191 (25.02.19).
21 de Diciembre de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: VILLARREAL LABERNADIE AINHOA. Datos registrales. T 2616 , F 98, S 8, H SS 4097, I/A 180(14.12.18).
12 de Julio de 2018Nombramientos. Apoderado: MU脩OZ MARTINEZ MARIA CARMEN. Datos registrales. T 2616 , F 97, S 8, H SS 4097, I/A 179 (2.07.18).
28 de Junio de 2018Revocaciones. Apoderado: SILVA RODRIGUEZ JUAN-JOSE. Datos registrales. T 2616 , F 97, S 8, H SS 4097, I/A 178 (15.06.18).
14 de Mayo de 2018Nombramientos. Apoderado: BARRENA CRESPO ASIER. Datos registrales. T 2616 , F 96, S 8, H SS 4097, I/A 177 ( 8.05.18).
27 de Marzo de 2017Nombramientos. Apoderado: HERNANDEZ GARCIA IKER. Datos registrales. T 2616 , F 96, S 8, H SS 4097, I/A 176 (15.03.17).
15 de Diciembre de 2016Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 2616 , F 95, S 8, H SS 4097, I/A 175 ( 7.12.16).
01 de Diciembre de 2016Nombramientos. Apo.Sol.: GONZALEZ GARCIA EDUARDO. Datos registrales. T 2616 , F 95, S 8, H SS 4097, I/A 174 (18.11.16).
18 de Abril de 2016Nombramientos. Apo.Manc.: CULLA HERNANDEZ JOSE FRANCISCO;BADIA DOMENECH PABLO. Datos registrales. T 2616 , F94, S 8, H SS 4097, I/A 172 ( 6.04.16).
Nombramientos. Apo.Manc.: ANDRES PRIETO AGUSTIN;NISTAL RAMON PEDRO. Datos registrales. T 2616 , F 94, S 8, H SS4097, I/A 173 ( 6.04.16).
26 de Noviembre de 2015Revocaciones. Apoderado: RICA PEREZ RAUL;ALONSO LOPEZ ANGEL;MUGICA PERAL JOSE MIGUEL;ZAPIAIN SANCHEZSONIA;EGUIDAZU GORDOA PEDRO;GARATE MARCELLAN IGNACIO;MARTINEZ SANZ ROSARIO MONICA. Datos registrales. T2616 , F 94, S 8, H SS 4097, I/A 171 (12.11.15).
19 de Noviembre de 2015Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: ELOSEGUI SOTOS JOAQUIN. Secretario: ELOSEGUI AZCARATE JOAQUIN. Presidente:ELOSEGUI SOTOS JOAQUIN. Consejero: BARRANCO JIMENEZ VICTOR-RAMON;ARRIZABALAGA IRAOLA JOSE-FRANCISCO;LUZURIAGA SANTO DOMINGO BEATRIZ;ALUSTIZA GARCIA ANGEL;ELOSEGUI SOTOS JOAQUIN;URRESTILUZURIAGA VICTORIO;FUENTES OQUI脩ENA MIGUEL;RECALDE GONZALEZ VENANCIO;ELOSEGUI AZCARATEJOAQUIN;ERQUICIA RODRIGUEZ MARIA-LUISA. Cancelaciones de oficio de nombramientos. Consejero: GASCUE
Nombramientos. Con.Delegado: ELOSEGUI SOTOS JOAQUIN. Datos registrales. T 2616 , F 93, S 8, H SS 4097, I/A 168(11.11.15).
Nombramientos. Consejero: VALSECA 1 INVERSIONES SL. Datos registrales. T 2616 , F 94, S 8, H SS 4097, I/A 169 (12.11.15).
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 2616 , F 94, S 8, H SS 4097, I/A 170 (12.11.15).
17 de Septiembre de 2015Nombramientos. Apo.Man.Soli: PE脩A GOMEZ DIEGO;MEDINA SOLA ANA MARIA. Datos registrales. T 2616 , F 92, S 8, H SS4097, I/A 166 (11.09.15).
20 de Enero de 2015Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 2616 , F 92, S 8, H SS 4097, I/A 165 ( 5.01.15).
04 de Julio de 2014Revocaciones. Apoderado: ALVAREZ MONTESERIN JOSE-MARIA;ARRATE SAEZ MARIA LOURDES. Datos registrales. T 2616 ,F 92, S 8, H SS 4097, I/A 164 (24.06.14).
21 de Mayo de 2014Nombramientos. Apo.Sol.: MORENO VIVAS PEDRO. Datos registrales. T 2616 , F 92, S 8, H SS 4097, I/A 163 (13.05.14).
17 de Marzo de 2014Nombramientos. Apoderado: SORONDO RIVERO BE脩AT. Datos registrales. T 2616 , F 91, S 8, H SS 4097, I/A 162 ( 6.03.14).
04 de Febrero de 2013Nombramientos. Apo.Sol.: RECALDE GONZALEZ VENANCIO;ELOSEGUI AZCARATE JOAQUIN. Datos registrales. T 2083 , F116, S 8, H SS 4097, I/A 160 (28.01.13).
18 de Enero de 2013Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 129.641,71 Euros. Desembolsado: 129.641,71 Euros. Resultante Suscrito: 1.838.170,52 Euros.Resultante Desembolsado: 1.838.170,52 Euros. Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: GENERAL IBERICA DESEGURIDAD SA. Datos registrales. T 2083 , F 115, S 8, H SS 4097, I/A 159 (10.01.13).
14 de Diciembre de 2012Revocaciones. Apoderado: GARAYAR IRAZUSTA LINO;GARAYAR IRAZUSTA LINO. Datos registrales. T 2083 , F 115, S 8, H SS4097, I/A 158 ( 7.12.12).
02 de Enero de 2012Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 2083 , F 114, S 8, H SS 4097, I/A 156 (19.12.11).
Nombramientos. Apo.Sol.: RECALDE GONZALEZ VENANCIO;ELOSEGUI AZCARATE JOAQUIN. Datos registrales. T 2083 , F114, S 8, H SS 4097, I/A 157 (20.12.11).
07 de Abril de 2011Revocaciones. Apoderado: ARIETA-ARAUNABE脩A ESPA脩OL PEDRO. Datos registrales. T 2083 , F 114, S 8, H SS 4097, I/A 155(29.03.11).
11 de Noviembre de 2010Nombramientos. Con.Delegado: ELOSEGUI SOTOS JOAQUIN. Datos registrales. T 2083 , F 114, S 8, H SS 4097, I/A 154(29.10.10).
19 de Julio de 2010Revocaciones. Apoderado: BRAVO RODRIGUEZ FERNANDO. Datos registrales. T 2083 , F 114, S 8, H SS 4097, I/A 153 (9.07.10).
07 de Junio de 2010Nombramientos. Apo.Sol.: RODRIGO MANSO FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 2083 , F 113, S 8, H SS 4097, I/A 152(27.05.10).
22 de Junio de 2009P茅rdida del caracter de unipersonalidad. Datos registrales. T 2083 , F 113, S 8, H SS 4097, I/A 151 (10.06.09).
18 de Mayo de 2009Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 2083 , F 113, S 8, H SS 4097, I/A 150 ( 6.05.09).
05 de Febrero de 2009Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: INVESNOR SL. Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: INVESNOR SL. Nombramientos.Consejero: ELOSEGUI SOTOS JOAQUIN;ELOSEGUI AZCARATE JOAQUIN;LUZURIAGA SANTO DOMINGO BEATRIZ;RECALDEGONZALEZ VENANCIO;FUENTES OQUI脩ENA MIGUEL;ERQUICIA RODRIGUEZ MARIA-LUISA;URRESTI LUZURIAGAVICTORIO;ALUSTIZA GARCIA ANGEL;ARRIZABALAGA IRAOLA JOSE-FRANCISCO;GASCUE ECHEBESTE LAURA;BARRANCOJIMENEZ VICTOR-RAMON. Presidente: ELOSEGUI SOTOS JOAQUIN. Secretario: ELOSEGUI AZCARATE JOAQUIN.Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Consejo de administraci贸n. Datosregistrales. T 2083 , F 112, S 8, H SS 4097, I/A 149 (27.01.09).