Actos BORME de Sacyr Concesiones Sl
25 de Julio de 2023Revocaciones. Apoderado: FERNANDEZ PEREZ MARIA. Apo.Sol.: MEJUTO PITA ANDREA. Datos registrales. T 40340 , F 33, S8, H M 471022, I/A 96 (18.07.23).
26 de Mayo de 2023Revocaciones. Apo.Manc.: TARANCHEL CAMACHO JOSE ANGEL. Nombramientos. Apoderado: FRESNEDA GUERRA RAMON-MANUEL. Datos registrales. T 40340 , F 32, S 8, H M 471022, I/A 94 (19.05.23).
Nombramientos. Apoderado: PINACHO LASTRES PABLO. Datos registrales. T 40340 , F 32, S 8, H M 471022, I/A 95 (19.05.23).
05 de Abril de 2023Revocaciones. Apoderado: MU脩OZ MU脩OZ MARIA. Apo.Sol.: CAVA ALDANA RUBEN. Apoderado: MU脩OZ MU脩OZ MARIA.Apo.Man.Soli: MU脩OZ MU脩OZ MARIA. Apoderado: MU脩OZ MU脩OZ MARIA. Apo.Sol.: BARREIRA GOZALO VERONICA. Datosregistrales. T 40340 , F 32, S 8, H M 471022, I/A 93 (29.03.23).
16 de Enero de 2023Revocaciones. Apoderado: TARANCHEL CAMACHO JOSE ANGEL;TARANCHEL CAMACHO JOSE ANGEL;TARANCHELCAMACHO JOSE ANGEL. Datos registrales. T 40340 , F 32, S 8, H M 471022, I/A 92 ( 9.01.23).
22 de Noviembre de 2022Nombramientos. Apo.Manc.: JIMENEZ-ALFARO LARRAZABAL RODRIGO;GARCIA GONZALEZ IGNACIO;RODRIGUEZ-AVIALVILLALAIN FERNANDO;LEBRE DE LIMA FELIX JOSE NUNO HENRIQUES;TARANCHEL CAMACHO JOSE ANGEL;PINACHOLASTRES PABLO. Datos registrales. T 40340 , F 31, S 8, H M 471022, I/A 90 (15.11.22).
Revocaciones. Apoderado: GUIO CALLEJA JAVIER. Nombramientos. Apoderado: GARCIA GONZALEZ IGNACIO. Datosregistrales. T 40340 , F 31, S 8, H M 471022, I/A 91 (15.11.22).
07 de Noviembre de 2022Revocaciones. Apoderado: SUERO MARCOS LOURDES. Apo.Sol.: SUERO MARCOS LOURDES. Datos registrales. T 40340 , F31, S 8, H M 471022, I/A 89 (28.10.22).
29 de Septiembre de 2022Revocaciones. Apo.Manc.: OTERO FERNANDEZ JOSE CARLOS. Apoderado: OTERO FERNANDEZ JOSE CARLOS. Datosregistrales. T 40340 , F 31, S 8, H M 471022, I/A 88 (22.09.22).
14 de Septiembre de 2022Nombramientos. Apo.Sol.: ABRIL-MARTORELL HERNANDEZ PABLO;MARTINEZ CA脩AVATE MONTERO JAVIER;BERRIOCHOAALBEROLA CARLOS. Datos registrales. T 40340 , F 29, S 8, H M 471022, I/A 86 ( 7.09.22).
Nombramientos. Apo.Sol.: ABRIL-MARTORELL HERNANDEZ PABLO;MARTINEZ CA脩AVATE MONTERO JAVIER;BERRIOCHOAALBEROLA CARLOS. Datos registrales. T 40340 , F 30, S 8, H M 471022, I/A 87 ( 7.09.22).
09 de Septiembre de 2022Nombramientos. Apo.Sol.: RAMIREZ RODRIGUEZ ANTONIO ANGEL;RODRIGUEZ-AVIAL VILLALAIN FERNANDO. Datosregistrales. T 40340 , F 29, S 8, H M 471022, I/A 85 ( 2.09.22).
23 de Junio de 2022Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Aud.C.Con.: PRICEWATERHOUSECOOPERSAUDITORES SL. Datos registrales. T 40340 , F 28, S 8, H M 471022, I/A 84 (16.06.22).
22 de Abril de 2022Nombramientos. Apo.Sol.: MEJUTO PITA ANDREA;BARREIRA GOZALO VERONICA;LOPEZ DIEZ ROBERTO;SUERO MARCOSLOURDES. Datos registrales. T 40340 , F 28, S 8, H M 471022, I/A 83 (15.04.22).
10 de Marzo de 2022Nombramientos. Apo.Manc.: MIJANGOS GOROZARRI CARLOS. Datos registrales. T 40340 , F 28, S 8, H M 471022, I/A 82 (3.03.22).
17 de Febrero de 2022Revocaciones. Apo.Manc.: MOCHON LOPEZ PABLO. Apo.Man.Soli: MOCHON LOPEZ PABLO;MOCHON LOPEZ PABLO.Apoderado: MOCHON LOPEZ PABLO;MOCHON LOPEZ PABLO. Apo.Man.Soli: MOCHON LOPEZ PABLO. Datos registrales. T40340 , F 26, S 8, H M 471022, I/A 80 (10.02.22).
Nombramientos. Apoderado: ABRIL-MARTORELL HERNANDEZ PABLO;PELLON REVUELTA LEOPOLDO;MANRIQUE SABATELFABIO;GUIO CALLEJA JAVIER;JALON GONZALEZ EVA;MU脩OZ MU脩OZ MARIA;JIMENEZ-ALFARO LARRAZABALRODRIGO;RODRIGUEZ-AVIAL VILLALAIN FERNANDO;CAJA CALERO BEATRIZ;RODRIGUEZ DE TEMBLEQUE HERRUZOJUAN;DIAZ DEL RIO REDONDO PABLO;MIJANGOS GOROZARRI CARLOS;GARCIA URUE脩A LUIS ENRIQUE;OTEROESCUDERO PABLO;OTERO FERNANDEZ JOSE CARLOS;VENTURA GARCIA RODRIGUEZ FRANCISCO. Datos registrales. T40340 , F 26, S 8, H M 471022, I/A 81 (10.02.22).
08 de Noviembre de 2021Revocaciones. Apo.Sol.: CORRAL FERNANDEZ FELIX;CORRAL FERNANDEZ FELIX. Apo.Man.Soli: CORRAL FERNANDEZFELIX. Apoderado: CORRAL FERNANDEZ FELIX;CORRAL FERNANDEZ FELIX;LOUREDA LOPEZ SILVIA. Datos registrales. T40340 , F 23, S 8, H M 471022, I/A 78 (29.10.21).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: ABRIL-MARTORELL HERNANDEZ PABLO;PELLON REVUELTA LEOPOLDO;MANRIQUESABATEL FABIO;MOCHON LOPEZ PABLO;JALON GONZALEZ EVA;MU脩OZ MU脩OZ MARIA. Apo.Manc.: JIMENEZ-ALFAROLARRAZABAL RODRIGO;RODRIGUEZ-AVIAL VILLALAIN FERNANDO;CAJA CALERO BEATRIZ;RODRIGUEZ DE TEMBLEQUEHERRUZO JUAN;DIAZ DEL RIO REDONDO PABLO;GARCIA URUE脩A LUIS ENRIQUE;OTERO ESCUDERO PABLO;OTEROFERNANDEZ JOSE CARLOS;GARCIA RODRIGUEZ FRANCISCO VENTURA. Datos registrales. T 40340 , F 23, S 8, H M 471022,I/A 79 (29.10.21).
15 de Octubre de 2021Nombramientos. Apoderado: TARANCHEL CAMACHO JOSE ANGEL;GONZALEZ-LLANOS ROMERO LOURDES. Datosregistrales. T 40340 , F 22, S 8, H M 471022, I/A 76 ( 7.10.21).
Nombramientos. Apoderado: COMENDADOR CASARRUBIOS SANDRA;PINACHO LASTRES PABLO;TARANCHEL CAMACHOJOSE ANGEL;MANJON MANJON TERESA;IBA脩EZ MU脩OZ JOSE IGNACIO;FERNANDEZ PEREZ MARIA;SUERO MARCOSLOURDES;GONZALEZ-LLANOS ROMERO LOURDES;COLOMER DE LA TORRE ANA MARIA. Datos registrales. T 40340 , F 22, S
04 de Agosto de 2021Nombramientos. Apoderado: MOCHON LOPEZ PABLO. Datos registrales. T 40340 , F 22, S 8, H M 471022, I/A 75 (28.07.21).
07 de Junio de 2021Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 40340 , F 21, S 8, H M471022, I/A 74 (31.05.21).
10 de Septiembre de 2020Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 40340 , F 21, S 8, H M471022, I/A 73 ( 3.09.20).
13 de Marzo de 2020Nombramientos. Apoderado: CORRAL FERNANDEZ FELIX;MANRIQUE SABATEL FABIO;MOCHON LOPEZ PABLO;JALONGONZALEZ EVA;MU脩OZ MU脩OZ MARIA;LOUREDA LOPEZ SILVIA;JIMENEZ-ALFARO LARRAZABAL RODRIGO;RODRIGUEZ-AVIAL VILLALAIN FERNANDO;CAJA CALERO BEATRIZ;RODRIGUEZ DE TEMBLEQUE HERRUZO JUAN;DIAZ DEL RIOREDONDO PABLO;MIJANGOS GORONZARRI CARLOS;GARCIA URUE脩A LUIS ENRIQUE;OTERO ESCUDERO PABLO;OTEROFERNANDEZ JOSE CARLOS;VENTURA GARCIA RODRIGUEZ FRANCISCO. Datos registrales. T 27095 , F 225, S 8, H M 471022,I/A 72 ( 6.03.20).
12 de Septiembre de 2019Cambio de domicilio social. C/ CONDESA DE VENADITO 7 (MADRID). Datos registrales. T 27095 , F 225, S 8, H M 471022, I/A71 ( 5.09.19).
02 de Agosto de 2019Nombramientos. Apoderado: TARANCHEL CAMACHO JOSE ANGEL. Datos registrales. T 27095 , F 225, S 8, H M 471022, I/A 70(26.07.19).
08 de Noviembre de 2018Revocaciones. Apoderado: RANZ AZCUTIA ELISA. Datos registrales. T 27095 , F 224, S 8, H M 471022, I/A 69 (30.10.18).
27 de Julio de 2018Revocaciones. Apoderado: GRITTI BRAVO SERGIO OSVALDO;FACUSE MELENDEZ JUAN ALBERTO;CASTRO RUIZ RENEDAVID. Datos registrales. T 27095 , F 224, S 8, H M 471022, I/A 68 (20.07.18).
29 de Junio de 2018Nombramientos. Consejero: SIGUENZA HERNANDEZ PEDRO. Datos registrales. T 27095 , F 224, S 8, H M 471022, I/A 67(21.06.18).
25 de Junio de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: ORIHUELA UZAL JOSE MARIA;BERRIOCHOA ALBEROLA CARLOS. Datos registrales. T 27095 ,F 224, S 8, H M 471022, I/A 66 (18.06.18).
22 de Junio de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: CAVA ALDANA RUBEN. Datos registrales. T 27095 , F 223, S 8, H M 471022, I/A 65 (15.06.18).
18 de Mayo de 2018Ceses/Dimisiones. Secretario: RIELVES PILAS MIGUEL ANGEL. Nombramientos. SecreNoConsj: GUILLAMON CRIADOANTONIO. Datos registrales. T 27095 , F 223, S 8, H M 471022, I/A 64 ( 7.05.18).
13 de Marzo de 2018Nombramientos. Consejero: BERRIOCHOA ALBEROLA CARLOS. Datos registrales. T 27095 , F 223, S 8, H M 471022, I/A 63 (
23 de Enero de 2018Ampliaci贸n de capital. Capital: 1.000.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 407.666.620,00 Euros. Datos registrales. T 27095 , F 222,S 8, H M 471022, I/A 62 (16.01.18).
05 de Octubre de 2017Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 27095 , F 222, S 8, H M471022, I/A 61 (27.09.17).
31 de Mayo de 2017Nombramientos. Apo.Sol.: PEREZ-MARSA VALLBONA JOAQUIN;GUILLAMON CRIADO ANTONIO. Datos registrales. T 27095 , F221, S 8, H M 471022, I/A 60 (23.05.17).
20 de Abril de 2017Nombramientos. Apoderado: GARCIA DENCHE MARTA;IBA脩EZ MU脩OZ JOSE IGNACIO;IGLESIAS DE PABLOS DANIEL. Datosregistrales. T 27095 , F 221, S 8, H M 471022, I/A 59 (10.04.17).
21 de Marzo de 2017Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ-AVIAL VILLALAIN FERNANDO. Datos registrales. T 27095 , F 221, S 8, H M 471022,I/A 58 ( 9.03.17).
30 de Diciembre de 2016Ampliaci贸n de capital. Capital: 1.000.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 406.666.620,00 Euros. Datos registrales. T 27095 , F 220,S 8, H M 471022, I/A 57 (21.12.16).
28 de Diciembre de 2016Revocaciones. Apoderado: REINA GALLARDO ANTONIO. Apo.Sol.: REINA GALLARDO ANTONIO. Nombramientos. Apoderado:PINACHO LASTRES PABLO. Datos registrales. T 27095 , F 220, S 8, H M 471022, I/A 56 (19.12.16).
07 de Diciembre de 2016Revocaciones. Apoderado: SEGURA FERNANDEZ ANDREA. Datos registrales. T 27095 , F 219, S 8, H M 471022, I/A 55(28.11.16).
28 de Septiembre de 2016Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 27095 , F 219, S 8, H M471022, I/A 54 (21.09.16).
06 de Septiembre de 2016Revocaciones. Apo.Sol.: DEL COLLADO CARO INMACULADA. Datos registrales. T 27095 , F 219, S 8, H M 471022, I/A 53(29.08.16).
26 de Agosto de 2016Nombramientos. Apo.Sol.: LIMA FELIX NUNO;PINACHO LASTRES PABLO. Datos registrales. T 27095 , F 219, S 8, H M 471022,I/A 52 (17.08.16).
06 de Abril de 2016Nombramientos. Apoderado: LIMA FELIX NUNO. Datos registrales. T 27095 , F 218, S 8, H M 471022, I/A 51 (29.03.16).
05 de Abril de 2016Nombramientos. Apoderado: MU脩OZ MU脩OZ MARIA;JIMENEZ-ALFARO LARRAZABAL RODRIGO;MOCHON LOPEZPABLO;CORRAL FERNANDEZ FELIX;RODRIGUEZ-AVIAL VILLALAIN FERNANDO;JALON GONZALEZ EVA. Datos registrales. T27095 , F 216, S 8, H M 471022, I/A 49 (21.03.16).
Nombramientos. Apoderado: NOTARIO NIETO MARIA. Datos registrales. T 27095 , F 218, S 8, H M 471022, I/A 50 (21.03.16).
26 de Enero de 2016Ampliaci贸n de capital. Capital: 1.000.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 405.666.620,00 Euros. Datos registrales. T 27095 , F 216,S 8, H M 471022, I/A 48 (19.01.16).
14 de Enero de 2016Revocaciones. Apo.Sol.: ULLASTRES FERNANDEZ JOSE IGNACIO. Datos registrales. T 27095 , F 216, S 8, H M 471022, I/A 47 (5.01.16).
29 de Diciembre de 2015Revocaciones. Apoderado: NAHARRO CASTRILLO JOSE MANUEL. Datos registrales. T 27095 , F 215, S 8, H M 471022, I/A 46(21.12.15).
16 de Diciembre de 2015Nombramientos. Apoderado: SEGURA FERNANDEZ ANDREA;RANZ AZCUTIA ELISA. Datos registrales. T 27095 , F 215, S 8, HM 471022, I/A 45 ( 7.12.15).
04 de Noviembre de 2015Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: MIJANGOS GOROZARRI CARLOS. Nombramientos. Consejero: GOMEZ DEL RIO SANZHERNANZ RAFAEL. Con.Delegado: GOMEZ DEL RIO SANZ HERNANZ RAFAEL. Datos registrales. T 27095 , F 214, S 8, H M471022, I/A 44 (28.10.15).
08 de Octubre de 2015Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 27095 , F 214, S 8, H M471022, I/A 43 (30.09.15).
10 de Junio de 2015Modificaciones estatutarias. SE REFUNDEN LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 27095 , F 211, S 8, H M 471022,I/A 42 ( 2.06.15).
08 de Junio de 2015Nombramientos. Apo.Sol.: CORRAL FERNANDEZ FELIX. Datos registrales. T 27095 , F 158, S 8, H M 471022, I/A 40 (27.05.15).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: CORRAL FERNANDEZ FELIX;GOMEZ DEL RIO SANZ HERNANZ RAFAEL;RODRIGUEZ-AVIALVILLALAIN FERNANDO;MOCHON LOPEZ PABLO. Datos registrales. T 27095 , F 159, S 8, H M 471022, I/A 41 (28.05.15).
03 de Junio de 2015Nombramientos. Apo.Sol.: CORRAL FERNANDEZ FELIX. Datos registrales. T 27095 , F 157, S 8, H M 471022, I/A 39 (27.05.15).
17 de Marzo de 2015Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: ORIHUELA UZAL JOSE MARIA. Nombramientos. Con.Delegado: MIJANGOS GOROZARRICARLOS. Datos registrales. T 27095 , F 157, S 8, H M 471022, I/A 38 ( 9.03.15).
01 de Diciembre de 2014Nombramientos. Apo.Sol.: MARTIN LARA JAIME;ULLASTRES FERNANDEZ JOSE IGNACIO. Datos registrales. T 27095 , F 156,S 8, H M 471022, I/A 36 (21.11.14).
Nombramientos. Apo.Sol.: REINA GALLARDO ANTONIO;DEL COLLADO CARO INMACULADA. Datos registrales. T 27095 , F157, S 8, H M 471022, I/A 37 (21.11.14).
12 de Noviembre de 2014Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 27095 , F 156, S 8, H M471022, I/A 35 ( 3.11.14).
07 de Mayo de 2014Revocaciones. Apoderado: DE SAN JOSE TORIJA JORGE. Datos registrales. T 27095 , F 156, S 8, H M 471022, I/A 34 (25.04.14).
09 de Enero de 2014Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 27095 , F 155, S 8, H M471022, I/A 33 (30.12.13).
05 de Marzo de 2013Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ CAMINO RUIZ DE BUCESTA I脩IGO. Datos registrales. T 27095 , F 155, S 8, H M471022, I/A 32 (22.02.13).
05 de Febrero de 2013Nombramientos. Apo.Man.Soli: MIJANGOS GOROZARRI CARLOS;GOMEZ DEL RIO SANZ HERNANZ RAFAEL;MOCHON LOPEZPABLO;RODRIGUEZ-AVIAL VILLALAIN FERNANDO. Datos registrales. T 27095 , F 153, S 8, H M 471022, I/A 31 (28.01.13).
20 de Diciembre de 2012Ampliaci贸n de capital. Capital: 10.000.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 404.666.620,00 Euros. Modificaciones estatutarias.Art铆culo de los estatutos: 5. Capital.-. Datos registrales. T 27095 , F 153, S 8, H M 471022, I/A 30 (12.12.12).
19 de Octubre de 2012Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 27095 , F 153, S 8, H M 471022, I/A 29 ( 5.10.12).
26 de Junio de 2012Nombramientos. Apo.Manc.: MIJANGOS GOROZARRI CARLOS;MOCHON LOPEZ PABLO. Datos registrales. T 27095 , F 151, S8, H M 471022, I/A 28 (14.06.12).
06 de Junio de 2012Revocaciones. Apoderado: ORTIZ LORENZO GONZALO. Nombramientos. Apoderado: BERRIOCHOA ALBEROLA CARLOS.Datos registrales. T 27095 , F 150, S 8, H M 471022, I/A 27 (25.05.12).
03 de Mayo de 2012Modificaciones estatutarias. 17. Administraci贸n y Representacion.-. Datos registrales. T 27095 , F 150, S 8, H M 471022, I/A 26(20.04.12).
18 de Abril de 2012Nombramientos. Presidente: MANRIQUE CECILIA MANUEL. Datos registrales. T 27095 , F 150, S 8, H M 471022, I/A 25 (2.04.12).
09 de Enero de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: DEL RIVERO ASENSIO LUIS FERNANDO. Presidente: DEL RIVERO ASENSIO LUIS FERNANDO.Datos registrales. T 27095 , F 150, S 8, H M 471022, I/A 24 (27.12.11).
17 de Agosto de 2011Nombramientos. Apoderado: RAMIREZ RODRIGUEZ ANTONIO. Datos registrales. T 27095 , F 149, S 8, H M 471022, I/A 23 (4.08.11).
08 de Abril de 2011Revocaciones. Apoderado: ESTEVEZ ALAVEZ GERMAN. Datos registrales. T 27095 , F 149, S 8, H M 471022, I/A 22 (25.03.11).
21 de Marzo de 2011Nombramientos. Apoderado: MIJANGOS GOROZARRI CARLOS;ORTIZ LORENZO GONZALO. Datos registrales. T 27095 , F148, S 8, H M 471022, I/A 21 ( 9.03.11).
02 de Febrero de 2011Revocaciones. Apoderado: AYESTA FERNANDEZ-PACHECO FIDEL. Datos registrales. T 27095 , F 148, S 8, H M 471022, I/A 20(20.01.11).
31 de Diciembre de 2010Nombramientos. Apoderado: VENEGAS JIMENEZ MILAGROS. Datos registrales. T 27095 , F 147, S 8, H M 471022, I/A 19(22.12.10).
01 de Diciembre de 2010Revocaciones. Apoderado: PINO GIRALDEZ MANUEL. Datos registrales. T 27095 , F 147, S 8, H M 471022, I/A 18 (22.11.10).
30 de Noviembre de 2010Nombramientos. Apoderado: GRITTI BRAVO SERGIO OSVALDO;FACUSE MELENDEZ JUAN ALBERTO;CASTRO RUIZ RENEDAVID. Datos registrales. T 27095 , F 147, S 8, H M 471022, I/A 17 (18.11.10).
Nombramientos. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 27095 , F 147, S 8, H M 471022, I/A 16 (18.11.10).
15 de Octubre de 2010Nombramientos. Apoderado: DE SAN JOSE TORIJA JORGE. Datos registrales. T 27095 , F 146, S 8, H M 471022, I/A 15 (4.10.10).
13 de Julio de 2010Modificaciones estatutarias. MODIFICADO EL ARTICULO 7. Datos registrales. T 27095 , F 146, S 8, H M 471022, I/A 14 (1.07.10).
06 de Mayo de 2010Ampliaci贸n de capital. Capital: 44.150.800,00 Euros. Resultante Suscrito: 394.666.620,00 Euros. Datos registrales. T 27095 , F144, S 8, H M 471022, I/A 13 (26.04.10).
30 de Marzo de 2010Ampliaci贸n de capital. Capital: 770.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 350.515.820,00 Euros. Datos registrales. T 27095 , F 143, S8, H M 471022, I/A 12 (16.03.10).
05 de Marzo de 2010Modificaciones estatutarias. MODIFICADO EL ARTICULO 17 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 27095 , F143, S 8, H M 471022, I/A 11 (23.02.10).
04 de Marzo de 2010Nombramientos. Apoderado: REINA GALLARDO ANTONIO;PINO GIRALDEZ MANUEL;AYESTA FERNANDEZ-PACHECOFIDEL;MANJON MANJON TERESA;ESTEVEZ ALAVEZ GERMAN. Datos registrales. T 27095 , F 142, S 8, H M 471022, I/A 10(22.02.10).
02 de Marzo de 2010Ampliaci贸n de capital. Capital: 4.384.120,00 Euros. Resultante Suscrito: 349.745.820,00 Euros. Datos registrales. T 27095 , F 142,S 8, H M 471022, I/A 9 (18.02.10).
07 de Enero de 2010Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 27095 , F 141, S 8, H M 471022, I/A 8 (23.12.09).
28 de Diciembre de 2009Ampliaci贸n de capital. Capital: 157.542.900,00 Euros. Resultante Suscrito: 345.361.700,00 Euros. Datos registrales. T 27095 , F140, S 8, H M 471022, I/A 7 (16.12.09).
02 de Diciembre de 2009Ampliaci贸n de capital. Capital: 82.558.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 187.818.800,00 Euros. Datos registrales. T 26132 , F101, S 8, H M 471022, I/A 6 (23.11.09).
18 de Noviembre de 2009Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: OTERO FERNANDEZ JOSE CARLOS;DEL PINO AGUILERA SANTIAGO. Nombramientos.Consejero: ORIHUELA UZAL JOSE MARIA;DEL RIVERO ASENSIO LUIS FERNANDO;MANRIQUE CECILIA MANUEL;MIJANGOSGOROZARRI CARLOS. Presidente: DEL RIVERO ASENSIO LUIS FERNANDO. Con.Delegado: ORIHUELA UZAL JOSE MARIA.SecreNoConsj: RIELVES PILAS MIGUEL ANGEL. Ampliaci贸n de capital. Capital: 68.363.800,00 Euros. Resultante Suscrito:105.260.800,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores solidarios a Consejo deadministraci贸n. Datos registrales. T 26132 , F 98, S 8, H M 471022, I/A 5 ( 6.11.09).
30 de Octubre de 2009Ampliaci贸n de capital. Capital: 36.887.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 36.897.000,00 Euros. Datos registrales. T 26132 , F 97,S 8, H M 471022, I/A 4 (20.10.09).
31 de Julio de 2009Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ PEREZ DAVID;SANCHEZ ARGUDO ANA MARGARITA;NAHARRO CASTRILLO JOSEMANUEL. Datos registrales. T 26132 , F 97, S 8, H M 471022, I/A 3 (21.07.09).