Buscador CIF Logo

Actos BORME Sacyr Vallehermoso Participaciones Mobiliarias Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Sacyr Vallehermoso Participaciones Mobiliarias Sl

Actos BORME Sacyr Vallehermoso Participaciones Mobiliarias Sl - B84791516

Tenemos registrados 28 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Sacyr Vallehermoso Participaciones Mobiliarias Sl con CIF B84791516

馃敊 Perfil de Sacyr Vallehermoso Participaciones Mobiliarias Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Sacyr Vallehermoso Participaciones Mobiliarias Sl

10 de Octubre de 2023
Ceses/Dimisiones. Representan: MIJANGOS GOROZARRI CARLOS. Adm. Unico: SACYR SA. Revocaciones. Apoderado:MIJANGOS GOROZARRI CARLOS;GARCIA URUE脩A LUIS ENRIQUE;GARCIA RODRIGUEZ FRANCISCO VENTURA;ROBERTORODRIGUEZ DOMINGUEZ;OTERO ESCUDERO PABLO;GOMEZ GOMEZ DAVID;FERRERO COLLADO RAMIRO;CABRERAHERRERO MARIA. Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 33024 , F 219, S 8, H M 412619, I/A 30 ( 3.10.23).

02 de Noviembre de 2022
Nombramientos. Apoderado: OTERO FERNANDEZ JOSE CARLOS. Fe de erratas: Se omiti贸 publicar por error en la inscripci贸n 17el nombramiento de OTERO FERNANDEZ JOSE CARLOS como apoderado. Datos registrales. T 33024 , F 215, S 8, H M 412619,I/A 17 ( 2.11.15).

Revocaciones. Apoderado: CAMACHO CALDERON JOAQUIN;OTERO FERNANDEZ JOSE CARLOS. Datos registrales. T 33024 ,F 219, S 8, H M 412619, I/A 29 (25.10.22).

03 de Marzo de 2021
Ceses/Dimisiones. Representan: MANRIQUE CECILIA MANUEL. Nombramientos. Representan: MIJANGOS GOROZARRICARLOS. Datos registrales. T 33024 , F 219, S 8, H M 412619, I/A 28 (24.02.21).

11 de Febrero de 2020
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 599.997.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.000,00 Euros. Datos registrales. T 33024 ,F 218, S 8, H M 412619, I/A 27 ( 4.02.20).

09 de Octubre de 2019
Cambio de domicilio social. C/ CONDESA DE VENADITO 7 (MADRID). Datos registrales. T 33024 , F 218, S 8, H M 412619, I/A26 ( 2.10.19).

04 de Octubre de 2017
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 33024 , F 218, S 8, H M 412619, I/A 25 (27.09.17).

09 de Mayo de 2017
Revocaciones. Apoderado: ALVAREZ FERNANDEZ SUSANA. Datos registrales. T 33024 , F 218, S 8, H M 412619, I/A 24(27.04.17).

28 de Julio de 2016
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 33024 , F 217, S 8, H M 412619, I/A 23 (20.07.16).

21 de Marzo de 2016
Revocaciones. Apoderado: PALOMO GOMEZ RAFAEL. Datos registrales. T 33024 , F 217, S 8, H M 412619, I/A 21 (10.03.16).

Revocaciones. Apoderado: BUENO ROYO ROCIO. Datos registrales. T 33024 , F 217, S 8, H M 412619, I/A 22 (11.03.16).

03 de Febrero de 2016
Revocaciones. Apo.Man.Soli: NU脩EZ CABALLERO FELIX. Apoderado: NU脩EZ CABALLERO FELIX. Datos registrales. T 33024 ,F 217, S 8, H M 412619, I/A 20 (27.01.16).

29 de Diciembre de 2015
Revocaciones. Apo.Man.Soli: PALOMO GOMEZ RAFAEL;GARCIA URUE脩A LUIS ENRIQUE;ALVAREZ FERNANDEZSUSANA;GARCIA RODRIGUEZ FRANCISCO-VENTURA;ROBERTO RODRIGUEZ DOMINGUEZ;CAMACHO CALDERONJOAQUIN;OTERO ESCUDERO PABLO;OTERO FERNANDEZ JOSE CARLOS;GOMEZ GOMEZ DAVID;BUENO ROYOROCIO;FERRERO COLLADO RAMIRO;CABRERA HERRERO MARIA. Datos registrales. T 33024 , F 217, S 8, H M 412619, I/A 19(21.12.15).

12 de Noviembre de 2015
Revocaciones. Apo.Man.Soli: GORTAZAR SANCHEZ TORRES JUAN EDUARDO. Datos registrales. T 33024 , F 217, S 8, H M412619, I/A 18 ( 3.11.15).

11 de Noviembre de 2015
Nombramientos. Apoderado: MIJANGOS GOROZARRI CARLOS;PALOMO GOMEZ RAFAEL;GARCIA URUE脩A LUISENRIQUE;ALVAREZ FERNANDEZ SUSANA;GARCIA RODRIGUEZ FRANCISCO VENTURA;ROBERTO RODRIGUEZDOMINGUEZ;CAMACHO CALDERON JOAQUIN;OTERO ESCUDERO PABLO;GOMEZ GOMEZ DAVID;NU脩EZ CABALLEROFELIX;BUENO ROYO ROCIO;FERRERO COLLADO RAMIRO;CABRERA HERRERO MARIA. Datos registrales. T 33024 , F 215, S8, H M 412619, I/A 17 ( 2.11.15).

05 de Agosto de 2015
Revocaciones. Apo.Man.Soli: OTERO FERNANDEZ JOSE CARLOS;GOMEZ GOMEZ DAVID;NU脩EZ CABALLERO FELIX;BUENOROYO ROCIO;FERRERO COLLADO RAMIRO;CABRERA HERRERO MARIA;LACADENA AZPEITIA FERNANDO;PALOMO GOMEZRAFAEL;GARCIA URE脩A LUIS ENRIQUE;ALVAREZ FERNANDEZ SUSANA;VENTURA GARCIA RODRIGUEZFRANCISCO;RODRIGUEZ DOMINGUEZ ROBERTO;ADALID MOLL JOSE LUIS. Datos registrales. T 33024 , F 215, S 8, H M412619, I/A 16 (28.07.15).

13 de Julio de 2015
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GORTAZAR SANCHEZ TORRES JUAN EDUARDO;PALOMO GOMEZ RAFAEL;GARCIA URUE脩ALUIS ENRIQUE;ALVAREZ FERNANDEZ SUSANA;GARCIA RODRIGUEZ FRANCISCO-VENTURA;ROBERTO RODRIGUEZDOMINGUEZ;CAMACHO CALDERON JOAQUIN;OTERO ESCUDERO PABLO;OTERO FERNANDEZ JOSE CARLOS;GOMEZGOMEZ DAVID;NU脩EZ CABALLERO FELIX;BUENO ROYO ROCIO;FERRERO COLLADO RAMIRO;CABRERA HERRERO MARIA.Datos registrales. T 23033 , F 111, S 8, H M 412619, I/A 15 ( 6.07.15).

25 de Junio de 2015
Revocaciones. Apo.Man.Soli: CALLEJA MATEO GONZALO. Datos registrales. T 23033 , F 111, S 8, H M 412619, I/A 14(18.06.15).

20 de Marzo de 2015
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 23033 , F 111, S 8, H M 412619, I/A 12 ( 9.03.15).

Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 23033 , F 111, S 8, H M 412619, I/A 13 ( 9.03.15).

06 de Noviembre de 2014
Revocaciones. Apo.Man.Soli: NAVAZO MORRONDO VICTORIA;MARTINEZ BRAVO JOSE LUIS. Datos registrales. T 23033 , F111, S 8, H M 412619, I/A 11 (27.10.14).

19 de Diciembre de 2013
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 23033 , F 110, S 8, H M 412619, I/A 10 (11.12.13).

01 de Febrero de 2013
Ampliaci贸n de capital. Capital: 200.000.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 600.000.000,00 Euros. Datos registrales. T 23033 , F110, S 8, H M 412619, I/A 9 (23.01.13).

30 de Abril de 2012
Ampliaci贸n de capital. Capital: 200.000.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 400.000.000,00 Euros. Datos registrales. T 23033 , F109, S 8, H M 412619, I/A 8 (18.04.12).

09 de Enero de 2012
Nombramientos. Apo.Man.Soli: OTERO FERNANDEZ JOSE CARLOS;NAVAZO MORRONDO VICTORIA;GOMEZ GOMEZDAVID;NU脩EZ CABALLERO FELIX;BUENO ROYO ROCIO;FERRERO COLLADO RAMIRO;CABRERA HERRERO

05 de Enero de 2012
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: OTERO FERNANDEZ JOSE CARLOS;DEL PINO AGUILERA SANTIAGO. Nombramientos. Adm.Unico: SACYR VALLEHERMOSO SA. Representan: MANRIQUE CECILIA MANUEL. Modificaciones estatutarias. Cambio delOrgano de Administraci贸n: Administradores solidarios a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 23033 , F 106, S 8, H M 412619,I/A 6 (26.12.11).

26 de Diciembre de 2011
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: DEL RIVERO ASENSIO LUIS FERNANDO. Datos registrales. T 23033 , F 106, S 8, H M 412619,I/A 5 (14.12.11).

22 de Noviembre de 2010
Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 23033 , F 106, S 8, H M 412619, I/A 4 (10.11.10).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n