Actos BORME de Sada P A Valencia Sa
27 de Noviembre de 2020Disolución. Fusion. Extinción. Datos registrales. T 10824, L 8103, F 141, S 8, H V 18333, I/A 136 (23.11.20).
20 de Julio de 2020Revocaciones. Apoderado: FERNANDEZ DOCTOR JUAN PEDRO. Apo.Manc.: FERNANDEZ DOCTOR JUANPEDRO;FERNANDEZ DOCTOR JUAN PEDRO;FERNANDEZ DOCTOR JUAN PEDRO. Datos registrales. T 10824, L 8103, F 140, S
17 de Julio de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: ROCA BALLESTER JAVIER;VELASCO ARROYO ENRIQUE;VICENS ROIG FRANCISCO.Presidente: VELASCO ARROYO ENRIQUE. Vicepresid.: ROCA BALLESTER JAVIER. Secretario: GOMEZ DE BONILLA GONZALEZMARIA ELISA. Nombramientos. Adm. Mancom.: DOALLO ALVAREZ ARTURO;VICENS ROIG FRANCISCO. Otros conceptos:Modificación y refundición de estatutos Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradoresmancomunados. Datos registrales. T 9904, L 7186, F 140, S 8, H V 18333, I/A 134 (10.07.20).
10 de Febrero de 2020Revocaciones. Apo.Manc.: DEL BOSQUE SAENZ MARTA;DEL BOSQUE SAENZ MARTA;DEL BOSQUE SAENZ MARTA. Apo.Sol.:MEGO PEREZ ROSA MARIA. Apoderado: RAMOS DIEZ AGUSTIN. Apo.Manc.: IGESUND KETIL PETTER;BELLES MEDALLSANTIAGO. Apo.Sol.: SANTANATALIA LEDESMA FRANCISCO MANUEL;FERRER SALAS JERONI. Datos registrales. T 9904, L7186, F 139, S 8, H V 18333, I/A 133 ( 3.02.20).
25 de Noviembre de 2019Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 9904, L 7186, F 139, S 8, H V 18333, I/A 132 (18.11.19).
14 de Octubre de 2019Revocaciones. Apo.Man.Soli: GERARDUS HENDRIKUS JOHANNES VAN DEN BERG. Apo.Manc.: GERARDUS HENDRIKUSJOHANNES VAN DEN BERG. Datos registrales. T 9904, L 7186, F 139, S 8, H V 18333, I/A 131 ( 7.10.19).
08 de Julio de 2019Revocaciones. Apo.Sol.: ARLANDIS GUZMAN VICENTE JOSE. Datos registrales. T 9904, L 7186, F 139, S 8, H V 18333, I/A 130 (1.07.19).
09 de Mayo de 2019Nombramientos. Apoderado: GIL RODRIGO JOSEFA. Datos registrales. T 9904, L 7186, F 139, S 8, H V 18333, I/A 129 ( 2.05.19).
05 de Abril de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: GOMEZ DE BONILLA GONZALEZ MARIA ELISA;DEL CAMPO PASTOR AMALIA MARIA. Datosregistrales. T 9904, L 7186, F 132, S 8, H V 18333, I/A 127 (29.03.19).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: DE ANCOS ARACIL ELENA. Apo.Manc.: VICENS ROIG FRANCISCO;FERNANDEZ DOCTOR JUANPEDRO;DEL BOSQUE SAENZ MARTA;MONTON APARICIO MIGUEL ANGEL;VELASCO ARROYO ENRIQUE;ROCA BALLESTERJAVIER. Datos registrales. T 9904, L 7186, F 132, S 8, H V 18333, I/A 128 (29.03.19).
18 de Enero de 2019Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 9904, L 7186, F 132, S 8, H V 18333, I/A 126 (11.01.19).
07 de Septiembre de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: MONTON APARICIO MIGUEL ANGEL. Vicepresid.: VICENS ROIG FRANCISCO. Nombramientos.Consejero: ROCA BALLESTER JAVIER. Vicepresid.: ROCA BALLESTER JAVIER. Reelecciones. Consejero: VELASCO ARROYOENRIQUE;VICENS ROIG FRANCISCO. Secretario: GOMEZ DE BONILLA GONZALEZ MARIA ELISA. Presidente: VELASCOARROYO ENRIQUE. Datos registrales. T 9904, L 7186, F 17, S 8, H V 18333, I/A 123 (31.08.18).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: ROCA BALLESTER JAVIER. Datos registrales. T 9904, L 7186, F 18, S 8, H V 18333, I/A 124(31.08.18).
Revocaciones. Apo.Sol.: LAGUENS AGUDO EVA MARIA. Nombramientos. Apoderado: GARCIA GARCIA BEATRIZ. Datosregistrales. T 9904, L 7186, F 19, S 8, H V 18333, I/A 125 (31.08.18).
20 de Julio de 2018Ceses/Dimisiones. Secretario: GALLEGO LONGAS ESTIBALIZ. Nombramientos. Secretario: GOMEZ DE BONILLA GONZALEZMARIA ELISA. Datos registrales. T 9904, L 7186, F 17, S 8, H V 18333, I/A 120 (13.07.18).
Revocaciones. Apo.Sol.: GALLEGO LONGAS ESTIBALIZ. Datos registrales. T 9904, L 7186, F 17, S 8, H V 18333, I/A 121(13.07.18).
Nombramientos. Apoderado: GOMEZ DE BONILLA GONZALEZ MARIA ELISA. Datos registrales. T 9904, L 7186, F 17, S 8, H V18333, I/A 122 (13.07.18).
22 de Mayo de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: GERARDUS HENDRIKUS JOHANNES VAN DEN BERG;GANDIA GALBIS JOSE FRANCISCO.Vicepresid.: GERARDUS HENDRIKUS JOHANNES VAN DEN BERG. Nombramientos. Consejero: VICENS ROIGFRANCISCO;MONTON APARICIO MIGUEL ANGEL. Vicepresid.: VICENS ROIG FRANCISCO. Reelecciones. Secretario: GALLEGOLONGAS ESTIBALIZ. Consejero: VELASCO ARROYO ENRIQUE. Presidente: VELASCO ARROYO ENRIQUE. Datos registrales. T9903, L 7185, F 169, S 8, H V 18333, I/A 117 (14.05.18).
Revocaciones. Apo.Sol.: SISCAR SERVER RAMON. Apoderado: SISCAR SERVER RAMON. Datos registrales. T 9903, L 7185, F169, S 8, H V 18333, I/A 118 (14.05.18).
Nombramientos. Apo.Manc.: GERARDUS HENDRIKUS JOHANNES VAN DEN BERG;DEL BOSQUE SAENZ MARTA. Datosregistrales. T 9903, L 7185, F 170, S 8, H V 18333, I/A 119 (14.05.18).
12 de Abril de 2018Nombramientos. Apo.Man.Soli: VELASCO ARROYO ENRIQUE. Datos registrales. T 9903, L 7185, F 168, S 8, H V 18333, I/A 114 (5.04.18).
Revocaciones. Apo.Manc.: MARTINEZ ASO ANGEL;MARTINEZ ASO ANGEL. Apo.Sol.: MARTINEZ ASO ANGEL. Datosregistrales. T 9903, L 7185, F 169, S 8, H V 18333, I/A 115 ( 5.04.18).
Revocaciones. Apo.Sol.: GANDIA GALBIS JOSE FRANCISCO. Apo.Man.Soli: GANDIA GALBIS JOSE FRANCISCO. Datosregistrales. T 9903, L 7185, F 169, S 8, H V 18333, I/A 116 ( 5.04.18).
11 de Abril de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: PADILLA PULIDO PEDRO. Vicepresid.: PADILLA PULIDO PEDRO. Nombramientos. Consejero:GERARDUS HENDRIKUS JOHANNES VAN DEN BERG. Vicepresid.: GERARDUS HENDRIKUS JOHANNES VAN DEN BERG.Reelecciones. Consejero: GANDIA GALBIS JOSE FRANCISCO;BOTTER GERHARD. Presidente: BOTTER GERHARD. Secretario:GALLEGO LONGAS ESTIBALIZ. Datos registrales. T 9903, L 7185, F 165, S 8, H V 18333, I/A 109 ( 4.04.18).
Ceses/Dimisiones. Consejero: BOTTER GERHARD. Presidente: BOTTER GERHARD. Nombramientos. Consejero: VELASCOARROYO ENRIQUE. Presidente: VELASCO ARROYO ENRIQUE. Reelecciones. Secretario: GALLEGO LONGAS ESTIBALIZ.Consejero: GERARDUS HENDRIKUS JOHANNES VAN DEN BERG;GANDIA GALBIS JOSE FRANCISCO. Vicepresid.: GERARDUSHENDRIKUS JOHANNES VAN DEN BERG. Datos registrales. T 9903, L 7185, F 166, S 8, H V 18333, I/A 110 ( 4.04.18).
Revocaciones. Apo.Sol.: PADILLA PULIDO PEDRO. Apo.Manc.: PADILLA PULIDO PEDRO. Datos registrales. T 9903, L 7185, F166, S 8, H V 18333, I/A 111 ( 4.04.18).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GERARDUS HENDRIKUS JOHANNES VAN DEN BERG. Datos registrales. T 9903, L 7185, F 166,S 8, H V 18333, I/A 112 ( 4.04.18).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: BOTTER GERHARD. Datos registrales. T 9903, L 7185, F 167, S 8, H V 18333, I/A 113 ( 4.04.18).
02 de Enero de 2018Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 9903, L 7185, F 165, S 8, H V 18333, I/A 108 (22.12.17).
09 de Octubre de 2017Revocaciones. Apo.Manc.: MONCHO MORA LORENZO. Datos registrales. T 9903, L 7185, F 165, S 8, H V 18333, I/A 107 (2.10.17).
26 de Junio de 2017Revocaciones. Apoderado: VELASCO MORENO JUAN FRANCISCO;SUÑE GUIU JOSE DOMINGO;PEÑA GIMENEZ JOSE MARIA.Apo.Manc.: RIBAS MONTOBBIO MANUEL;SABARIEGO MADRID MIGUEL;PEREZ PLEGUEZUELO PEDRO RAUL;DOMINGOBERNAL RICARDO. Apoderado: MORENES MARIATEGUI IGNACIO;MONTSERRAT ESTEBAN JOSE MARIA;MONSONIS BELLLLOCH FRANCISCO;GONZALEZ URIBESALGO IGNACIO;VELASCO MORENO JUAN FRANCISCO;PEÑA GIMENEZ JOSEMARIA;ALCANTARA NICOLAS JUAN;SCHILT NADAL ANTONI;SUÑE GUIU JOSE DOMINGO;BERNAL PINEDA ROSARIO. Datosregistrales. T 9903, L 7185, F 165, S 8, H V 18333, I/A 105 (19.06.17).
Nombramientos. Apo.Sol.: ARLANDIS GUZMAN VICENTE JOSE;LAGUENS AGUDO EVA MARIA. Datos registrales. T 9903, L7185, F 165, S 8, H V 18333, I/A 106 (19.06.17).
17 de Marzo de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: CAPILLA AZPILICUETA MARIA EULALIA. Presidente: CAPILLA AZPILICUETA MARIA EULALIA.Nombramientos. Consejero: BOTTER GERHARD. Presidente: BOTTER GERHARD. Reelecciones. Secretario: GALLEGOLONGAS ESTIBALIZ. Consejero: PADILLA PULIDO PEDRO. Vicepresid.: PADILLA PULIDO PEDRO. Consejero: GANDIA GALBISJOSE FRANCISCO. Datos registrales. T 9903, L 7185, F 163, S 8, H V 18333, I/A 102 (10.03.17).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: CAPILLA AZPILICUETA MARIA EULALIA. Apo.Manc.: MOLINA PEREIRA LAURA. Datos registrales.T 9903, L 7185, F 163, S 8, H V 18333, I/A 103 (10.03.17).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: BOTTER GERHARD. Datos registrales. T 9903, L 7185, F 163, S 8, H V 18333, I/A 104 (10.03.17).
22 de Diciembre de 2016Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 9903, L 7185, F 162, S 8, H V 18333, I/A 101 (15.12.16).
13 de Enero de 2016Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 9903, L 7185, F 162, S 8, H V 18333, I/A 100 ( 5.01.16).
10 de Noviembre de 2015Revocaciones. Apo.Sol.: RODRIGUEZ CEBALLOS FRANCISCO JAVIER. Apo.Manc.: RODRIGUEZ CEBALLOS FRANCISCOJAVIER. Datos registrales. T 9903, L 7185, F 162, S 8, H V 18333, I/A 99 ( 2.11.15).
30 de Septiembre de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: RODRIGUEZ CEBALLOS FRANCISCO JAVIER. Presidente: RODRIGUEZ CEBALLOS FRANCISCOJAVIER. Nombramientos. Consejero: GANDIA GALBIS JOSE FRANCISCO. Presidente: CAPILLA AZPILICUETA MARIA EULALIA.Reelecciones. Consejero: PADILLA PULIDO PEDRO;CAPILLA AZPILICUETA MARIA EULALIA. Vicepresid.: PADILLA PULIDOPEDRO. Secretario: GALLEGO LONGAS ESTIBALIZ. Datos registrales. T 9903, L 7185, F 182, S 8, H V 18333, I/A 98 (23.09.15).
11 de Mayo de 2015Revocaciones. Apo.Sol.: BELLES MEDALL SANTIAGO. Datos registrales. T 9447, L 6729, F 152, S 8, H V 18333, I/A 95 ( 4.05.15).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GANDIA GALBIS JOSE FRANCISCO. Datos registrales. T 9447, L 6729, F 152, S 8, H V 18333,I/A 96 ( 4.05.15).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: CAPILLA AZPILICUETA MARIA EULALIA. Datos registrales. T 9447, L 6729, F 153, S 8, H V18333, I/A 97 ( 4.05.15).
30 de Marzo de 2015Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ COJO RAUL. Datos registrales. T 9447, L 6729, F 151, S 8, H V 18333, I/A 94(23.03.15).
30 de Diciembre de 2014Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 9447, L 6729, F 151, S 8, H V 18333, I/A 93 (22.12.14).
22 de Octubre de 2014Revocaciones. Apoderado: CAPILLA AZPILICUETA MARIA EULALIA. Datos registrales. T 9447, L 6729, F 151, S 8, H V 18333, I/A92 (15.10.14).
26 de Septiembre de 2014Revocaciones. Apo.Sol.: BELTEJAR CAMPOS JESUS. Datos registrales. T 9447, L 6729, F 151, S 8, H V 18333, I/A 91 (19.09.14).
24 de Julio de 2014Nombramientos. Apo.Sol.: BELLES MEDALL SANTIAGO. Datos registrales. T 9447, L 6729, F 7, S 8, H V 18333, I/A 90 (17.07.14).
17 de Marzo de 2014Fe de erratas: Revocados los poderes de: Juan Pedro Fernández Doctor, Jose Francisco Gandía Gálbiz, Roberto Herreras MartínRoberto, Pedro Luis Lera Muro, Agustín Ramos Diez, Julio José Soler Abad, Agustín Soler Sánchez. Se omitieron en el Boletín 8 defecha 14/01/02 y referencia 00183052002. Datos registrales. T 6270, L 3575, F 29, S 8, H V 18333, I/A 66 (17.09.04).
18 de Diciembre de 2013Nombramientos. Apoderado: SISCAR SERVER RAMON;MONTON APARICIO MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 9447, L 6729,F 4, S 8, H V 18333, I/A 89 (11.12.13).
11 de Diciembre de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTINEZ ASO ANGEL. Nombramientos. Consejero: CAPILLA AZPILICUETA MARIA EULALIA.Reelecciones. Consejero: RODRIGUEZ CEBALLOS FRANCISCO JAVIER. Presidente: RODRIGUEZ CEBALLOS FRANCISCOJAVIER. Consejero: PADILLA PULIDO PEDRO. Vicepresid.: PADILLA PULIDO PEDRO. Secretario: GALLEGO LONGAS ESTIBALIZ.Datos registrales. T 9447, L 6729, F 4, S 8, H V 18333, I/A 87 ( 3.12.13).
Nombramientos. Apoderado: CAPILLA AZPILICUETA MARIA EULALIA. Datos registrales. T 9447, L 6729, F 4, S 8, H V 18333, I/A88 ( 3.12.13).
06 de Noviembre de 2013Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 6270, L 3575, F 33, S 8, H V 18333, I/A 83 (29.10.13).
Ceses/Dimisiones. Consejero: VILA GINER RAUL. Nombramientos. Consejero: MARTINEZ ASO ANGEL. Reelecciones.Consejero: RODRIGUEZ CEBALLOS FRANCISCO JAVIER;PADILLA PULIDO PEDRO. Presidente: RODRIGUEZ CEBALLOSFRANCISCO JAVIER. Vicepresid.: PADILLA PULIDO PEDRO. Secretario: GALLEGO LONGAS ESTIBALIZ. Datos registrales. T6270, L 3575, F 33, S 8, H V 18333, I/A 84 (29.10.13).
Revocaciones. Apo.Sol.: VILA GINER RAUL. Datos registrales. T 6270, L 3575, F 33, S 8, H V 18333, I/A 85 (29.10.13).
Nombramientos. Apo.Sol.: MARTINEZ ASO ANGEL. Datos registrales. T 6270, L 3575, F 33, S 8, H V 18333, I/A 86 (29.10.13).
14 de Febrero de 2013Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 6270, L 3575, F 32, S 8, H V 18333, I/A 82 ( 7.02.13).
01 de Marzo de 2012Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 6270, L 3575, F 32, S 8, H V 18333, I/A 81 (21.02.12).
01 de Marzo de 2011Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 6270, L 3575, F 32, S 8, H V 18333, I/A 80 (18.02.11).
14 de Diciembre de 2010Nombramientos. Apoderado: AGUILAR BIOT ESTEFANIA. Datos registrales. T 6270, L 3575, F 32, S 8, H V 18333, I/A 79 (1.12.10).
31 de Diciembre de 2009Reelecciones. Consejero: RODRIGUEZ CEBALLOS FRANCISCO JAVIER;PADILLA PULIDO PEDRO;VILA GINER RAUL.Presidente: RODRIGUEZ CEBALLOS FRANCISCO JAVIER. Vicepresid.: PADILLA PULIDO PEDRO. Datos registrales. T 6270, L3575, F 31, S 8, H V 18333, I/A 77 (21.12.09).
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 6270, L 3575, F 32, S 8, H V 18333, I/A 78 (21.12.09).
20 de Noviembre de 2009Nombramientos. Apo.Manc.: MARTINEZ ASO ANGEL;FERNANDEZ DOCTOR JUAN PEDRO;DEL BOSQUE SAENZMARTA;MOLINA PEREIRA LAURA. Datos registrales. T 6270, L 3575, F 31, S 8, H V 18333, I/A 76 (11.11.09).
12 de Febrero de 2009Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 6270, L 3575, F 31, S 8, H V 18333, I/A 75 ( 3.02.09).