Actos BORME de Saelices El Chico Solar Sl
22 de Abril de 2022Revocaciones. Apoderado: DIAZ ALMAZAN DAVID ANTONIO. Nombramientos. Apoderado: PENTREATH NICHOLAS;MARTINEZNAVARRO MARIA ARANZAZU;DE LA SERNA GOULD LUIS JAIME;TIELVE MARTINEZ DE GUEREÑU BEATRIZ;LACACI NUEVOFERNANDO;MOLINARI MIRKO PIETRO EMILIO;MOLINA DEL VALLE ELENA;RIBALLO FERNANDEZ ANTONIO ENRIQUE;MOYATRIGUERO FRANCISCO. Datos registrales. T 38198 , F 154, S 8, H M 449034, I/A 22 (13.04.22).
16 de Marzo de 2022Revocaciones. Apoderado: MONFORT CELDRAN JOAQUIN;ROZALEN RODRIGUEZ LAURA. Datos registrales. T 38198 , F 153,S 8, H M 449034, I/A 21 ( 9.03.22).
29 de Abril de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: DOMINGUEZ BAYON LORETO. Datos registrales. T 38198 , F 150, S 8, H M 449034, I/A 19 (22.04.21).
Nombramientos. Apo.Sol.: MARTINEZ NAVARRO MARIA ARANZAZU. Datos registrales. T 38198 , F 152, S 8, H M 449034, I/A 20(22.04.21).
05 de Octubre de 2020Nombramientos. Apoderado: DIAZ ALMAZAN DAVID ANTONIO;MICO VALDENEBRO FERNANDO;DE LA SERNA GOULD LUISJAIME;PARADISO BENIAMINO;TIELVE MARTINEZ DE GUEREÑU BEATRIZ;LACACI NUEVO FERNANDO;RIBALLO FERNANDEZANTONIO ENRIQUE;MARTINEZ NAVARRO MARIA ARANZAZU;ROZALEN RODRIGUEZ LAURA. Datos registrales. T 38198 , F148, S 8, H M 449034, I/A 16 (28.09.20).
Revocaciones. Apoderado: PARADISO BENIAMINO;PARADISO BENIAMINO. Datos registrales. T 38198 , F 150, S 8, H M449034, I/A 17 (28.09.20).
Revocaciones. Apoderado: MICO VALDENEBRO FERNANDO. Datos registrales. T 38198 , F 150, S 8, H M 449034, I/A 18(28.09.20).
30 de Abril de 2020Ceses/Dimisiones. Representan: BARREDO LOPEZ JORGE. Nombramientos. Representan: NOGUERA PUJOL-XICOY LLUIS.Datos registrales. T 38198 , F 148, S 8, H M 449034, I/A 15 (23.04.20).
28 de Abril de 2020Cambio de domicilio social. C/ POETA JOAN MARAGALL 1 5ª (MADRID). Datos registrales. T 38198 , F 147, S 8, H M 449034,I/A 14 (21.04.20).
03 de Junio de 2019Nombramientos. Apoderado: DE LA SERNA GOULD LUIS-JAIME;PARADISO BENIAMINO;RIBALLO FERNANDEZ ANTONIOENRIQUE;MARTINEZ NAVARRO MARIA ARANZAZU;PARDO AYUSO JOSE ENRIQUE. Datos registrales. T 38198 , F 146, S 8, HM 449034, I/A 13 (27.05.19).
05 de Noviembre de 2018Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: X-ELIO ENERGY SL. Datos registrales. T 24937 , F 152, S 8, H M449034, I/A 12 (26.10.18).
08 de Mayo de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: RIBERAS MERA JUAN MARIA;RIBERAS MERA FRANCISCO JOSE. Cons.Del.Sol: RIBERAS MERAJUAN MARIA;RIBERAS MERA FRANCISCO JOSE. Presidente: RIBERAS MERA JUAN MARIA. Secretario: RIBERAS MERAFRANCISCO JOSE. Consejero: BARREDO LOPEZ JORGE. Revocaciones. Apoderado: BARREDO LOPEZ JORGE;BARREDOLOPEZ JORGE. Nombramientos. Adm. Unico: X-ELIO ENERGY SL. Representan: BARREDO LOPEZ JORGE. Otros conceptos:Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único. Datos registrales. T 24937 , F 152, S 8, HM 449034, I/A 11 (27.04.17).
23 de Mayo de 2011Cambio de domicilio social. C/ OMBU NUMERO 3, PLANTA 2& (MADRID). Datos registrales. T 24937 , F 152, S 8, H M 449034,I/A 10 (12.05.11).
07 de Enero de 2010Modificaciones estatutarias. Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/12. Datos registrales. T 24937 , F 152, S 8, H M 449034, I/A 9(23.12.09).
16 de Septiembre de 2009Nombramientos. Apoderado: BARREDO LOPEZ JORGE. Datos registrales. T 24937 , F 151, S 8, H M 449034, I/A 8 (27.08.09).
04 de Mayo de 2009Cambio de objeto social. EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE ENERGIAS RENOVABLES, PRINCIPALMENTE DE ENERGIASOLAR FOTOVOLTAICA, EN CUALQUIERA DE SUS FASES... Datos registrales. T 24937 , F 150, S 8, H M 449034, I/A 7(21.04.09).
02 de Abril de 2009Nombramientos. Apoderado: BARREDO LOPEZ JORGE. Datos registrales. T 24937 , F 149, S 8, H M 449034, I/A 6 (23.03.09).