Actos BORME de Saeta Yield Sa
20 de Enero de 2023Revocaciones. Apo.Sol.: GARCIA IGLESIAS EDUARDO. Nombramientos. Apo.Sol.: RUBIO GARCIA FRANCISCO JAVIER.Datos registrales. T 37743 , F 115, S 8, H M 483710, I/A 54 (13.01.23).
26 de Octubre de 2022Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 37743 , F 114, S 8, H M 483710, I/A 52 (19.10.22).
05 de Mayo de 2022Revocaciones. Apo.Sol.: RUS OZAEZ ANTONIO;LOPEZ ROMAN CARMEN MARINA;GARCIA IGLESIAS EDUARDO;SALVADORDE SANCHO RAUL;FERNANDEZ PEREZ LUIS ALBERTO;DEL VALLE CALVO MARIA DOLORES;GONZALEZ HIERROFRANCISCO;PEREZ DE LEMA DE LA MATA ALVARO;REBOLLO RICO IGNACIO. Nombramientos. Apo.Sol.: RUS OZAEZANTONIO;PLAZAS REQUENA JAVIER;GARCIA IGLESIAS EDUARDO;SALVADOR DE SANCHO RAUL;SIERRA ALBERTJORGE;LASHERAS PRIETO MIGUEL;LOPEZ ROMAN CARMEN MARINA;BARDAJI GARCIA LUIS;PEREZ DE LEMA DE LA MATAALVARO. Datos registrales. T 37743 , F 113, S 8, H M 483710, I/A 51 (27.04.22).
01 de Abril de 2022Ceses/Dimisiones. Consejero: TESKEY CONNOR DAVID. Nombramientos. Consejero: PAZ ARES ALDANONDO IGNACIO.Datos registrales. T 37743 , F 112, S 8, H M 483710, I/A 50 (25.03.22).
25 de Marzo de 2022Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 37743 , F 112, S 8, H M 483710, I/A 48 (18.03.22).
Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 37743 , F 112, S 8, H M 483710, I/A 49 (18.03.22).
08 de Julio de 2019Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: NU脩EZ-LAGOS DE MIGUEL RAFAEL. VsecrNoConsj: CARBONELL GARCIA JOSE FELIPE.Nombramientos. SecreNoConsj: BARDAJI GARCIA LUIS. Datos registrales. T 37743 , F 111, S 8, H M 483710, I/A 47 ( 2.07.19).
22 de Marzo de 2019Otros conceptos: Novar el poder aprobado por el Consejo de Administraci贸n con fecha 25 de septiembre de 2018, que caus贸 lainscripci贸n 44陋, en cuanto a modificar su apartado F(a) y su apartado H(e), con expresa derogaci贸n de su redacci贸n anterior. Datosregistrales. T 37743 , F 111, S 8, H M 483710, I/A 46 (15.03.19).
18 de Enero de 2019Ceses/Dimisiones. Cons.Ejecuti: MARTINEZ DALMAU JOSE LUIS. Con.Delegado: MARTINEZ DALMAU JOSE LUIS. Datosregistrales. T 37743 , F 111, S 8, H M 483710, I/A 45 (11.01.19).
10 de Diciembre de 2018Nombramientos. Vicepresid.: O'BRIEN THOMAS JOSEPH. Datos registrales. T 37743 , F 108, S 8, H M 483710, I/A 42 (30.11.18).
Nombramientos. Apo.Sol.: REBOLLO RICO IGNACIO. Otros conceptos: Novada la escritura de poder con numero de protocolo1618, que caus贸 la inscripci贸n 40陋, al incluir como nuevo Apoderado del grupo A a Don Ignacio Rebollo Rico, modificando ademas ellimite cuantitativo respecto a las facultades a ejercitar por el apoderado del Grupo C. Datos registrales. T 37743 , F 108, S 8, H M483710, I/A 43 (30.11.18).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: PEREZ DE LEMA DE LA MATA ALVARO. Apo.Manc.: RUS OZAEZ ANTONIO;GONZALEZ HIERROFRANCISCO;BARDAJI GARCIA LUIS. Datos registrales. T 37743 , F 110, S 8, H M 483710, I/A 44 (30.11.18).
16 de Noviembre de 2018Modificaciones estatutarias. MODIFICADO EL ARTICULO 5 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.. Otros conceptos: APROBACIONDE LA MODIFICACION DEL SISTEMA DE REPRESENTACION DE LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD. Datos registrales. T 37743, F 107, S 8, H M 483710, I/A 41 ( 8.11.18).
04 de Octubre de 2018Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: TERP SPANISH HOLDCO SOCIEDAD LIMITADA. Ceses/Dimisiones. Presidente:MARTINEZ DALMAU JOSE LUIS. Con.Ind.: BARREIRO HERNANDEZ JOSE;JEFFERY PAUL;MORE DANIEL BOYD. SecreNoConsj:PEREZ DE AYALA BECERRIL LUIS PEDRO. Nombramientos. Presidente: ZAMARRIEGO FERNANDEZ ALFREDO. SecreNoConsj:NU脩EZ-LAGOS DE MIGUEL RAFAEL. VsecrNoConsj: CARBONELL GARCIA JOSE FELIPE. Datos registrales. T 37743 , F 102, S8, H M 483710, I/A 36 (26.09.18).
Modificaciones estatutarias. HA QUEDADO REFUNDIDO EL TEXTO INTEGRO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES Y HAQUEDADO DEROGADO Y SIN EFECTO PARA LO SUCESIVO EL REGLAMENTO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DELA SOCIEDAD.- . Datos registrales. T 37743 , F 103, S 8, H M 483710, I/A 37 (26.09.18).
P谩gina web de la sociedad. Supresi贸n de la p谩gina web corporativa: www.saetayield.com. Datos registrales. T 37743 , F 105, S 8,H M 483710, I/A 38 (26.09.18).
Otros conceptos: HA QUEDADO RATIFICADO EL NOMBRAMIENTO POR COOPTACION DE LOS CONSEJEROS D. THOMASJOSEPH O BRIEN, D. CONNOR DAVID TESKEY, D陋 EMMANUELLE MARYSE ROUCHEL Y D. ALFREDO ZAMARRIEGOFERNANDEZ, POR ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL DE FECHA 2 DE AGOSTO DE 2018.- HA QUEDADO RATIFICADOASIMISMO EL NOMBRAMIENTO COMO PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE DON ALFREDO ZAMARRIEGOFERNANDEZ, POR ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL DE FECHA 2 DE AGOSTO DE 2018.- Datos registrales. T 37743 , F 105,S 8, H M 483710, I/A 39 (26.09.18).
Nombramientos. Apo.Sol.: RUS OZAEZ ANTONIO;LOPEZ ROMAN CARMEN MARINA;GARCIA IGLESIAS EDUARDO;SALVADORDE SANCHO RAUL;FERNANDEZ PEREZ LUIS ALBERTO;DEL VALLE CALVO MARIA DOLORES;GONZALEZ HIERROFRANCISCO;PEREZ DE LEMA DE LA MATA ALVARO. Datos registrales. T 37743 , F 106, S 8, H M 483710, I/A 40 (26.09.18).
03 de Octubre de 2018Ceses/Dimisiones. Con.Ind.: LOPEZ ISLA HONORATO. Consj.Domini: AGRAWAL DEEPAK;KERRENNEUR ANTOINE;ALDAMIZ-ECHEVARRIA GONZALEZ DE DURANA CRISTINA;GONZALEZ WIEDMAIER CRISTOBAL. Nombramientos. Consejero: O'BRIENTHOMAS JOSEPH;TESKEY CONNOR DAVID;ZAMARRIEGO FERNANDEZ ALFREDO;ROUCHEL EMMANUELLE MARYSE. Datosregistrales. T 30291 , F 222, S 8, H M 483710, I/A 35 (26.09.18).
20 de Agosto de 2018Otros conceptos: Exclusi贸n de la negociaci贸n en la Bolsa de Valores de Bilbao, con efectos del 4 de julio de 2018, las 81.576.928acciones ordinarias de 1 euro de valor nominal cada una de ellas representativas del capital social. Datos registrales. T 30291 , F222, S 8, H M 483710, I/A 34 ( 9.08.18).
17 de Agosto de 2018Otros conceptos: EXCLUSION DE LA NEGOCIACION EN LA BOLSA DE VALORES DE MADRID, CON EFECTOS DEL 4 DE JULIODE 2018, LAS 81.576.928 ACCIONES ORDINARIAS DE 1 EURO DE VALOR NOMINAL CADA UNA DE ELLAS, REPRESENTATIVASDEL CAPITAL SOCIAL. Datos registrales. T 30291 , F 222, S 8, H M 483710, I/A 32 ( 9.08.18).
Otros conceptos: EXCLUSION DE LA NEGOCIACION EN LA BOLSA DE VALORES DE BARCELONA, CON EFECTOS DEL 4 DEJULIO DE 2018, LAS 81.576.928 ACCIONES ORDINARIAS DE 1 EURO DE VALOR NOMINAL CADA UNA DE ELLAS,REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL. Datos registrales. T 30291 , F 222, S 8, H M 483710, I/A 33 ( 9.08.18).
03 de Octubre de 2017Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Otros conceptos: Se ratifica el nombramiento por cooptaci贸n deD. Antoine Kerrenneur como consejero dominical. Datos registrales. T 30291 , F 221, S 8, H M 483710, I/A 30 (22.09.17).
29 de Septiembre de 2017Fe de erratas: SE PUBLICO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 29陋 EL NOMBRMAIENTO DE KERRENNEUER ANTOINE COMOCONSEJERO, SIENDO LO CORRECTO CONSEJERO DOMINICAL. Datos registrales. T 30291 , F 221, S 8, H M 483710, I/A 29(22.11.16).
02 de Diciembre de 2016Ceses/Dimisiones. Consj.Domini: RAO RAJ. Nombramientos. Consejero: KERRENNEUR ANTOINE. Datos registrales. T 30291 ,F 221, S 8, H M 483710, I/A 29 (22.11.16).
03 de Octubre de 2016Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ HIERRO FRANCISCO;PEREZ DE LEMA DE LA MATA ALVARO;DEL VALLE CALVOMARIA DOLORES. Datos registrales. T 30291 , F 220, S 8, H M 483710, I/A 28 (22.09.16).
05 de Octubre de 2015Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: MI脩ARRO BRUGAROLAS CATALINA. Nombramientos. SecreNoConsj: PEREZ DE AYALABECERRIL LUIS PEDRO. Datos registrales. T 30291 , F 219, S 8, H M 483710, I/A 27 (28.09.15).
10 de Agosto de 2015Otros conceptos: RATIFICACION DEL NOMBRAMIENTO DE DON DEEPAK AGRAWAL Y DON RAJ RAO COMO CONSEJEROSDOMINICALES POR LA JUNTA GENERAL DE 25 DE JUNIO DE 2015. Datos registrales. T 30291 , F 219, S 8, H M 483710, I/A 26 (3.08.15).
16 de Julio de 2015Ceses/Dimisiones. Consj.Domini: LOZANO PUEYO EPIFANIO;AGUIRRE DIAZ GUARDAMINO ALFONSO. Nombramientos.Consj.Domini: AGRAWAL DEEPAK;RAO RAJ. Otros conceptos: MODIFICACION DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO DEADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD TENIENDO EN CUENTA EL NUEVO CODIGO DE BUEN GOBIERNO DE LAS SOCIEDADESCOTIZADAS, APROBADO POR ACUERDO DEL CONSEJO DE LA COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES DE 18 DEFEBRERO DE 2015. Datos registrales. T 30291 , F 212, S 8, H M 483710, I/A 24 ( 7.07.15).
Otros conceptos: Modificaci贸n del art铆culo 18.3 del Reglamento del consejo de administraci贸n teniendo en cuenta el nuevo c贸digo debuen gobierno de las sociedades cotizadas aprobado por acuerdo del Consejo de la Comisi贸n Nacional del Mercado de Valores de 18de febrero de 2015. Datos registrales. T 30291 , F 219, S 8, H M 483710, I/A 25 ( 7.07.15).
19 de Mayo de 2015Otros conceptos: Practicado el dep贸sito de Pactos Parasociales de la sociedad SAETA YIELD SA.. Se expone que en fecha 23 deabril de 2015 , la entidad "GIP II HELIOS S. A R.L." sociedad de nacionalidad luxemburguesa ha ejecutado la compraventa de accionesrepresentativas de un 24,01 por ciento del capital social de. Datos registrales. T 26842 , F 14, S 8, H M 483710, I/A 1-M ( 7.05.15).
Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 3. Cambio de domicilio social. AVDA DE BURGOS 16 D (MADRID). Datosregistrales. T 30291 , F 212, S 8, H M 483710, I/A 23 ( 8.05.15).
07 de Abril de 2015Otros conceptos: ADMISION A NEGOCIACION EN LA BOLSA DE VALORES DE MADRID , CON EFECTOS A PARTIR DEL DIA 16DE FEBRERO DE 2015, INCLUSIVE, 81.576.928 ACCIONES DE 1 EURO DE VALOR NOMINAL CADA UNA ELLAS, CODIGO ISINES0105058004, REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL ACTUAL EN CIRCULACION. Datos registrales. T 30291 , F 211, S 8, H M
Otros conceptos: ADMISION A NEGOCIACION EN LA BOLSA DE VALORES DE BARCELONA , CON EFECTOS A PARTIR DELDIA 16 DE FEBRERO DE 2015, INCLUSIVE, 81.576.928 ES0105058004, REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL ACTUAL ENCIRCULACION. Datos registrales. T 30291 , F 211, S 8, H M 483710, I/A 20 (24.03.15).
Otros conceptos: ADMISION A NEGOCIACION EN LA BOLSA DE VALORES DE BILBAO , CON EFECTOS A PARTIR DEL DIA 16DE FEBRERO DE 2015, INCLUSIVE, 81.576.928 ACCIONES DE 1 EURO DE VALOR NOMINAL CADA UNA ELLAS, CODIGO ISINES0105058004, REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL ACTUAL EN CIRCULACION. Datos registrales. T 30291 , F 211, S 8, H M483710, I/A 21 (24.03.15).
Otros conceptos: ADMISION A NEGOCIACION EN LA BOLSA DE VALORES DE VALENCIA, CON EFECTOS A PARTIR DEL DIA16 DE FEBRERO DE 2015, INCLUSIVE, 81.576.928 ACCIONES DE 1 EURO DE VALOR NOMINAL CADA UNA ELLAS, CODIGOISIN ES0105058004, REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL ACTUAL EN CIRCULACION. Datos registrales. T 30291 , F 211, S 8, H M483710, I/A 22 (24.03.15).
06 de Marzo de 2015Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 30291 , F 211, S 8, H M 483710, I/A 18(25.02.15).
20 de Febrero de 2015Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 20.013.918,00 Euros. Desembolsado: 20.013.918,00 Euros. Resultante Suscrito: 81.576.928,00Euros. Resultante Desembolsado: 81.576.928,00 Euros. Datos registrales. T 30291 , F 210, S 8, H M 483710, I/A 17 (13.02.15).
18 de Febrero de 2015Ceses/Dimisiones. Secretario: AGUIRRE DIAZ GUARDAMINO ALFONSO. Nombramientos. Con.Ind.: BARREIRO HERNANDEZJOSE;LOPEZ ISLA HONORATO;JEFFERY PAUL;MORE DANIEL BOYD. SecreNoConsj: MI脩ARRO BRUGAROLAS CATALINA.Con.Delegado: MARTINEZ DALMAU JOSE LUIS. PresEjecutiv: MARTINEZ DALMAU JOSE LUIS. Consej.Coord: LOPEZ ISLAHONORATO. Otros conceptos: Aprobaci贸n del Reglamento del consejo de administraci贸n que entrar谩 en vigor en el momento enque las acciones de la sociedad sean admitidas a negociaci贸n de las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia yquedar谩 sin efecto si antes del 31 de marzo de 2015 no se hubiera obtenido Se deja constancia de que los consejeros Don Crist贸balGonz谩lez Wiedmaier, Do帽a Cristina Ald谩miz-Echevarr铆a Gonz谩lez de Durana, Don Epifanio Lozano pueyo y Don Alfonso Aguirre D铆az-Guardamino nombrados el d铆a 20 de enero de 2015, tienen la calificaci贸n de consejeros dominicales. Datos registrales. T 30291 , F204, S 8, H M 483710, I/A 16 (11.02.15).
02 de Febrero de 2015Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: URBAENERGIA SL. Representan: MARTINEZ DALMAU JOSE LUIS. Nombramientos. Consejero:MARTINEZ DALMAU JOSE LUIS. Presidente: MARTINEZ DALMAU JOSE LUIS. Consejero: GONZALEZ WIEDMAIERCRISTOBAL;ALDAMIZ-ECHEVARRIA GONZALEZ DE DURANA CRISTINA;LOZANO PUEYO EPIFANIO;AGUIRRE DIAZGUARDAMINO ALFONSO. Secretario: AGUIRRE DIAZ GUARDAMINO ALFONSO. Ent.Reg.Cont: SOCIEDAD DE GESTION DE LOSSISTEMAS DE REGISTRO CO. Modificaciones estatutarias. Modificaci贸n de los estatutos sociales mediante la aprobaci贸n de unnuevo texto para adaptarlos a las exigencias de las sociedades cotizadas, en el que se modifica, entre otros extremos, la duraci贸n delcargo de administrador. . Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Consejo de administraci贸n.Aprobaci贸n del Reglamento de la Junta, que entrar谩 en vigor e el momento en que las acciones de la sociedad sean admitidas anegociaci贸n de las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia y quedar谩 sin efecto alguno autom谩ticamente si antesdel 31 de marzo de 2015 no se hubiera. P谩gina web de la sociedad. Creaci贸n de la p谩gina web corporativa: www.saetayield.com.Datos registrales. T 26842 , F 165, S 8, H M 483710, I/A 15 (26.01.15).
16 de Enero de 2015Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 51.500.000,00 Euros. Desembolsado: 51.500.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 61.563.010,00Euros. Resultante Desembolsado: 61.563.010,00 Euros. Datos registrales. T 26842 , F 164, S 8, H M 483710, I/A 14 ( 9.01.15).