Actos BORME de Sai Integracion Social Sl
23 de Octubre de 2018Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 184, S 8, H PO 58710, I/A 30 (16.10.18).
24 de Julio de 2018Nombramientos. Apoderado: LOPESINO SOUSA AGUSTIN MODESTO. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 184, S 8, H PO58710, I/A 29 (17.07.18).
02 de Julio de 2018Nombramientos. Apoderado: CUETO FAUS JOSE LUIS. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 184, S 8, H PO 58710, I/A 28(26.06.18).
12 de Junio de 2018Revocaciones. Apo.Sol.: RODRIGUEZ MARTINEZ ISABEL. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 183, S 8, H PO 58710, I/A 27 (6.06.18).
12 de Marzo de 2018Revocaciones. Apoderado: GALLOFRE PASCUAL ROMAN. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 183, S 8, H PO 58710, I/A 26 (2.03.18).
19 de Febrero de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: ROMERO VAN DER SCHOOT MANUEL. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 182, S 8, H PO 58710,I/A 23 (12.02.18).
Nombramientos. Apo.Sol.: ORTS SAN JOSE ALFREDO. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 183, S 8, H PO 58710, I/A 24(12.02.18).
Nombramientos. Apo.Sol.: GUTIERREZ HERREROS ARANTZAZU. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 183, S 8, H PO 58710, I/A25 (12.02.18).
16 de Febrero de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: SOLER VICENS ANTONI. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 182, S 8, H PO 58710, I/A 22 ( 9.02.18).
15 de Febrero de 2018Nombramientos. Apoderado: CARRASCO SAGREDO FRANCISCA. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 181, S 8, H PO 58710, I/A21 ( 7.02.18).
04 de Septiembre de 2017Nombramientos. Apoderado: SOLER VICENS ANTONI. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 181, S 8, H PO 58710, I/A 20(25.08.17).
30 de Agosto de 2017Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ MIGUELEZ PEDRO. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 180, S 8, H PO 58710, I/A 19(21.08.17).
24 de Agosto de 2017Nombramientos. Apoderado: ABASCAL CASTA脩ON ALVARO MARIA. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 178, S 8, H PO 58710,I/A 18 (17.08.17).
22 de Agosto de 2017Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: GERIAVI SA. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 177, S 8, H PO58710, I/A 17 (11.08.17).
28 de Julio de 2017Nombramientos. Apoderado: ESPIN FORJAN ANA. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 177, S 8, H PO 58710, I/A 14 (20.07.17).
Nombramientos. Apo.Sol.: DURAN MARI脩O MARIA;DEL CAMPO REDONDO LUCIA;MELON CASTRO MARIA JOSE. Datosregistrales. T 4204, L 4204, F 177, S 8, H PO 58710, I/A 15 (24.07.17).
Nombramientos. Apo.Sol.: PALENZUELA FERNANDEZ JAVIER;PITEL MENDEZ MARIA EUGENIA;RODRIGUEZ MARTINEZISABEL;PRIEGO DEL RIO SANDRA. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 177, S 8, H PO 58710, I/A 16 (24.07.17).
26 de Julio de 2017Nombramientos. Apoderado: JIMENEZ CALAVIA JAVIER. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 176, S 8, H PO 58710, I/A 13(19.07.17).
25 de Julio de 2017Nombramientos. Apoderado: SOLER VICENS ANTONI. Datos registrales. T 4051, L 4051, F 198, S 8, H PO 58710, I/A 12(18.07.17).
26 de Junio de 2017Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ GARCIA ANTONIO. Datos registrales. T 4051, L 4051, F 198, S 8, H PO 58710, I/A 10(16.06.17).
Nombramientos. Apoderado: FERRA GUILLEN MARIO-JOSE. Datos registrales. T 4051, L 4051, F 198, S 8, H PO 58710, I/A 11(19.06.17).
23 de Junio de 2017Nombramientos. Apoderado: GALLOFRE PASCUAL ROMAN. Datos registrales. T 4051, L 4051, F 197, S 8, H PO 58710, I/A 9(15.06.17).
22 de Junio de 2017Nombramientos. Apoderado: LOPESINO SOUSA AGUSTIN. Datos registrales. T 4051, L 4051, F 197, S 8, H PO 58710, I/A 8(14.06.17).
21 de Junio de 2017Nombramientos. Apoderado: ROSELLO RIERA JOSE-LUIS. Datos registrales. T 4051, L 4051, F 158, S 8, H PO 58710, I/A 7(14.06.17).
20 de Junio de 2017Nombramientos. Apoderado: HUGUET LLULL ANDREU. Datos registrales. T 4051, L 4051, F 155, S 8, H PO 58710, I/A 6(12.06.17).
26 de Octubre de 2015Revocaciones. Apo.Sol.: TARONCHER REDONDO DAVID. Datos registrales. T 4051, L 4051, F 155, S 8, H PO 58710, I/A 5(14.10.15).
24 de Septiembre de 2015Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: TARONCHER REDONDO DAVID;FERNANDEZ MIGUELEZ JOSEFINA. Nombramientos.Adm. Unico: FERNANDEZ MIGUELEZ JOSEFA ISABEL. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n:Administradores mancomunados a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 4051, L 4051, F 155, S 8, H PO 58710, I/A 4 (16.09.15).
24 de Julio de 2015Revocaciones. Apoderado: TARONCHER REDONDO DAVID. Nombramientos. Apo.Sol.: TARONCHER REDONDODAVID;FERNANDEZ MIGUELEZ JOSEFINA;PENAS GARCIA MARIA JESUS. Datos registrales. T 4051, L 4051, F 154, S 8, H PO58710, I/A 3 (15.07.15).
13 de Julio de 2015Cambio de domicilio social. AVDA GARCIA BARBON 60 (VIGO). Datos registrales. T 4051, L 4051, F 150, S 8, H PO 58710, I/A 1( 3.07.15).
Otros conceptos: MODIFICADO el art铆culo 4 de los estatutos sociales correspondiente al DOMICILIO SOCIAL y MODIFICADO elart铆culo 19 de los estatutos sociales para establecer el car谩cter GRATUITO de la administraci贸n. Datos registrales. T 4051, L 4051, F153, S 8, H PO 58710, I/A 2 ( 3.07.15).
08 de Junio de 2015Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: INVERSIONES SOCICARE SL. Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: ELVIRA VALLEJOGUILLERMO;MONREAL MORENO ANTONIO. Nombramientos. Adm. Mancom.: FERNANDEZ MIGUELEZ JOSEFAISABEL;TARONCHER REDONDO DAVID. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores solidarios aAdministradores mancomunados. Datos registrales. T 6772, L 4076, F 93, S 8, H V 74925, I/A 8 (29.05.15).
15 de Marzo de 2011Revocaciones. Apoderado: TARONCHER REDONDO DAVID. Datos registrales. T 6772, L 4076, F 92, S 8, H V 74925, I/A 5 (3.03.11).
Nombramientos. Apoderado: TARONCHER REDONDO DAVID. Datos registrales. T 6772, L 4076, F 92, S 8, H V 74925, I/A 6 (3.03.11).
Modificaciones estatutarias. ARTICULO 19潞.-. Datos registrales. T 6772, L 4076, F 93, S 8, H V 74925, I/A 7 ( 4.03.11).