Actos BORME de Saint Gobain Idaplac Sl
21 de Diciembre de 2023Nombramientos. Apoderado: RUIZ SANGIL MARIA. Datos registrales. T 36835 , F 170, S 8, H M 659380, I/A 54 (14.12.23).
13 de Noviembre de 2023Revocaciones. Apoderado: MORAL PEREZ ANTONIO. Datos registrales. T 36835 , F 170, S 8, H M 659380, I/A 53 ( 5.11.23).
17 de Octubre de 2023Otros conceptos: Subsanado error padecido en el segundo apellido de la apoderado do帽a CRISTINA MARIN, siendo el correcto elde "EGIDO". Datos registrales. T 36835 , F 170, S 8, H M 659380, I/A 52 ( 6.10.23).
03 de Agosto de 2023Nombramientos. Apoderado: MARIN EJIDO CRISTINA. Datos registrales. T 36835 , F 169, S 8, H M 659380, I/A 51 (26.07.23).
30 de Mayo de 2023Nombramientos. Apoderado: PIRES DUARTE DA SILVA PEDRO MIGUEL. Datos registrales. T 36835 , F 167, S 8, H M 659380,I/A 49 (23.05.23).
21 de Diciembre de 2022Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 36835 , F 167, S 8, H M 659380, I/A 48 (14.12.22).
24 de Noviembre de 2022Revocaciones. Apoderado: TRAPERO MILLAN DANIEL. Datos registrales. T 36835 , F 167, S 8, H M 659380, I/A 47 (17.11.22).
17 de Noviembre de 2022Revocaciones. Apoderado: GALLARDO CODORRO VICTORIANO. Fe de erratas: Se omiti贸 por error en la Inscripci贸n 36陋 larevocaci贸n como apoderado de GALLARDO CODORRO VICTORIANO. Datos registrales. T 36835 , F 157, S 8, H M 659380, I/A 36 (6.08.21).
16 de Junio de 2022Revocaciones. Apoderado: BARRIO DELGADO ALVARO. Apo.Man.Soli: CID GARCIA NIEVES. Nombramientos. Apoderado:BLASCO TITO VICENS. Datos registrales. T 36835 , F 165, S 8, H M 659380, I/A 46 ( 9.06.22).
18 de Mayo de 2022Revocaciones. Apoderado: GIMENEZ JIMENEZ FRANCESC. Apo.Sol.: GIMENEZ JIMENEZ FRANCESC;GARCIA FERNANDEZMONICA. Apo.Man.Soli: GARCIA FERNANDEZ MONICA. Datos registrales. T 36835 , F 163, S 8, H M 659380, I/A 44 (10.05.22).
Revocaciones. Apo.Sol.: RAMASCO LUCA. Apo.Manc.: RAMASCO LUCA. Nombramientos. Apo.Man.Soli: FERNANDEZCRISTOBAL JAVIER. Datos registrales. T 36835 , F 163, S 8, H M 659380, I/A 45 (10.05.22).
24 de Marzo de 2022Nombramientos. Apoderado: MIGUEL GARCIA SONIA. Datos registrales. T 36835 , F 163, S 8, H M 659380, I/A 43 (17.03.22).
13 de Enero de 2022Revocaciones. Apoderado: TOMAS GUMFAU MARIA ANGELS;TOMAS GUMFAU MARIA ANGELS;ADRIAN TAUSCHKEROBERTO. Datos registrales. T 36835 , F 162, S 8, H M 659380, I/A 42 ( 5.01.22).
12 de Enero de 2022Nombramientos. Apo.Man.Soli: NEGRE CLIMENT ALBERT. Datos registrales. T 36835 , F 159, S 8, H M 659380, I/A 40 ( 4.01.22).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: MESONES RIUDOR JORDI. Datos registrales. T 36835 , F 161, S 8, H M 659380, I/A 41 ( 4.01.22).
01 de Diciembre de 2021Revocaciones. Apoderado: HURTADO MARJALIZO FRANCISCO MANUEL. Nombramientos. Apo.Sol.: RAMASCO LUCA.Apo.Manc.: RAMASCO LUCA. Datos registrales. T 36835 , F 158, S 8, H M 659380, I/A 39 (24.11.21).
02 de Noviembre de 2021Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 36835 , F 158, S 8, H M 659380, I/A 38 (25.10.21).
13 de Agosto de 2021Revocaciones. Apoderado: GARCIA GOMEZ BEGO脩A;CADILLAC BEDOYA GONZALO;GARCIA GOMEZ BEGO脩A;CORREIATAVARES ANTONIO RICARDO;VILA DE PEDRO JORDI;MARCOS SANCHEZ VICENTE;GARCIA ORTEGA MARIA;VICENTGIMENEZ RAFAEL JOAQUIN;JIMENEZ MENA JORGE;CANO RAYO FRANCISCO JAVIER. Apo.Sol.: GONZALEZ OROBON NURIA.Otros conceptos: Revocado el poder conferido a don Antonio Granados Segura en la escritura de 5 de febrero de 2003, n煤mero 397de protocolo, que motiv贸 la inscripc贸n 8陋 en el Registro Mercantil de Barcelona. Datos registrales. T 36835 , F 157, S 8, H M 659380,I/A 36 ( 6.08.21).
Nombramientos. Apoderado: DIAZ ALVAREZ SERGIO. Datos registrales. T 36835 , F 157, S 8, H M 659380, I/A 37 ( 6.08.21).
14 de Julio de 2021Cambio de domicilio social. C/ PRINCIPE DE VERGARA 132 (MADRID). Datos registrales. T 36835 , F 156, S 8, H M 659380, I/A35 ( 7.07.21).
07 de Julio de 2021Nombramientos. Apo.Man.Soli: SERI ALCOLADO FRANCISCO ANTONIO. Datos registrales. T 36835 , F 155, S 8, H M 659380,I/A 34 (30.06.21).
30 de Junio de 2021Nombramientos. Apoderado: LINDO SANCHEZ ANAIS. Datos registrales. T 36835 , F 154, S 8, H M 659380, I/A 33 (23.06.21).
28 de Junio de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: GOMEZ DANIEL. Presidente: GOMEZ DANIEL. Con.Delegado: GOMEZ DANIEL. Nombramientos.Consejero: DE LUCAS DIEZ MARIANO ALBERTO. Presidente: GARDAZ JEAN LUC. Con.Delegado: GARDAZ JEAN LUC. Datosregistrales. T 36835 , F 154, S 8, H M 659380, I/A 32 (21.06.21).
05 de Enero de 2021Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 36835 , F 153, S 8, H M 659380, I/A 31 (28.12.20).
21 de Diciembre de 2020Nombramientos. Apo.Man.Soli: MONTES SANCHEZ ANTONIO. Datos registrales. T 36835 , F 150, S 8, H M 659380, I/A 29(14.12.20).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GALLARDO LUNA MARIA JOSE. Datos registrales. T 36835 , F 152, S 8, H M 659380, I/A 30(14.12.20).
06 de Agosto de 2020Revocaciones. Apoderado: BLANCO RODRIGUEZ ANA ISABEL. Datos registrales. T 36835 , F 150, S 8, H M 659380, I/A 28(30.07.20).
03 de Julio de 2020Nombramientos. Apoderado: HURTADO MARJALIZO FRANCISCO MANUEL. Datos registrales. T 36835 , F 149, S 8, H M659380, I/A 27 (26.06.20).
05 de Febrero de 2020Nombramientos. Apoderado: GESLIN NATHALIE. Datos registrales. T 36835 , F 147, S 8, H M 659380, I/A 26 (29.01.20).
02 de Diciembre de 2019Nombramientos. Apoderado: RAMIREZ ARAQUE MARIA MERCEDES. Datos registrales. T 36835 , F 146, S 8, H M 659380, I/A 24(25.11.19).
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 36835 , F 147, S 8, H M 659380, I/A 25 (25.11.19).
30 de Octubre de 2019Nombramientos. Apoderado: GARCIA CABRERA MIGUEL. Datos registrales. T 36835 , F 144, S 8, H M 659380, I/A 22 (23.10.19).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: CANO RAYO FRANCISCO JAVIER. Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ YELAMOSFRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 36835 , F 145, S 8, H M 659380, I/A 23 (23.10.19).
01 de Agosto de 2019Nombramientos. Apo.Man.Soli: GARCIA FERNANDEZ MONICA. Datos registrales. T 36835 , F 142, S 8, H M 659380, I/A 21(25.07.19).
23 de Mayo de 2019Revocaciones. Apoderado: MONTES NIETO AMELIA NATACHA;URETA MESA MARIA ADELA. Datos registrales. T 36835 , F142, S 8, H M 659380, I/A 20 (16.05.19).
03 de Mayo de 2019Revocaciones. Apoderado: MARCOS GARCIA JOSE LORENZO. Nombramientos. Apoderado: RESSEL BETTINA. Datosregistrales. T 36835 , F 140, S 8, H M 659380, I/A 19 (24.04.19).
23 de Abril de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: MOISSET ARNAUD;SCOTTI GIANNI. Nombramientos. Consejero: GARDAZ JEAN LUC;TOBARGRACIA PALOMA. Datos registrales. T 36835 , F 140, S 8, H M 659380, I/A 18 (12.04.19).
05 de Marzo de 2019Revocaciones. Apo.Sol.: NAVAS PALLARES JUAN. Nombramientos. Apoderado: ADRIAN TAUSCHKE ROBERTO. Datosregistrales. T 36835 , F 139, S 8, H M 659380, I/A 17 (26.02.19).
04 de Febrero de 2019Nombramientos. Apo.Man.Soli: CANO RAYO FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 36835 , F 138, S 8, H M 659380, I/A 15(28.01.19).
Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA FERNANDEZ MONICA. Datos registrales. T 36835 , F 139, S 8, H M 659380, I/A 16(28.01.19).
29 de Agosto de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: ANCHUSTEGUI QUINTELA RAFAEL. Nombramientos. Consejero: SCOTTI GIANNI. Datosregistrales. T 36835 , F 137, S 8, H M 659380, I/A 14 (22.08.18).
04 de Julio de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: GIMENEZ JIMENEZ FRANCESC. Datos registrales. T 36835 , F 137, S 8, H M 659380, I/A 13(27.06.18).
29 de Junio de 2018Nombramientos. Apoderado: LAFUENTE SALAS JAIME PABLO. Datos registrales. T 36835 , F 137, S 8, H M 659380, I/A 12(21.06.18).
22 de Junio de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: SEGUI SERRA JOSEP. Datos registrales. T 36835 , F 135, S 8, H M 659380, I/A 9 (15.06.18).
Nombramientos. Apo.Sol.: GONZALEZ OROBON NURIA. Datos registrales. T 36835 , F 135, S 8, H M 659380, I/A 10 (15.06.18).
Nombramientos. Apo.Sol.: NAVAS PALLARES JUAN. Datos registrales. T 36835 , F 136, S 8, H M 659380, I/A 11 (15.06.18).
29 de Mayo de 2018Nombramientos. Apo.Man.Soli: CID GARCIA NIEVES. Datos registrales. T 36835 , F 134, S 8, H M 659380, I/A 8 (22.05.18).
07 de Marzo de 2018Revocaciones. Apoderado: CARMENA CUERVA AURORA;MORENO DE CAYEUX DE SENARPONT ANDRES-JUAN. Datosregistrales. T 36835 , F 133, S 8, H M 659380, I/A 7 (28.02.18).
06 de Marzo de 2018Revocaciones. Apoderado: TORRELLES SERRA JORGE;SORRIBAS BARRERA MERCE;GRANADOS SEGURAANTONIO;SANTORROMAN FLAVIA RUTH;HUETE URBINA MARIA BLANCA;SANJUAN BARREIROS MARIA SAMANTA;ANDREUCALVO VICTOR;BUSTAMANTE FERNANDEZ FERNANDO. Nombramientos. Apoderado: CANO RAYO FRANCISCO JAVIER.Datos registrales. T 36835 , F 133, S 8, H M 659380, I/A 6 (23.02.18).
01 de Febrero de 2018Revocaciones. Apoderado: PERE脩A ANDRES RAFAEL. Datos registrales. T 36835 , F 132, S 8, H M 659380, I/A 5 1 (23.01.18).
03 de Enero de 2018Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 24.000.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 6.200.000,00 Euros. Datos registrales. T36835 , F 131, S 8, H M 659380, I/A 4 1 (26.12.17).
21 de Diciembre de 2017Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ JIMENEZ ROBERTO. Datos registrales. T 36835 , F 131, S 8, H M 659380, I/A 3(14.12.17).
20 de Diciembre de 2017Cambio de domicilio social. C/ FRANCISCO GASCO SANTILLAN 2 - POLIGONO INDUSTR (GETAFE). Datos registrales. T36835 , F 131, S 8, H M 659380, I/A 2 (13.12.17).
17 de Abril de 2017Nombramientos. APODERAD.SOL: VICENT GIMENEZ RAFAEL JOAQUIN. Datos registrales. T 45478 , F 24, S 8, H B 226593, I/A108 ( 5.04.17).
29 de Marzo de 2017Revocaciones. CONSEJERO: NICOLAS SURET. Nombramientos. CONSEJERO: ARNAUD MOISSET. Datos registrales. T45478 , F 24, S 8, H B 226593, I/A 107 (21.03.17).
22 de Marzo de 2017Nombramientos. APODERAD.SOL: GARCIA ORTEGA MARIA. Datos registrales. T 45478 , F 23, S 8, H B 226593, I/A 106 (9.03.17).
22 de Noviembre de 2016Nombramientos. APODERAD.SOL: BELLO DURAN MATILDE;JIMENEZ MENA JORGE;TRAPERO MILLAN DANIEL. Datosregistrales. T 45478 , F 23, S 8, H B 226593, I/A 105 (11.11.16).
11 de Octubre de 2016Nombramientos. APODERAD.SOL: MU脩OZ LOPEZ JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 45478 , F 22, S 8, H B 226593, I/A 102 (3.10.16).
Revocaciones. APODERAD.SOL: MIRANDA VALLESPIN MARIO. Nombramientos. APODERAD.SOL: MORAL PEREZ ANTONIO.Datos registrales. T 45478 , F 22, S 8, H B 226593, I/A 103 ( 3.10.16).
Revocaciones. APODERADO: HERNANZ BENITO JUAN. Datos registrales. T 45478 , F 23, S 8, H B 226593, I/A 104 ( 3.10.16).
06 de Septiembre de 2016Nombramientos. AUDIT.CUENT.: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 45478 , F 21, S 8, H B 226593, I/A 101 (26.08.16).
23 de Agosto de 2016Ampliaci贸n de capital. Capital: 29.000.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 30.200.000,00 Euros. Datos registrales. T 45478 , F 21,S 8, H B 226593, I/A 100 (12.08.16).
04 de Agosto de 2016Nombramientos. APOD.SOL/MAN: MARCOS GARCIA JOSE LORENZO. Datos registrales. T 43861 , F 156, S 8, H B 226593, I/A97 (27.07.16).
Nombramientos. APOD.SOL/MAN: MARCOS SANCHEZ VICENTE. Datos registrales. T 43861 , F 158, S 8, H B 226593, I/A 98(27.07.16).
Nombramientos. APOD.SOL/MAN: MU脩OZ LOPEZ JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 43861 , F 160, S 8, H B 226593, I/A 99(27.07.16).
08 de Junio de 2016Nombramientos. APOD.SOL/MAN: MONTES NIETO AMELIA NATACHA. Datos registrales. T 43861 , F 154, S 8, H B 226593, I/A96 ( 1.06.16).
21 de Marzo de 2016Nombramientos. APODERAD.SOL: MIGUEL GARCIA SONIA. Datos registrales. T 43861 , F 153, S 8, H B 226593, I/A 95(10.03.16).
21 de Diciembre de 2015Revocaciones. APODERADO: PLA GONZALEZ ISABEL. APOD.SOL/MAN: LAGUNAS ORTE CARLOS. Datos registrales. T 43861, F 153, S 8, H B 226593, I/A 94 (11.12.15).
24 de Noviembre de 2015Nombramientos. AUDIT.CUENT.: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 43861 , F 153, S 8, H B226593, I/A 93 (16.11.15).
12 de Noviembre de 2015Revocaciones. APODERADO: VILLENA ACEDOS EVA. Datos registrales. T 43861 , F 153, S 8, H B 226593, I/A 92 ( 3.11.15).
01 de Diciembre de 2014Revocaciones. APODERAD.SOL: IBARZ BAYONA ALBERTO. Datos registrales. T 43861 , F 152, S 8, H B 226593, I/A 91(24.11.14).
26 de Septiembre de 2014Nombramientos. AUDIT.CUENT.: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 43861 , F 152, S 8, H B226593, I/A 90 (19.09.14).
24 de Septiembre de 2014Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 4.800.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.200.000,00 Euros. Datos registrales. T 43861, F 152, S 8, H B 226593, I/A 89 (16.09.14).
04 de Septiembre de 2014Revocaciones. CONSEJERO: CHRISTIAN YAN MARIE COCHET. Nombramientos. CONSEJERO: NICOLAS SURET. Datosregistrales. T 43861 , F 152, S 8, H B 226593, I/A 88 (27.08.14).
07 de Agosto de 2014Nombramientos. APODERAD.SOL: ARRIBAS RIAGUAS JUAN CARLOS. Datos registrales. T 43861 , F 150, S 8, H B 226593, I/A84 (30.07.14).
Nombramientos. APODERAD.SOL: MIRANDA VALLESPIN MARIO. Datos registrales. T 43861 , F 150, S 8, H B 226593, I/A 85(30.07.14).
Nombramientos. APODERAD.SOL: BARRIO DELGADO ALVARO. Datos registrales. T 43861 , F 151, S 8, H B 226593, I/A 86(30.07.14).
Nombramientos. APODERAD.SOL: CORREIA TAVARES ANTONIO RICARDO. Datos registrales. T 43861 , F 151, S 8, H B226593, I/A 87 (30.07.14).
10 de Junio de 2014Revocaciones. APOD.SOL/MAN: DE LUCAS DIEZ MARIANO. Datos registrales. T 43861 , F 149, S 8, H B 226593, I/A 83(29.05.14).
21 de Mayo de 2014Revocaciones. APODERAD.SOL: URETA MESA ADELA. Nombramientos. APODERAD.SOL: URETA MESA ADELA. Datosregistrales. T 43861 , F 148, S 8, H B 226593, I/A 82 (12.05.14).
11 de Abril de 2014Nombramientos. APOD.SOL/MAN: BLANCO RODRIGUEZ ANA ISABEL. Datos registrales. T 43861 , F 144, S 8, H B 226593, I/A79 ( 3.04.14).
Nombramientos. APOD.SOL/MAN: MU脩OZ FERRER MARTA;MORENO DE CAYEUX DE SENARPONT ANDRES JUAN;TEJADOCHAMORRO DANIEL. Datos registrales. T 43861 , F 147, S 8, H B 226593, I/A 80 ( 3.04.14).
Revocaciones. APODERADO: ENCABO MOTREL JAVIER. Datos registrales. T 43861 , F 148, S 8, H B 226593, I/A 81 ( 3.04.14).
19 de Febrero de 2014Revocaciones. APODERADO: MENENDEZ PRADO JOSE ANTONIO;GARCIA MOLLON SERGIO. Nombramientos.APODERAD.SOL: URETA MESA ADELA. Datos registrales. T 43861 , F 143, S 8, H B 226593, I/A 78 (12.02.14).
28 de Enero de 2014Ampliaci贸n de capital. Capital: 4.020.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 6.000.000,00 Euros. Datos registrales. T 43861 , F 143, S8, H B 226593, I/A 77 (21.01.14).
21 de Octubre de 2013Revocaciones. APODERADO: GOICOECHEA GARAY LUIS ALBERTO;LAGUNAS ORTE CARLOS;NAVAS PALLARESJUAN;PADILLA RAFI JORDI. Datos registrales. T 43861 , F 143, S 8, H B 226593, I/A 76 (11.10.13).
10 de Octubre de 2013Nombramientos. AUDIT.CUENT.: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 43861 , F 143, S 8, H B226593, I/A 75 ( 2.10.13).
19 de Julio de 2013Nombramientos. APOD.SOL/MAN: LAGUNAS ORTE CARLOS. Datos registrales. T 43481 , F 172, S 8, H B 226593, I/A 65(12.07.13).
Nombramientos. APOD.SOL/MAN: DE LUCAS DIEZ MARIANO. Datos registrales. T 43481 , F 174, S 8, H B 226593, I/A 66(12.07.13).
Nombramientos. APOD.SOL/MAN: CARMENA CUERVA AURORA. Datos registrales. T 43481 , F 176, S 8, H B 226593, I/A 67(12.07.13).
Nombramientos. APOD.SOL/MAN: GALLARDO CODORRO VICTORIANO. Datos registrales. T 43481 , F 177, S 8, H B 226593,I/A 68 (12.07.13).
Nombramientos. APOD.SOL/MAN: GIMENEZ JIMENEZ FRANCESC. Datos registrales. T 43481 , F 179, S 8, H B 226593, I/A 69(12.07.13).
Nombramientos. APODERAD.SOL: CIVIT NOGUES ISMAEL. Datos registrales. T 43861 , F 141, S 8, H B 226593, I/A 70(12.07.13).
Nombramientos. APODERAD.SOL: VILA DE PEDRO JORDI. Datos registrales. T 43861 , F 141, S 8, H B 226593, I/A 71(12.07.13).
Nombramientos. APODERAD.SOL: HERNANDEZ TORES PATRICIA. Datos registrales. T 43861 , F 142, S 8, H B 226593, I/A 72(12.07.13).
Nombramientos. APODERAD.SOL: IBARZ BAYONA ALBERTO. Datos registrales. T 43861 , F 142, S 8, H B 226593, I/A 73(12.07.13).
Revocaciones. APODERADO: LOPEZ CABRERA VICTOR MANUEL;GUTIERREZ SALVADOR OSCAR;BOUZAS GARCIAMARIO;BUSTAMANTE FERNANDEZ FERNANDO;SALINAS FERNANDEZ MANUEL. Datos registrales. T 43861 , F 143, S 8, H B226593, I/A 74 (12.07.13).
07 de Mayo de 2013Revocaciones. SECR.NO CONS: PADILLA RAFI JORDI. Nombramientos. SECR.NO CONS: SEGUI SERRA JOSEP. Datos
27 de Noviembre de 2012Revocaciones. APODERADO: SALVADOR CORREA FRANCISCO ANTONIO. Nombramientos. APODERADO: SEGUI SERRA
03 de Agosto de 2012Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 4.020.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.980.000,00 Euros. Datos registrales. T 42173, F 129, S 8, H B 226593, I/A 62 (26.07.12).
27 de Julio de 2012Nombramientos. AUDIT.CUENT.: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 42173 , F 129, S 8, H B226593, I/A 61 (18.07.12).
21 de Marzo de 2012Nombramientos. APODERADO: MARTINEZ SANCHEZ MARIA OLGA. Datos registrales. T 42173 , F 127, S 8, H B 226593, I/A 60( 7.03.12).
12 de Diciembre de 2011Revocaciones. APODERADO: ANCHUSTEGUI QUINTELA RAFAEL. Datos registrales. T 42173 , F 127, S 8, H B 226593, I/A 59(29.11.11).
17 de Agosto de 2011Nombramientos. AUDIT.CUENT.: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 42173 , F 126, S 8, H B226593, I/A 58 ( 8.08.11).
04 de Julio de 2011Nombramientos. APODERADO: HERNANZ BENITO JUAN. Datos registrales. T 42173 , F 123, S 8, H B 226593, I/A 57 (21.06.11).
13 de Abril de 2011Nombramientos. APODERADO: PLA GONZALEZ ISABEL. Datos registrales. T 42173 , F 122, S 8, H B 226593, I/A 56 ( 1.04.11).
15 de Febrero de 2011Revocaciones. APODERADO: BE脩A LUQUE LUIS JAVIER. Datos registrales. T 42173 , F 122, S 8, H B 226593, I/A 55 ( 3.02.11).
21 de Enero de 2011Revocaciones. SECR.NO CONS: ECHANIZ UNAMUNO BEATRIZ. Nombramientos. SECR.NO CONS: PADILLA RAFI JORDI.Datos registrales. T 42173 , F 121, S 8, H B 226593, I/A 52 (12.01.11).
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 42173 , F 121, S 8, H B226593, I/A 53 (12.01.11).
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 42173 , F 122, S 8, H B226593, I/A 54 (12.01.11).
08 de Noviembre de 2010Nombramientos. APODERADO: SALVADOR CORREA FRANCISCO ANTONIO. Datos registrales. T 41396 , F 224, S 8, H B226593, I/A 50 (25.10.10).
Revocaciones. APODERADO: MU脩OZ GORDALIZA SANTIAGO. Datos registrales. T 42173 , F 121, S 8, H B 226593, I/A 51(25.10.10).
23 de Julio de 2010Revocaciones. APODERADO: RODRIGUEZ PEREZ IGNACIO;LAFUENTE SALAS JAIME;TOMAS GUMFAU ANGELS;SALINASFERNANDEZ MANUEL;JIMENEZ NU脩EZ ENRIQUE. Nombramientos. APODERADO: LOPEZ CABRERA VICTORMANUEL;GUTIERREZ SALVADOR OSCAR;ARROYO CARRILLO RAUL;GARCIA MOLLON SERGIO;MONTA脩ES TORRENT RAULGASPAR;BOUZAS GARCIA MARIO;BUSTAMANTE FERNANDEZ FERNANDO;PERE脩A ANDRES RAFAEL;LAFUENTE SALASJAIME PABLO;SALINAS FERNANDEZ MANUEL;TOMAS GUMFAU MARIA ANGELS. Datos registrales. T 41396 , F 221, S 8, H B226593, I/A 49 (13.07.10).
28 de Junio de 2010Nombramientos. APODERADO: NAVAS PALLARES JUAN. Datos registrales. T 41396 , F 212, S 8, H B 226593, I/A 46 (16.06.10).
Nombramientos. APODERADO: PADILLA RAFI JORDI. Datos registrales. T 41396 , F 215, S 8, H B 226593, I/A 47 (16.06.10).
Nombramientos. APODERADO: LUPION MORENO SILVIA. Datos registrales. T 41396 , F 219, S 8, H B 226593, I/A 48 (16.06.10).
05 de Mayo de 2010Revocaciones. APODERADO: TOMAS GUMFAUS ANGELS;TRENCHS LOPEZ DAVID. Nombramientos. APODERADO: TOMASGUMFAU MARIA ANGELS;HERNANDEZ TORES PATRICIA. Datos registrales. T 41396 , F 208, S 8, H B 226593, I/A 44 (26.04.10).
Revocaciones. APODERADO: LAGUNAS ORTE CARLOS;PALA CASTELLA GABRIEL;BE脩A LUQUE LUIS JAVIER.Nombramientos. APODERADO: LAGUNAS ORTE CARLOS;BE脩A LUQUE LUIS JAVIER;CERCOS MUS JOSEP MARIA. Datosregistrales. T 41396 , F 209, S 8, H B 226593, I/A 45 (26.04.10).
26 de Abril de 2010Revocaciones. CONSEJERO: PATRICK BERTRAND. PRESIDENTE: PATRICK BERTRAND. CONSEJERO: FERNANDEZCRISTOBAL JAVIER. Nombramientos. CONSEJERO: CHRISTIAN YAN MARIE COCHET;ANCHUSTEGUI QUINTELA RAFAEL.PRESIDENTE: DANIEL GOMEZ. Datos registrales. T 41396 , F 207, S 8, H B 226593, I/A 43 (15.04.10).
08 de Marzo de 2010Nombramientos. APODERADO: MENENDEZ PRADO JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 41396 , F 206, S 8, H B 226593, I/A 42(24.02.10).
05 de Enero de 2010Nombramientos. APODERADO: GOICOECHEA GARAY LUIS ALBERTO. Datos registrales. T 41396 , F 202, S 8, H B 226593, I/A40 (22.12.09).
Nombramientos. APODERADO: MU脩OZ GORDALIZA SANTIAGO. Datos registrales. T 41396 , F 204, S 8, H B 226593, I/A 41(22.12.09).
11 de Septiembre de 2009Nombramientos. APODERADO: ENCABO MOTREL JAVIER. Datos registrales. T 40413 , F 120, S 8, H B 226593, I/A 37(31.08.09).
Nombramientos. APODERADO: VILLENA ACEDOS EVA. Datos registrales. T 40413 , F 124, S 8, H B 226593, I/A 38 (31.08.09).
Nombramientos. APODERADO: ANCHUSTEGUI QUINTELA RAFAEL. Datos registrales. T 40413 , F 127, S 8, H B 226593, I/A 39(31.08.09).