Actos BORME de Saint Gobain Isover Iberica Sl
13 de Octubre de 2023Nombramientos. Apoderado: CRUZADO LEDESMA LAURA. Datos registrales. T 41251 , F 185, S 8, H M 582248, I/A 82 ( 5.10.23).
30 de Mayo de 2023Nombramientos. Apoderado: PIRES DUARTE DA SILVA PEDRO MIGUEL. Datos registrales. T 41251 , F 183, S 8, H M 582248,I/A 80 (23.05.23).
10 de Febrero de 2023Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 41251 , F 183, S 8, H M 582248, I/A 79 ( 3.02.23).
31 de Octubre de 2022Nombramientos. Apoderado: ALONSO MARTINEZ EDUARDO. Datos registrales. T 39847 , F 98, S 8, H M 582248, I/A 78(24.10.22).
21 de Septiembre de 2022Revocaciones. Apo.Man.Soli: CID GARCIA NIEVES. Apo.Sol.: SAURA ALCARAZ MARIA DOLORES. Apoderado: PE脩A PE脩AJESUS. Apo.Sol.: RAMOS RAMOS ANTONIO-JOAQUIN. Apo.Manc.: RAMOS RAMOS ANTONIO-JOAQUIN. Datos registrales. T39847 , F 95, S 8, H M 582248, I/A 75 (14.09.22).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARTINEZ SANCHEZ MARIA OLGA. Datos registrales. T 39847 , F 95, S 8, H M 582248, I/A 76(14.09.22).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: BLASCO TITO VICENS. Datos registrales. T 39847 , F 97, S 8, H M 582248, I/A 77 (14.09.22).
16 de Junio de 2022Nombramientos. Apoderado: VILCHEZ BETTINI ANTONIO. Datos registrales. T 39847 , F 93, S 8, H M 582248, I/A 74 ( 9.06.22).
19 de Mayo de 2022Revocaciones. Apo.Man.Soli: RAMASCO LUCA. Nombramientos. Apo.Man.Soli: FERNANDEZ CRISTOBAL JAVIER. Datosregistrales. T 39847 , F 92, S 8, H M 582248, I/A 73 (11.05.22).
21 de Febrero de 2022Revocaciones. Apo.Sol.: ARMESILLA GARCIA ANA MARIA. Nombramientos. Apoderado: GIMENO ALCALA LUIS. Datosregistrales. T 39847 , F 88, S 8, H M 582248, I/A 71 (14.02.22).
Nombramientos. Apoderado: GARCIA RAMON PEDRO JOSE. Datos registrales. T 39847 , F 90, S 8, H M 582248, I/A 72(14.02.22).
17 de Enero de 2022Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 39847 , F 88, S 8, H M 582248, I/A 70 (10.01.22).
30 de Noviembre de 2021Revocaciones. Apo.Man.Soli: HURTADO MARJALIZO FRANCISCO MANUEL. Apoderado: HURTADO MARJALIZO FRANCISCOMANUEL. Nombramientos. Apo.Man.Soli: RAMASCO LUCA. Datos registrales. T 39847 , F 86, S 8, H M 582248, I/A 69(23.11.21).
22 de Noviembre de 2021Revocaciones. Apoderado: RESSEL BETTINA. Nombramientos. Apo.Man.Soli: RESSEL BETTINA. Datos registrales. T 39847 ,F 84, S 8, H M 582248, I/A 68 (15.11.21).
11 de Octubre de 2021Nombramientos. Apoderado: DOMINGUEZ MARTINEZ ALEJANDRO. Datos registrales. T 39847 , F 83, S 8, H M 582248, I/A 67 (4.10.21).
23 de Septiembre de 2021Revocaciones. Apo.Man.Soli: GALLARDO CODORRO VICTORIANO. Datos registrales. T 39847 , F 83, S 8, H M 582248, I/A 66(16.09.21).
06 de Julio de 2021Nombramientos. Apoderado: SERI ALCOLADO FRANCISCO ANTONIO. Datos registrales. T 39847 , F 81, S 8, H M 582248, I/A65 (29.06.21).
01 de Junio de 2021Nombramientos. Apoderado: LINDO SANCHEZ ANAIS. Datos registrales. T 39847 , F 81, S 8, H M 582248, I/A 64 (25.05.21).
08 de Abril de 2021Nombramientos. Apo.Man.Soli: PARDO COBO FERNANDO. Datos registrales. T 39847 , F 79, S 8, H M 582248, I/A 63 (30.03.21).
12 de Enero de 2021Revocaciones. Apo.Man.Soli: MARCOS GARCIA JOSE LORENZO. Datos registrales. T 39847 , F 79, S 8, H M 582248, I/A 62 (4.01.21).
21 de Diciembre de 2020Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 39847 , F 79, S 8, H M 582248, I/A 61 (14.12.20).
14 de Diciembre de 2020Nombramientos. Apo.Man.Soli: CHICOT LLANO MARIO. Datos registrales. T 39847 , F 77, S 8, H M 582248, I/A 60 ( 3.12.20).
08 de Octubre de 2020Nombramientos. Apoderado: HURTADO MARJALIZO FRANCISCO MANUEL. Datos registrales. T 39847 , F 77, S 8, H M 582248,I/A 59 ( 1.10.20).
13 de Abril de 2020Nombramientos. Apoderado: BOTTERO VILLEGAS MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 39847 , F 75, S 8, H M 582248, I/A 58 (2.04.20).
24 de Marzo de 2020Nombramientos. Apoderado: SORIANO HOYUELOS ESTHER. Datos registrales. T 39847 , F 70, S 8, H M 582248, I/A 56(17.03.20).
Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ TRIGOS RICARDO. Datos registrales. T 39847 , F 73, S 8, H M 582248, I/A 57(17.03.20).
26 de Febrero de 2020Nombramientos. Apoderado: CHICOT LLANO MARIO. Datos registrales. T 39847 , F 70, S 8, H M 582248, I/A 55 (19.02.20).
20 de Diciembre de 2019Nombramientos. Apoderado: RAMIREZ ARAQUE MARIA MERCEDES. Datos registrales. T 39847 , F 70, S 8, H M 582248, I/A 54(13.12.19).
04 de Diciembre de 2019Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 35936 , F 54, S 8, H M 582248, I/A 53 (27.11.19).
28 de Noviembre de 2019Revocaciones. Apo.Manc.: GARCIA MORO MIGUEL ANGEL. Apoderado: RUIZ ROZAS LAURA;CANALES CASTELLANOS MARIAESTHER. Datos registrales. T 35936 , F 54, S 8, H M 582248, I/A 52 (21.11.19).
04 de Noviembre de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: BAUTISTA VERASTEGUI VICTOR. Nombramientos. Consejero: MACIEL MARQUES RAMOSJOSE FILIPE. Datos registrales. T 35936 , F 54, S 8, H M 582248, I/A 51 (25.10.19).
24 de Octubre de 2019Revocaciones. Apoderado: BAUTISTA VERASTEGUI VICTOR. Nombramientos. Apo.Man.Soli: MACIEL MARQUES RAMOSJOSE FILIPE. Datos registrales. T 35936 , F 51, S 8, H M 582248, I/A 50 (17.10.19).
08 de Octubre de 2019Nombramientos. Apoderado: PEREZ PAJARES JORGE. Datos registrales. T 35936 , F 51, S 8, H M 582248, I/A 48 ( 1.10.19).
Revocaciones. Apo.Sol.: SANCHEZ MARTIN JOSE ANTONIO. Apoderado: GONZALEZ CUETOS PEDRO LUIS;GONZALEZCUETOS PEDRO LUIS;GARCIA DE ARRIBA MARCOS PATRICIA. Datos registrales. T 35936 , F 51, S 8, H M 582248, I/A 49 (1.10.19).
08 de Abril de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: SCOTTI GIANNI. Presidente: SCOTTI GIANNI. Consejero: MOISSET ARNAUD. Con.Delegado:SCOTTI GIANNI. Nombramientos. Consejero: TOBAR GRACIA PALOMA. Con.Delegado: GARDAZ JEAN LUC. Consejero:GARDAZ JEAN LUC. Presidente: GARDAZ JEAN LUC. Datos registrales. T 35936 , F 50, S 8, H M 582248, I/A 47 ( 1.04.19).
18 de Marzo de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: TOBAR GRACIA PALOMA. Apo.Manc.: TOBAR GRACIA PALOMA. Datos registrales. T 35936 , F 44, S8, H M 582248, I/A 42 (11.03.19).
Nombramientos. Apo.Sol.: RAMOS RAMOS ANTONIO-JOAQUIN. Apo.Manc.: RAMOS RAMOS ANTONIO-JOAQUIN. Datosregistrales. T 35936 , F 46, S 8, H M 582248, I/A 43 (11.03.19).
Nombramientos. Apo.Sol.: ARMESILLA GARCIA ANA MARIA. Datos registrales. T 35936 , F 48, S 8, H M 582248, I/A 44(11.03.19).
Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ BLANCO ESTEFANIA. Datos registrales. T 35936 , F 49, S 8, H M 582248, I/A 45(11.03.19).
Nombramientos. Apo.Sol.: RODRIGUEZ TRIGOS RICARDO. Datos registrales. T 35936 , F 50, S 8, H M 582248, I/A 46 (11.03.19).
20 de Febrero de 2019Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ RUBIO LAURA. Datos registrales. T 35936 , F 44, S 8, H M 582248, I/A 41 (13.02.19).
22 de Agosto de 2018Nombramientos. Apoderado: CASO HOMBRADOS JOAQUIN. Datos registrales. T 35936 , F 42, S 8, H M 582248, I/A 40(14.08.18).
17 de Julio de 2018Nombramientos. Apoderado: BAUTISTA VERASTEGUI VICTOR. Datos registrales. T 35936 , F 39, S 8, H M 582248, I/A 39(10.07.18).
27 de Junio de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: FERNANDEZ CAMPAL FRANCISCO JAVIER. Con.Delegado: FERNANDEZ CAMPAL FRANCISCOJAVIER. Nombramientos. Consejero: BAUTISTA VERASTEGUI VICTOR. Con.Delegado: SCOTTI GIANNI. Datos registrales. T35936 , F 39, S 8, H M 582248, I/A 38 (20.06.18).
26 de Marzo de 2018Nombramientos. Apoderado: CANALES CASTELLANOS MARIA ESTHER. Datos registrales. T 35936 , F 39, S 8, H M 582248, I/A37 (16.03.18).
28 de Febrero de 2018Revocaciones. Apoderado: CARMENA CUERVA AURORA. Apo.Man.Soli: MORENO DE CAYEUX DE SENARPONT ANDRES-JUAN. Apoderado: GONZALEZ LOPEZ ANGEL. Datos registrales. T 35936 , F 38, S 8, H M 582248, I/A 36 (21.02.18).
10 de Enero de 2018Revocaciones. Apo.Sol.: BLANCO GONZALEZ ANGEL. Datos registrales. T 35936 , F 38, S 8, H M 582248, I/A 35 (28.12.17).
06 de Noviembre de 2017Nombramientos. Apoderado: GARCIA DE ARRIBA MARCOS PATRICIA. Datos registrales. T 35936 , F 37, S 8, H M 582248, I/A33 (26.10.17).
Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ BLANCO ESTEFANIA. Datos registrales. T 35936 , F 37, S 8, H M 582248, I/A 34(26.10.17).
28 de Septiembre de 2017Otros conceptos: SE RECTIFICA EL PRIMER APELLIDO DEL APODERADO DESIGNADO DON PEDRO LUIS VITOREROMIGUELEZ, QUE SE CONSIGNO ERRONEAMENTE EN LA ESCRITURA QUE CAUSO LA INSCRIPCION 32陋 COMO "VOTORERO",SIENDO EL APELLIDO CORRECTO "VITORERO". Datos registrales. T 35936 , F 36, S 8, H M 582248, I/A 32-M (20.09.17).
24 de Agosto de 2017Nombramientos. Apoderado: VOTORERO MIGUELEZ PEDRO LUIS. Datos registrales. T 35936 , F 36, S 8, H M 582248, I/A 32(16.08.17).
03 de Agosto de 2017Nombramientos. Apoderado: PE脩A PE脩A JESUS. Datos registrales. T 35936 , F 35, S 8, H M 582248, I/A 31 (27.07.17).
31 de Mayo de 2017Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ CUETOS PEDRO LUIS. Datos registrales. T 32433 , F 224, S 8, H M 582248, I/A 29(23.05.17).
Nombramientos. Apoderado: MU脩OZ LOPEZ JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 32433 , F 225, S 8, H M 582248, I/A 30(23.05.17).
29 de Mayo de 2017Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: FERNANDEZ CAMPAL FRANCISCO JAVIER. Nombramientos. Consejero: SCOTTI GIANNI.Presidente: SCOTTI GIANNI. Consejero: FERNANDEZ CAMPAL FRANCISCO JAVIER. Con.Delegado: FERNANDEZ CAMPALFRANCISCO JAVIER. Consejero: MOISSET ARNAUD. SecreNoConsj: RABADAN ESPA脩A MARGARITA. Otros conceptos:Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Consejo de administraci贸n. Datos registrales. T 32433 , F 221, S 8, HM 582248, I/A 26 (19.05.17).
Nombramientos. Apoderado: BERUFF ABREU ALEJANDRO. Datos registrales. T 32433 , F 221, S 8, H M 582248, I/A 27(19.05.17).
Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ CUETOS PEDRO LUIS. Datos registrales. T 32433 , F 222, S 8, H M 582248, I/A 28(19.05.17).
16 de Febrero de 2017Nombramientos. Apoderado: RUIZ ROZAS LAURA. Datos registrales. T 32433 , F 220, S 8, H M 582248, I/A 25 ( 8.02.17).
07 de Diciembre de 2016Nombramientos. Apo.Sol.: SAURA ALCARAZ MARIA DOLORES. Datos registrales. T 32433 , F 220, S 8, H M 582248, I/A 24(24.11.16).
07 de Octubre de 2016Nombramientos. Apoderado: MU脩OZ LOPEZ JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 32433 , F 220, S 8, H M 582248, I/A 23(29.09.16).
20 de Septiembre de 2016Revocaciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL.Datos registrales. T 32433 , F 219, S 8, H M 582248, I/A 22 (12.09.16).
15 de Junio de 2016Revocaciones. Apo.Man.Soli: FRUTOS HERNANZ BENITO JUAN. Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARCOS GARCIA JOSELORENZO. Datos registrales. T 32433 , F 218, S 8, H M 582248, I/A 21 ( 7.06.16).
07 de Abril de 2016Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ LOPEZ ANGEL. Datos registrales. T 32433 , F 217, S 8, H M 582248, I/A 20 (30.03.16).
10 de Febrero de 2016Nombramientos. Apo.Sol.: COSTA FERNANDEZ MILAGROS. Datos registrales. T 32433 , F 216, S 8, H M 582248, I/A 19 (2.02.16).
10 de Julio de 2015Revocaciones. Apo.Manc.: PEREZ MONTES JOSE LUIS. Apo.Sol.: PEREZ MONTES JOSE LUIS. Datos registrales. T 32433 , F216, S 8, H M 582248, I/A 18 ( 3.07.15).
03 de Marzo de 2015Nombramientos. Apo.Man.Soli: CID GARCIA NIEVES. Datos registrales. T 32433 , F 215, S 8, H M 582248, I/A 17 (20.02.15).
12 de Febrero de 2015Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 32433 , F 215, S 8, H M 582248,I/A 16 ( 5.02.15).
19 de Diciembre de 2014Nombramientos. Apo.Man.Soli: BERUFF ABREU ALEJANDRO. Datos registrales. T 32433 , F 213, S 8, H M 582248, I/A 15(10.12.14).
03 de Octubre de 2014Ampliaci贸n de capital. Capital: 34.479.450,00 Euros. Resultante Suscrito: 34.482.450,00 Euros. Datos registrales. T 32433 , F 212,S 8, H M 582248, I/A 14 (25.09.14).
13 de Agosto de 2014Nombramientos. Apo.Manc.: GONZALEZ BLANCO MIGUEL ANGEL. Apo.Sol.: BLANCO GONZALEZ ANGEL. Datos registrales. T32433 , F 206, S 8, H M 582248, I/A 10 ( 5.08.14).
Nombramientos. Apo.Sol.: SANCHEZ MARTIN JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 32433 , F 208, S 8, H M 582248, I/A 11 (5.08.14).
Nombramientos. Apo.Manc.: PEREZ MONTES JOSE LUIS. Apo.Sol.: PEREZ MONTES JOSE LUIS. Datos registrales. T 32433 , F209, S 8, H M 582248, I/A 12 ( 5.08.14).
Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA MORO MIGUEL ANGEL. Apo.Manc.: GARCIA MORO MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T32433 , F 210, S 8, H M 582248, I/A 13 ( 5.08.14).
08 de Agosto de 2014Nombramientos. Apoderado: CARMENA CUERVA AURORA. Datos registrales. T 32346 , F 96, S 8, H M 582248, I/A 3 (31.07.14).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GALLARDO CODORRO VICTORIANO. Datos registrales. T 32346 , F 97, S 8, H M 582248, I/A 4(31.07.14).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: FRUTOS HERNANZ BENITO JUAN. Datos registrales. T 32346 , F 217, S 8, H M 582248, I/A 5(31.07.14).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: MORENO DE CAYEUX DE SENARPONT ANDRES-JUAN. Datos registrales. T 32433 , F 200, S 8,H M 582248, I/A 6 (31.07.14).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: MU脩OZ FERRER MARTA. Datos registrales. T 32433 , F 201, S 8, H M 582248, I/A 7 (31.07.14).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: HURTADO MARJALIZO FRANCISCO MANUEL. Datos registrales. T 32433 , F 203, S 8, H M582248, I/A 8 (31.07.14).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: TEJADO CHAMORRO DANIEL. Datos registrales. T 32433 , F 204, S 8, H M 582248, I/A 9(31.07.14).
07 de Agosto de 2014Nombramientos. Apoderado: RESSEL BETTINA. Datos registrales. T 32346 , F 94, S 8, H M 582248, I/A 2 (31.07.14).
13 de Junio de 2014Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 19.05.14. Objeto social: LA FABRICACION, TRANSFORMACION Y VENTA DE FIBRAS YLANAS MINERALES Y CUALESQUIERA OTROS PRODUCTOS SIMILARES, EN TODAS LAS MODALIDADES Y, EN PARTICULAR,DE VIDRIO, PARA TODOS LOS USOS ESPECIALMENTE PARA AISLAMIENTO.- Domicilio: C/ PRINCIPE DE VERGARA 132(MADRID). Capital: 3.000,00 Euros. Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: SAINT GOBAIN CRISTALERIA SL.Nombramientos. Adm. Unico: FERNANDEZ CAMPAL FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 32346 , F 93, S 8, H M 582248,I/A 1 ( 6.06.14).