Actos BORME de Saitec Sociedad Anonima
21 de Julio de 2022Reelecciones. Auditor: AUDITEC TECNICOS AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 5656 , F 193, S 8, H BI3493,A , I/ 59 .(11.07.22).
02 de Febrero de 2022Cambio de objeto social. AMPLIACION: La compraventa, arrendamiento y explotación de toda clase de bienes inmuebles. Datosregistrales. T 5656 , F 193, S 8, H BI 3493,A , I/ 58 .(24.01.22).
03 de Enero de 2022Revocaciones. Apoderado: MATEO LASCORZ CARLOS;MATEO LASCORZ CARLOS;MATEO LASCORZ JOSE CARLOS. Datosregistrales. T 5656 , F 193, S 8, H BI 3493,A , I/ 57 .(24.12.21).
22 de Abril de 2021Reelecciones. Adm. Solid.: GALDOS TOBALINA ALBERTO;URGOITI MARTIN FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 5656 , F191, S 8, H BI 3493,A , I/ 55 .(15.04.21).
Nombramientos. Apoderado: MATEO LASCORZ JOSE CARLOS. Datos registrales. T 5656 , F 191, S 8, H BI 3493,A , I/ 56.(15.04.21).
31 de Octubre de 2019Revocaciones. Apoderado: CASO GARCIA FRANCISCO JOSE. Datos registrales. T 5656 , F 191, S 8, H BI 3493,A , I/ 54.(23.10.19).
26 de Diciembre de 2018Reelecciones. Auditor: AUDITEC TECNICOS AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 5656 , F 191, S 8, H BI3493,A , I/ 53 .(14.12.18).
08 de Mayo de 2018Nombramientos. Apoderado: MATEO LASCORZ JOSE CARLOS. Datos registrales. T 5656 , F 189, S 8, H BI 3493,A , I/ 52.(25.04.18).
15 de Marzo de 2018Modificaciones estatutarias. Modificacion del artículo 25º de los estatutos sociales.. Datos registrales. T 5656 , F 189, S 8, H BI3493,A , I/ 51 .( 6.03.18).
28 de Julio de 2017Nombramientos. Apoderado: GARAGORRI REVENGA FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 5656 , F 187, S 8, H BI 3493,A ,I/ 49 .(19.07.17).
Nombramientos. Apoderado: MATEO LASCORZ JOSE CARLOS. Datos registrales. T 5656 , F 188, S 8, H BI 3493,A , I/ 50.(19.07.17).
19 de Enero de 2017Nombramientos. Apoderado: GARAGORRI REVENGA FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 5493 , F 142, S 8, H BI 3493,A ,I/ 48 .( 4.01.17).
29 de Septiembre de 2016Reelecciones. Adm. Solid.: GALDOS TOBALINA ALBERTO;URGOITI MARTIN FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 5493 , F142, S 8, H BI 3493,A , I/ 47 .(16.09.16).
21 de Diciembre de 2015Reelecciones. Auditor: AUDITEC TECNICOS AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 5493 , F 142, S 8, H BI3493,A , I/ 46 .( 9.12.15).
04 de Noviembre de 2015Nombramientos. Apoderado: GARCIA GONZALEZ DIEGO JESUS. Datos registrales. T 5493 , F 141, S 8, H BI 3493,A , I/ 44.(23.10.15).
Nombramientos. Apoderado: CASO GARCIA FRANCISCO JOSE. Datos registrales. T 5493 , F 142, S 8, H BI 3493,A , I/ 45.(23.10.15).
30 de Septiembre de 2015Nombramientos. Apoderado: GALDOS ISPIZUA ALBERTO. Datos registrales. T 5493 , F 139, S 8, H BI 3493,A , I/ 43 .(16.09.15).
21 de Agosto de 2015Nombramientos. Apoderado: MATEO LASCORZ JOSE CARLOS. Datos registrales. T 5493 , F 137, S 8, H BI 3493,A , I/ 40.(12.08.15).
Nombramientos. Apoderado: GARAGORRI REVENGA FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 5493 , F 138, S 8, H BI 3493,A ,I/ 41 .(12.08.15).
Revocaciones. Apoderado: ESCOBAR CERVANTES FRANCISCO BORJA;ESCOBAR CERVANTES FRANCISCO BORJA. Datosregistrales. T 5493 , F 139, S 8, H BI 3493,A , I/ 42 .(12.08.15).
19 de Diciembre de 2014Nombramientos. Apoderado: MATEO LASCORZ JOSE CARLOS. Datos registrales. T 5493 , F 132, S 8, H BI 3493,A , I/ 36 .(9.12.14).
Nombramientos. Apoderado: GARAGORRI REVENGA FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 5493 , F 133, S 8, H BI 3493,A ,I/ 37 .( 9.12.14).
Nombramientos. Apoderado: BELALCAZAR GUERRERO ALEX YESID. Datos registrales. T 5493 , F 134, S 8, H BI 3493,A , I/ 38.( 9.12.14).
Nombramientos. Apoderado: ESCOBAR CERVANTES FRANCISCO BORJA. Datos registrales. T 5493 , F 135, S 8, H BI 3493,A ,I/ 39 .( 9.12.14).
30 de Octubre de 2014Nombramientos. Apoderado: MATEO LASCORZ JOSE CARLOS. Datos registrales. T 2069 , F 225, S 8, H BI 3493,A , I/ 35.(16.10.14).
16 de Septiembre de 2014Revocaciones. Apoderado: AGUILERA BECERRIL ZITA;SANTISTEBAN AVELLA SANDRA LILIANA. Apo.Sol.: BASSINO PINASCOMANLIO;AGUILERA BECERRIL ZITA CONSUELO. Datos registrales. T 2069 , F 223, S 8, H BI 3493,A , I/ 34 .( 1.09.14).
21 de Enero de 2014Nombramientos. Apoderado: ESCOBAR CERVANTES FRANCISCO BORJA. Datos registrales. T 2069 , F 223, S 8, H BI 3493,A ,I/ 33 .( 8.01.14).
05 de Agosto de 2013Nombramientos. Apoderado: ESCOBAR CERVANTES FRANCISCO BORJA. Datos registrales. T 2069 , F 222, S 8, H BI 3493,A ,I/ 32 .(22.07.13).
19 de Julio de 2013Nombramientos. Apoderado: SANTISTEBAN AVELLA SANDRA LILIANA. Datos registrales. T 2069 , F 215, S 8, H BI 3493,A , I/ 25.( 4.07.13).
Nombramientos. Apoderado: MATEO LASCORZ JOSE CARLOS. Datos registrales. T 2069 , F 215, S 8, H BI 3493,A , I/ 26 .(5.07.13).
Nombramientos. Apoderado: GARAGORRI REVENGA FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 2069 , F 217, S 8, H BI 3493,A ,I/ 27 .( 5.07.13).
11 de Julio de 2013Nombramientos. Apoderado: MATEO LASCORZ JOSE CARLOS. Datos registrales. T 2069 , F 218, S 8, H BI 3493,A , I/ 28 .(5.07.13).
Nombramientos. Apoderado: ESCOBAR CERVANTES FRANCISCO BORJA. Datos registrales. T 2069 , F 219, S 8, H BI 3493,A ,I/ 29 .( 5.07.13).
Nombramientos. Apoderado: GARAGORRI REVENGA FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 2069 , F 220, S 8, H BI 3493,A ,I/ 30 .( 5.07.13).
Nombramientos. Apo.Sol.: BASSINO PINASCO MANLIO;AGUILERA BECERRIL ZITA CONSUELO. Datos registrales. T 2069 , F221, S 8, H BI 3493,A , I/ 31 .( 5.07.13).
02 de Julio de 2013Nombramientos. Apoderado: BELALCAZAR GUERRERO ALEX YESID. Datos registrales. T 2069 , F 213, S 8, H BI 3493,A , I/ 24.(21.06.13).
30 de Abril de 2013Reelecciones. Auditor: AUDITEC TECNICOS AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 2069 , F 213, S 8, H BI3493,A , I/ 23 .(18.04.13).
27 de Febrero de 2012Reelecciones. Adm. Solid.: GALDOS TOBALINA ALBERTO;URGOITI MARTIN FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 2069 , F213, S 8, H BI 3493,A , I/ 22 .(13.02.12).
03 de Febrero de 2012Nombramientos. Apoderado: AGUILERA BECERRIL ZITA. Datos registrales. T 2069 , F 212, S 8, H BI 3493,A , I/ 21 .(19.01.12).
15 de Diciembre de 2011Cambio de objeto social. elaboracion de expedientes, tecnicos de obras, supervisión de obras, elaboracion de estudios depreinversion, diseño de proyectos, peritajes, investigaciones. Datos registrales. T 2069 , F 212, S 8, H BI 3493,A , I/ 20 .(30.11.11).
13 de Mayo de 2011Cambio de objeto social. Desarrollo de estudios, proyectos y servicios de ingeniería de todo tipo incluyendo telecomuncaciones,desarrollo, aplicaciones informáticas, instalaciones de seguridad y comunicaciones, comercialización de productos informáticos y laprestación de personal y servicios a terceros. Datos registrales. T 2069 , F 77, S 8, H BI 3493,A , I/ 19 .( 3.05.11).
28 de Septiembre de 2009Reelecciones. Auditor: AUDITEC TECNICOS AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 2069 , F 77, S 8, H BI3493,A , I/ 18 .(14.09.09).
02 de Julio de 2009Reelecciones. Auditor: AUDITEC TECNICOS AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 2069 , F 77, S 8, H BI3493,A , I/ 17 .(22.06.09).
09 de Enero de 2009Revocaciones. Apoderado: LASFUENTES MARTINEZ ICIAR. Datos registrales. T 2069 , F 76, S 8, H BI 3493,A , I/ 16 .(24.12.08).