Actos BORME de Salva Industrial Sa
14 de Enero de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: LASCURAIN AGUIRRESAROBE GUSTAVO;LLORDES ALONSO ANA;LLORDES USANDIZAGAIGOR;LLORDES IBA脩EZ JAIME. Presidente: LLORDES IBA脩EZ JAIME. Consejero: LLORDES ARRATIBEL DAVID;INSALHOL 2018SL. Revocaciones. Dir. General: LLORDES ARRATIBEL DAVID. L. Asesor: BARAHONA FERNANDEZ MAIDER. SecreNoConsj:BARAHONA FERNANDEZ MAIDER. Apoderado: LLORDES ARRATIBEL DAVID;LLORDES ARRATIBEL DAVID;LLORDES IBA脩EZJAIME;LLORDES ARRATIBEL DAVID;LLORDES USANDIZAGA IGOR;PRIOR MURILLO FELIPE;EGUILEOR RAMIREZMARCIAL;IBARGUREN MARTINEZ PELLO;SOTO DEL RIO SILVIA;MARQUES MARTINEZ GUSTAVO;LLORDES ALONSOANA;ZALO脩A ANDUEZA AITOR. Apo.Sol.: DIAZ GARMENDIA SANDRA;CORRAL ANSA AITZIBER. Escisi贸n total. Sociedadesbeneficiarias de la escisi贸n: SALVA INDUSTRIAL,,,SL. INSALHOL 2018 SL. PATRIN 2018 SL. Disoluci贸n. Escision. Extinci贸n.Datos registrales. T 1919 , F 204, S 8, H SS 1869, I/A 108 (24.12.18).
11 de Septiembre de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: DIAZ GARMENDIA SANDRA;CORRAL ANSA AITZIBER. Datos registrales. T 1919 , F 178, S 8, H SS1869, I/A 105 ( 3.09.18).
Otros conceptos: MODIFICACION DEL ARTICULO 12潞 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, en cuanto al lugar de celebraci贸n de lasJuntas Generales, que en adelante ser谩 en el t茅rmino municipal de LEZO. Datos registrales. T 1919 , F 179, S 8, H SS 1869, I/A 106( 3.09.18).
Nombramientos. Apoderado: ZALO脩A ANDUEZA AITOR. Datos registrales. T 1919 , F 179, S 8, H SS 1869, I/A 107 ( 3.09.18).
09 de Agosto de 2018Nombramientos. Apoderado: LLORDES ALONSO ANA. Datos registrales. T 1919 , F 178, S 8, H SS 1869, I/A 103 (30.07.18).
Revocaciones. Apoderado: IRAETA MU脩OZ PATXI MIKEL. Datos registrales. T 1919 , F 178, S 8, H SS 1869, I/A 104 (30.07.18).
03 de Abril de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: INMASER SA. Nombramientos. Consejero: INSALHOL 2018 SL. Datos registrales. T 1919 , F177, S 8, H SS 1869, I/A 102 (21.03.18).
14 de Diciembre de 2017Nombramientos. Dir. General: LLORDES ARRATIBEL DAVID. Datos registrales. T 1919 , F 176, S 8, H SS 1869, I/A 100 (5.12.17).
Ceses/Dimisiones. Dir. General: BA脩UELOS RODENAS ARTURO. Revocaciones. Apoderado: LLORDES IBA脩EZ JAIME.Apo.Sol.: LLORDES CISTERO JOSE;LLORDES CISTERO LUIS-RAMON. Datos registrales. T 1919 , F 177, S 8, H SS 1869, I/A 101( 5.12.17).
05 de Octubre de 2017Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 1919 , F 176, S 8, H SS 1869, I/A 99 (28.09.17).
05 de Septiembre de 2017Ceses/Dimisiones. Secretario: TUDURI ESNAL FRANCISCO. Nombramientos. SecreNoConsj: BARAHONA FERNANDEZMAIDER. L. Asesor: BARAHONA FERNANDEZ MAIDER. Reelecciones. Consejero: LLORDES IBA脩EZ JAIME. Presidente:LLORDES IBA脩EZ JAIME. Consejero: LLORDES ARRATIBEL DAVID. Datos registrales. T 1919 , F 175, S 8, H SS 1869, I/A 98(18.08.17).
14 de Octubre de 2016Nombramientos. Apoderado: MARQUES MARTINEZ GUSTAVO. Datos registrales. T 1919 , F 175, S 8, H SS 1869, I/A 97(29.09.16).
30 de Agosto de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: TIMESHEETS SL. Nombramientos. Consejero: LASCURAIN AGUIRRESAROBEGUSTAVO;LLORDES ALONSO ANA;LLORDES USANDIZAGA IGOR. Datos registrales. T 1919 , F 174, S 8, H SS 1869, I/A 96(22.08.16).
07 de Octubre de 2015Reelecciones. Consejero: INMASER SA. Datos registrales. T 1919 , F 174, S 8, H SS 1869, I/A 95 (30.09.15).
04 de Agosto de 2015Otros conceptos: Nueva redacci贸n de Estatutos Sociales, para su adaptaci贸n a la Ley 13/2014, de 3 de diciembre.- Cambio dedomicilio social. POLIG 107, CTRA. GI-636, KM 6. (LEZO). P谩gina web de la sociedad. Creaci贸n de la p谩gina web corporativa:www.salva.es. Datos registrales. T 1919 , F 172, S 8, H SS 1869, I/A 94 (23.07.15).
07 de Octubre de 2014Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 1919 , F 172, S 8, H SS 1869, I/A 93 (23.09.14).
13 de Agosto de 2013Ceses/Dimisiones. Presidente: LLORDES IBA脩EZ JAIME. Consejero: LLORDES IBA脩EZ JAIME;LLORDES ARRATIBEL DAVID.Nombramientos. Consejero: LLORDES IBA脩EZ JAIME. Presidente: LLORDES IBA脩EZ JAIME. Consejero: LLORDES ARRATIBELDAVID. Datos registrales. T 1919 , F 172, S 8, H SS 1869, I/A 92 ( 5.08.13).
29 de Octubre de 2012Otros conceptos: Modif. art. 12潞 de los Estatutos, relativo a la celebraci贸nde las Junta Generales.- Datos registrales. T 1919 , F172, S 8, H SS 1869, I/A 91 (18.10.12).
29 de Agosto de 2012Reelecciones. Consejero: TIMESHEETS SL. Datos registrales. T 1919 , F 171, S 8, H SS 1869, I/A 90 (21.08.12).
16 de Agosto de 2011Reelecciones. Consejero: INMASER SA. Datos registrales. T 1919 , F 171, S 8, H SS 1869, I/A 88 ( 4.08.11).
Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 1919 , F 171, S 8, H SS 1869, I/A 89 (4.08.11).
18 de Septiembre de 2009Reelecciones. Consejero: LLORDES ARRATIBEL DAVID;LLORDES IBA脩EZ JAIME. Presidente: LLORDES IBA脩EZ JAIME. Datosregistrales. T 1919 , F 171, S 8, H SS 1869, I/A 87 ( 9.09.09).
18 de Marzo de 2009Revocaciones. Apoderado: LLORDES CREUS JUAN;LLORDES IBA脩EZ JAIME;LLORDES IBA脩EZ JAIME;LLORDES IBA脩EZJAIME;LLORDES IBA脩EZ JAIME. Datos registrales. T 1919 , F 170, S 8, H SS 1869, I/A 86 ( 9.03.09).